THE INSTITUTE FOR COLLABORATIVE WORKING
Vue d'ensemble
| Nom de la société | THE INSTITUTE FOR COLLABORATIVE WORKING |
|---|---|
| Statut de la société | Active |
| Forme juridique | Société privée à responsabilité limitée par garantie sans capital social, exemption d'utilisation de 'Limited' |
| Numéro de société | 02549634 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe THE INSTITUTE FOR COLLABORATIVE WORKING ?
| Adresse du siège social | 83 Victoria Street SW1H 0HW London England |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de THE INSTITUTE FOR COLLABORATIVE WORKING ?
| En retard | Non |
|---|---|
| Prochains comptes | |
| Fin de la prochaine période comptable le | 31 mars 2026 |
| Date d'échéance des prochains comptes | 31 déc. 2026 |
| Derniers comptes | |
| Derniers comptes arrêtés au | 31 mars 2025 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour THE INSTITUTE FOR COLLABORATIVE WORKING ?
| Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 18 oct. 2026 |
|---|---|
| Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 01 nov. 2026 |
| Dernière déclaration de confirmation | |
| Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 18 oct. 2025 |
| En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour THE INSTITUTE FOR COLLABORATIVE WORKING ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Déclaration de confirmation établie le 18 oct. 2025 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2025 | 13 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Professor Jane Lynch en tant qu'administrateur le 01 janv. 2025 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Lord John Hannett en tant qu'administrateur le 01 janv. 2025 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de David Charles Evans en tant que directeur le 01 janv. 2025 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Douglas Alexander Drysdale Mccormick en tant que directeur le 10 juil. 2025 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Central Point 45 Beech Street London EC2Y 8AD England à 83 Victoria Street London SW1H 0HW le 06 juin 2025 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 18 oct. 2024 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2024 | 13 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de Alan Maund en tant que directeur le 04 janv. 2024 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2023 | 13 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 18 oct. 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Nomination de Ms Claire Margaret Ward en tant qu'administrateur le 01 janv. 2023 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Evergreen House North Grafton Place London NW1 2DX England à Central Point 45 Beech Street London EC2Y 8AD le 16 nov. 2023 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de David Earnest Hawkins en tant que directeur le 01 janv. 2023 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Claire Margaret Ward en tant que directeur le 01 janv. 2023 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Frank Lee en tant qu'administrateur le 01 janv. 2023 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mr Alan Maund en tant qu'administrateur le 01 janv. 2023 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Statuts | 14 pages | MA | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2022 | 12 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 18 oct. 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2021 | 13 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 18 oct. 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Lord David Charles Evans le 01 déc. 2020 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de THE INSTITUTE FOR COLLABORATIVE WORKING ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABRAHAMS, Stephen Paul | Administrateur | Victoria Street SW1H 0HW London 83 England | England | British | 270513520001 | |||||
| BULLOCK, Timothy John | Administrateur | 4000 Parkway Whiteley PO15 7FL Fareham Nats Limited England | United Kingdom | British | 140799250001 | |||||
| HANNETT, John | Administrateur | Victoria Street SW1H 0HW London 83 England | England | British | 338285810001 | |||||
| KEHOE, Christopher James Peter | Administrateur | Victoria Street SW1H 0HW London 83 England | England | British | 220701910001 | |||||
| LEE, Frank | Administrateur | Victoria Street SW1H 0HW London 83 England | England | British | 315845660001 | |||||
| LYNCH, Jane, Professor | Administrateur | Victoria Street SW1H 0HW London 83 England | United Kingdom | British | 338286040001 | |||||
| WARD, Claire Margaret | Administrateur | Victoria Street SW1H 0HW London 83 England | England | British | 161506330002 | |||||
| CHERRETT, Kenneth William George | Secrétaire | 6 Hurst Lodge Gower Road KT13 0EF Weybridge Surrey | British | 7275770001 | ||||||
| PYLE, Leslie James | Secrétaire | Kerry Cottage St Johns Street Duxford CB2 4RA Cambridge | British | 37936720001 | ||||||
| WILKINS, Michael Christopher | Secrétaire | 112 Shenfield Place Shenfield CM15 9AG Brentwood Essex | British | 83464080001 | ||||||
| BERKELEY, Anthony, Lord | Administrateur | 166 Banbury Road OX2 7BT Oxford Oxfordshire | England | British | 61019950001 | |||||
| BULLARD, Gary Bruce | Administrateur | Old Palace Place The Green TW9 1NQ Richmond Surrey | United Kingdom | British | 148752360001 | |||||
| CHERRETT, Kenneth William George | Administrateur | 6 Hurst Lodge Gower Road KT13 0EF Weybridge Surrey | British | 7275770001 | ||||||
| DALY, Alexander | Administrateur | Condover Court Condover SY5 7AA Shrewsbury Salop | United Kingdom | British | 6442950001 | |||||
| DIXON, Ian Leonard, Sir | Administrateur | Wain Wood Edge Hitchin Road Preston SG4 7TZ Hitchin Hertfordshire | British | 41086850001 | ||||||
| EVANS, David Charles, Lord | Administrateur | Connaught Street W2 2BB London 59a England | England | British | 256319180001 | |||||
| HAWKINS, David Earnest | Administrateur | 21 Lancot Avenue LU6 2AW Dunstable | England | British | 78634740001 | |||||
| HORNBY, Derek Peter, Sir | Administrateur | Badgers Farm Idlicote CV36 5DT Shipston On Stour Warwickshire | England | British | 1821270001 | |||||
| HUNT, Maurice William | Administrateur | 24 Fairford Close RH16 3EF Haywards Heath West Sussex | British | 57197230002 | ||||||
| IRWIN, John Neill | Administrateur | Southern Cross Sandhills Road TQ8 8JP Salcombe Devon | British | 33814880002 | ||||||
| JACKSON, Alan Kenneth | Administrateur | 24 Spenser Avenue NR28 9HZ North Walsham Norfolk | United Kingdom | British | 33652920001 | |||||
| LATHAM, Michael Anthony, Sir | Administrateur | Rosary Farm 10 Arnhill Road NN17 3DN Gretton Northants | England | British | 50879560001 | |||||
| LUCKHURST, Marion Ruth | Administrateur | Courtleigh 5 Cox Tor Close PL20 6BH Yelverton Devon | England | British | 69714140001 | |||||
| MARRIOTT-SIMS, Dawn | Administrateur | 21 Bloomsbury Square WC1A 2NS London Suite 2 England | United Kingdom | British | 161040510002 | |||||
| MASON, Clive Roger | Administrateur | Cob Cottage 27 Mill Street CV34 4HB Warwick Warwickshire | United Kingdom | British | 52659450002 | |||||
| MAUND, Alan | Administrateur | 45 Beech Street EC2Y 8AD London Central Point England | England | British | 315845490001 | |||||
| MCCLELLAND, Margaret | Administrateur | Tudor Cottage Braintree Road CM6 3DS Felsted Essex | British | 126260810001 | ||||||
| MCCORMICK, Douglas Alexander Drysdale | Administrateur | Victoria Street SW1H 0HW London 83 England | United Kingdom | British | 183399510002 | |||||
| MCINTOSH, Andrew Robert, Lord Mcintosh Of Haringey | Administrateur | 27 Hurst Avenue N6 5TX London | British | 3192480001 | ||||||
| NIXON, Edwin Ronald, Sir | Administrateur | Starkes Heath Rogate GU31 5EJ Petersfield Hants | British | 8627560001 | ||||||
| ODAM, Christopher John | Administrateur | Sewell Road LN2 5RY Lincoln 9 Lincolnshire | United Kingdom | British | 147521200002 | |||||
| PYLE, Leslie James | Administrateur | St Johns Street Duxford CB22 4RA Cambridge Kerry Cottage United Kingdom | United Kingdom | British | 37936720001 | |||||
| RADCLIFFE, Mark Hugh Joseph | Administrateur | The Malt House Upton, Nr Andover SP11 0JS Andover Hampshire | British | 33402910003 | ||||||
| RITCHIE, Alison Jane | Administrateur | 41 Burrard Road NW6 1DA London | United Kingdom | British | 88178900001 | |||||
| SCOTT, Andrew Peter | Administrateur | The Firs Broadwater Forest TN3 9JP Tunbridge Wells Kent | United Kingdom | British | 57945470001 |
Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour THE INSTITUTE FOR COLLABORATIVE WORKING ?
| Notifié le | Cessé le | Déclaration |
|---|---|---|
| 18 oct. 2016 | La société sait ou a des raisons de croire qu'aucune personne enregistrable ou entité juridique pertinente enregistrable n'est liée à la société. |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0