GREYCROFT HOLDINGS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéGREYCROFT HOLDINGS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02550593
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de GREYCROFT HOLDINGS LIMITED ?

    • Achat et vente de biens immobiliers propres (68100) / Activités immobilières

    Où se situe GREYCROFT HOLDINGS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    68 Grafton Way 68 Grafton Way
    W1T 5DS London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de GREYCROFT HOLDINGS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2015

    Quels sont les derniers dépôts pour GREYCROFT HOLDINGS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2015

    12 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 22 oct. 2015 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital04 janv. 2016

    État du capital au 04 janv. 2016

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Changement d'adresse du siège social de 4th Floor Centre Heights 137 Finchley Road London NW3 6JG à 68 Grafton Way 68 Grafton Way London W1T 5DS le 22 déc. 2015

    1 pagesAD01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 sept. 2014

    4 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 22 oct. 2014 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital05 nov. 2014

    État du capital au 05 nov. 2014

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Comptes d'exonération totale établis au 30 sept. 2013

    15 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 22 oct. 2013 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital07 nov. 2013

    État du capital au 07 nov. 2013

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Nomination de Mr Malcolm William Froom Hezel en tant que secrétaire

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Kathleen Bainbridge en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Comptes d'exonération totale établis au 01 oct. 2012

    10 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 22 oct. 2012 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2011

    13 pagesAA

    legacy

    3 pagesMG02

    Déclaration annuelle jusqu'au 22 oct. 2011 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    legacy

    3 pagesMG02

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2010

    12 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 22 oct. 2010 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2009

    12 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 22 oct. 2009 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de Hamstead Park Hamstead Marshall Newbury Berks RG20 0HE

    1 pagesAD02

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré

    1 pagesAD03

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée

    1 pagesAD02

    Qui sont les dirigeants de GREYCROFT HOLDINGS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    HEZEL, Malcolm William Froom
    Hamstead Marshall
    RG20 0HE Newbury
    Hamstead Park
    Berks
    England
    Secrétaire
    Hamstead Marshall
    RG20 0HE Newbury
    Hamstead Park
    Berks
    England
    182713390001
    GWYN JONES, Timothy
    Hamstead Park
    Hamstead Marshall
    RG20 0HE Newbury
    Berkshire
    Administrateur
    Hamstead Park
    Hamstead Marshall
    RG20 0HE Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritishCompany Director48297190002
    MORRIS, Nicholas Charles
    1 Montpelier Street
    SW7 1EX London
    Administrateur
    1 Montpelier Street
    SW7 1EX London
    EnglandBritishSolicitor72509780002
    BAINBRIDGE, Kathleen
    Hamstead Park
    Hamstead Marshall
    RG20 0HE Newbury
    Berkshire
    Secrétaire
    Hamstead Park
    Hamstead Marshall
    RG20 0HE Newbury
    Berkshire
    British60082100001
    HARRISON, Dorothy Iris
    9 Ardilaun Road
    N5 2QR London
    Secrétaire
    9 Ardilaun Road
    N5 2QR London
    British1808630001
    TURNER, Barry William
    3 Bolebec House
    10 Lowndes Street
    SW1X 9EU London
    Administrateur
    3 Bolebec House
    10 Lowndes Street
    SW1X 9EU London
    New ZealandDirector1808640002

    GREYCROFT HOLDINGS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Mortgage deed
    Créé le 15 déc. 2003
    Livré le 30 déc. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The f/h property k/a or being 214 fulham road london SW10 t/no BGL28. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 30 déc. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 mai 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Mortgage deed
    Créé le 15 déc. 2003
    Livré le 30 déc. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The l/h property k/a or being land and buildings on the west side of froxmer street gorton manchester t/no LA234081. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 30 déc. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 avr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Deed of rental assignment
    Créé le 02 avr. 1998
    Livré le 10 avr. 1998
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All rights title benefit and interest in the rents licence fees or other sums recoverable in respect of the properties described on the reverse of form 395 please see form for full details. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bristol and West PLC
    Transactions
    • 10 avr. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    Commercial mortgage
    Créé le 02 avr. 1998
    Livré le 10 avr. 1998
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    214 fulham road kensington & chelsea BGL28,land on the west side of froxmer street city of manchester LA234081 land to the north east of broad street welshpool montgomeryshire powys WA527915 and other properties. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Bristol & West PLC
    Transactions
    • 10 avr. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 02 avr. 1998
    Livré le 10 avr. 1998
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bristol & West PLC
    Transactions
    • 10 avr. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 03 août 1993
    Livré le 05 août 1993
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    26 hanson street, city of westminster t/no: ln 241907 214 fulham road, r/b of kensington & chelsea t/no: bgl 28 by way of assignment the goodwill of the business. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 05 août 1993Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 28 juil. 1992
    Livré le 04 août 1992
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Bristol and West Building Society
    Transactions
    • 04 août 1992Enregistrement d'une charge (395)
    Commercial mortgage deed
    Créé le 28 juil. 1992
    Livré le 04 août 1992
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    By way of legalmortgage all estates rights title and other interests of the borrower in the property k/a 26 hanson street, london W1 title no. LN241907 together with all buildings structures and fixtures including trade fixtures and fixed plant and machinery from time to time thereon fixed charge over all moveable plant machinery implements utensils stock furniture and equipment etc floating charge over all other the undertaking and assets whatsoever and wheresoever both present and future.
    Personnes ayant droit
    • Bristol and West Building Society
    Transactions
    • 04 août 1992Enregistrement d'une charge (395)
    Commercial mortgage deed
    Créé le 19 févr. 1992
    Livré le 25 févr. 1992
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee the offer letter and/or the charge
    Brèves mentions
    All estates rights title and other interests of the company in the f/h property k/a 214 fulham road, l/b of kensington and chelsea title no. 322385 together with all buildings and fixtures(see form 395 for full property and other details).
    Personnes ayant droit
    • Bristol and West Building Society
    Transactions
    • 25 févr. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 19 févr. 1992
    Livré le 25 févr. 1992
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee the offer letter and/or the charge
    Brèves mentions
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Bristol and West Building Society
    Transactions
    • 25 févr. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 19 févr. 1992
    Livré le 25 févr. 1992
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H land on the west side of froxmer street, manchester title no. LA234081. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Greycroft Limited
    Transactions
    • 25 févr. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 19 févr. 1992
    Livré le 25 févr. 1992
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land lying to the north east of broad street, welshpool, powys title no. WA527915. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Greycroft Limited
    Transactions
    • 25 févr. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 19 févr. 1992
    Livré le 25 févr. 1992
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H unit 22 walworth industrial estate, walworth, hampshire title no. HB423085. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Greycroft Limited
    Transactions
    • 25 févr. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 19 févr. 1992
    Livré le 25 févr. 1992
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H land and buildings on the south side of swan lane, k/a swan village industrial estate, sandwell, west midlands title no. SF83350. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Greycroft Limited
    Transactions
    • 25 févr. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 19 févr. 1992
    Livré le 25 févr. 1992
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property at 214 fulham road, london SW10 in the royal borough of kensington & chelsea title no. 322385. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Greycroft Management Co. Limited
    Transactions
    • 25 févr. 1992Enregistrement d'une charge (395)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0