FREETRADERS GROUP LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéFREETRADERS GROUP LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02550656
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de FREETRADERS GROUP LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe FREETRADERS GROUP LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Thomas Hardy House
    2 Heath Road
    KT13 8TB Weybridge
    Surrey
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de FREETRADERS GROUP LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    FREE TRADERS GROUP LIMITED17 janv. 199117 janv. 1991
    OVAL (667) LIMITED22 oct. 199022 oct. 1990

    Quels sont les derniers comptes de FREETRADERS GROUP LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 juin 2016

    Quels sont les derniers dépôts pour FREETRADERS GROUP LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration de confirmation établie le 01 déc. 2016 avec mises à jour

    6 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 30 juin 2015

    13 pagesAA

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2016

    4 pagesAA

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2014

    4 pagesAA

    Inscription de la charge 025506560005, créée le 14 oct. 2016

    37 pagesMR01

    Inscription de la charge 025506560004, créée le 14 oct. 2016

    68 pagesMR01

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 déc. 2015 avec liste complète des actionnaires

    9 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital15 sept. 2016

    État du capital au 15 sept. 2016

    • Capital: GBP 5.04802
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Anthony Graham Wood le 02 oct. 2015

    4 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Jeremy Alexander Stevenson le 02 oct. 2015

    4 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Paul Michael Schaafsma le 02 oct. 2015

    4 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Robert John Ratcliffe le 02 oct. 2015

    4 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Steven Lee Gorst le 02 oct. 2015

    4 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Mr Jeremy Alexander Stevenson le 02 oct. 2015

    3 pagesCH03

    Modification des coordonnées du secrétaire Mrs Nicola Jane Spencer le 02 oct. 2015

    3 pagesCH03

    Changement d'adresse du siège social de Accolade House the Guildway Old Portsmouth Road Guildford Surrey GU3 1LR à Thomas Hardy House 2 Heath Road Weybridge Surrey KT13 8TB le 04 août 2016

    2 pagesAD01

    Restauration par ordonnance du tribunal

    3 pagesAC92

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    4 pagesDS01

    legacy

    2 pagesSH20

    État du capital au 19 déc. 2014

    • Capital: GBP 1,452,058.537965
    6 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Qui sont les dirigeants de FREETRADERS GROUP LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    SPENCER, Nicola Jane
    2 Heath Road
    KT13 8TB Weybridge
    Thomas Hardy House
    Surrey
    Secrétaire
    2 Heath Road
    KT13 8TB Weybridge
    Thomas Hardy House
    Surrey
    180938920001
    STEVENSON, Jeremy Alexander
    2 Heath Road
    KT13 8TB Weybridge
    Thomas Hardy House
    Surrey
    Secrétaire
    2 Heath Road
    KT13 8TB Weybridge
    Thomas Hardy House
    Surrey
    161855160001
    GORST, Steven Lee
    2 Heath Road
    KT13 8TB Weybridge
    Thomas Hardy House
    Surrey
    Administrateur
    2 Heath Road
    KT13 8TB Weybridge
    Thomas Hardy House
    Surrey
    CanadaCanadianCompany Director180938750002
    RATCLIFFE, Robert John
    2 Heath Road
    KT13 8TB Weybridge
    Thomas Hardy House
    Surrey
    Administrateur
    2 Heath Road
    KT13 8TB Weybridge
    Thomas Hardy House
    Surrey
    United KingdomBritishManagement Consultant185752460001
    SCHAAFSMA, Paul Michael
    2 Heath Road
    KT13 8TB Weybridge
    Thomas Hardy House
    Surrey
    Administrateur
    2 Heath Road
    KT13 8TB Weybridge
    Thomas Hardy House
    Surrey
    United KingdomBritishCompany Director105189170004
    STEVENSON, Jeremy Alexander
    2 Heath Road
    KT13 8TB Weybridge
    Thomas Hardy House
    Surrey
    Administrateur
    2 Heath Road
    KT13 8TB Weybridge
    Thomas Hardy House
    Surrey
    AustraliaAustralianSolicitor161846280001
    WOOD, Anthony Graham
    2 Heath Road
    KT13 8TB Weybridge
    Thomas Hardy House
    Surrey
    Administrateur
    2 Heath Road
    KT13 8TB Weybridge
    Thomas Hardy House
    Surrey
    AustraliaAustralianFinancial Controller185752470001
    CLOTHIER, Esther
    The Guildway
    Old Portsmouth Road
    GU3 1LR Guildford
    Accolade House
    Surrey
    United Kingdom
    Secrétaire
    The Guildway
    Old Portsmouth Road
    GU3 1LR Guildford
    Accolade House
    Surrey
    United Kingdom
    162189890001
    COLQUHOUN, Anne Therese
    Apartment B Kings Ride House
    Prince Albert Drive
    SL5 8AQ Ascot
    Secrétaire
    Apartment B Kings Ride House
    Prince Albert Drive
    SL5 8AQ Ascot
    British28396500005
    GREGORY, David Noel
    15 Orchard Rise
    TW10 5BX Richmond
    Surrey
    Secrétaire
    15 Orchard Rise
    TW10 5BX Richmond
    Surrey
    British14735490001
    HUGHES, David John
    The Guildway
    Old Portsmouth Road
    GU3 1LR Guildford
    Accolade House
    Surrey
    United Kingdom
    Secrétaire
    The Guildway
    Old Portsmouth Road
    GU3 1LR Guildford
    Accolade House
    Surrey
    United Kingdom
    157429190002
    MALHOTRA, Deepak Kumar
    Constellation House The Guildway
    Old Portsmouth Road Artington
    GU3 1LR Guildford
    Surrey
    Secrétaire
    Constellation House The Guildway
    Old Portsmouth Road Artington
    GU3 1LR Guildford
    Surrey
    BritishSolicitor69554640002
    AIKENS, Peter
    Princes Lodge
    BA4 5HN Shepton Mallet
    Somerset
    Administrateur
    Princes Lodge
    BA4 5HN Shepton Mallet
    Somerset
    BritishDirector2228040002
    BONES, David Christopher
    6 Trowle Common
    BA14 9BJ Trowbridge
    Wiltshire
    Administrateur
    6 Trowle Common
    BA14 9BJ Trowbridge
    Wiltshire
    EnglandBritishDirector60302270001
    BROCKETT, Gavin Stuart
    The Guildway
    Old Portsmouth Road
    GU3 1LR Guildford
    Accolade House
    Surrey
    United Kingdom
    Administrateur
    The Guildway
    Old Portsmouth Road
    GU3 1LR Guildford
    Accolade House
    Surrey
    United Kingdom
    AustraliaSouth AfricanAccountant167554030002
    CARSON, Christopher
    White Gates
    11 Oxshott Way
    KT11 2RU Cobham
    Surrey
    Administrateur
    White Gates
    11 Oxshott Way
    KT11 2RU Cobham
    Surrey
    BritishCompany Director26602290003
    CHRISTENSEN, Troy
    The Guildway
    Old Portsmouth Road
    GU3 1LR Guildford
    Accolade House
    Surrey
    United Kingdom
    Administrateur
    The Guildway
    Old Portsmouth Road
    GU3 1LR Guildford
    Accolade House
    Surrey
    United Kingdom
    AustraliaAmericanCompany Director130789730003
    CLARK, John Webb
    Orchard Priors
    Battledown Close
    GL52 6RD Cheltenham
    Gloucestershire
    Administrateur
    Orchard Priors
    Battledown Close
    GL52 6RD Cheltenham
    Gloucestershire
    BritishChartered Accountant5691050001
    COLQUHOUN, Anne Therese
    Apartment B Kings Ride House
    Prince Albert Drive
    SL5 8AQ Ascot
    Administrateur
    Apartment B Kings Ride House
    Prince Albert Drive
    SL5 8AQ Ascot
    United KingdomBritishCompany Secretary28396500005
    CRANE, Charles Michael
    41 Queens Gardens
    W2 3AA London
    Administrateur
    41 Queens Gardens
    W2 3AA London
    BritishCompany Director14735480001
    CREIGHTON, Thomas Hugh
    Apple Acre
    High Road
    CR5 3QR Chipstead
    Surrey
    Administrateur
    Apple Acre
    High Road
    CR5 3QR Chipstead
    Surrey
    EnglandBritishAccountant157727790001
    DICK, Thomas Gordon
    Yew House Giffards Meadow
    GU9 8DA Farnham
    Surrey
    Administrateur
    Yew House Giffards Meadow
    GU9 8DA Farnham
    Surrey
    BritishCompany Director46246620001
    ETHERIDGE, Hugh Charles
    5 Springfield Place
    BA1 5RA Bath
    Avon
    Administrateur
    5 Springfield Place
    BA1 5RA Bath
    Avon
    United KingdomBritishDirector1491130002
    FISHER, David Michael
    Ashley Wood
    Kingsdown
    SN14 9BH Corsham
    Wiltshire
    Administrateur
    Ashley Wood
    Kingsdown
    SN14 9BH Corsham
    Wiltshire
    BritishDirector76571110001
    GLENNIE, Helen Margaret
    Constellation House The Guildway
    Old Portsmouth Road Artington
    GU3 1LR Guildford
    Surrey
    Administrateur
    Constellation House The Guildway
    Old Portsmouth Road Artington
    GU3 1LR Guildford
    Surrey
    United KingdomBritishCompany Director137615160001
    GREGORY, David Noel
    15 Orchard Rise
    TW10 5BX Richmond
    Surrey
    Administrateur
    15 Orchard Rise
    TW10 5BX Richmond
    Surrey
    EnglandBritishDirector14735490001
    HODGES, Nigel Ian
    Sonning House
    2 Canns Lane
    TA6 6QF North Petherton
    Somerset
    Administrateur
    Sonning House
    2 Canns Lane
    TA6 6QF North Petherton
    Somerset
    BritishBusiness Development Executive75692570001
    HOYLE, Russell Blackburn
    77 Richmond Park Road
    East Sheen
    SW14 8JY London
    Administrateur
    77 Richmond Park Road
    East Sheen
    SW14 8JY London
    BritishDirector52822380001
    HUGHES, David John
    The Guildway
    Old Portsmouth Road
    GU3 1LR Guildford
    Accolade House
    Surrey
    United Kingdom
    Administrateur
    The Guildway
    Old Portsmouth Road
    GU3 1LR Guildford
    Accolade House
    Surrey
    United Kingdom
    AustraliaAustralianAccountant157415150002
    HUNTLEY, Peter William
    28 Allan Glen Gardens
    Bishopbriggs
    G64 3BG Glasgow
    Administrateur
    28 Allan Glen Gardens
    Bishopbriggs
    G64 3BG Glasgow
    ScotlandBritishDirector46387640002
    KLEIN, David
    45 Princes Road
    The Alberts
    TW10 6DQ Richmond
    Surrey
    Administrateur
    45 Princes Road
    The Alberts
    TW10 6DQ Richmond
    Surrey
    AmericanCompany Directors119928070001
    LARGE, Peter Francis William
    Heath Lodge Heath Road
    LU7 8AU Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    Administrateur
    Heath Lodge Heath Road
    LU7 8AU Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    BritishBanker66271370001
    LOUSADA, James David
    The Guildway
    Old Portsmouth Road
    GU3 1LR Guildford
    Accolade House
    Surrey
    United Kingdom
    Administrateur
    The Guildway
    Old Portsmouth Road
    GU3 1LR Guildford
    Accolade House
    Surrey
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director152222000001
    MALHOTRA, Deepak Kumar
    Constellation House The Guildway
    Old Portsmouth Road Artington
    GU3 1LR Guildford
    Surrey
    Administrateur
    Constellation House The Guildway
    Old Portsmouth Road Artington
    GU3 1LR Guildford
    Surrey
    United KingdomBritishSolicitor69554640002
    MORAMARCO, Jon
    C8 Trinity Gate
    Epsom Road
    GU1 3PW Guildford
    Surrey
    Administrateur
    C8 Trinity Gate
    Epsom Road
    GU1 3PW Guildford
    Surrey
    AmericanCompany Director114902210001

    Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour FREETRADERS GROUP LIMITED ?

    Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
    Notifié leCessé leDéclaration
    01 déc. 2016La société sait ou a des raisons de croire qu'aucune personne enregistrable ou entité juridique pertinente enregistrable n'est liée à la société.

    FREETRADERS GROUP LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 14 oct. 2016
    Livré le 31 oct. 2016
    En cours
    Brève description
    Country - community trade mark, mark - babycham [word], application no - 5406021, date filed - 20.10.2006, registration no - 5406021. for details of further intellectual property please refer to schedule 4 of the original transaction security.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Invoice Finance (UK) Limited (as New UK Security Trustee)
    Transactions
    • 31 oct. 2016Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 14 oct. 2016
    Livré le 21 oct. 2016
    En cours
    Brève description
    Country - community trade mark, mark - babycham [word], application no - 5406021, date filed - 20.10.2006, registration no - 5406021. for details of further intellectual property please refer to schedule 4 of the deed.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Invoice Finance (UK) Limited (as UK Security Trustee)
    Transactions
    • 21 oct. 2016Enregistrement d'une charge (MR01)
    Debenture
    Créé le 18 oct. 2011
    Livré le 25 oct. 2011
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee and other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, fixtures, plant & equipment. See image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Ge Commercial Distribution Finance Europe Limited (As UK Security Trustee)
    Transactions
    • 25 oct. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    Debenture
    Créé le 31 déc. 1990
    Livré le 08 janv. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the oval (668) limited to the chargee. In accordance with a loan facility agreement and in relation to the debenture
    Brèves mentions
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • J a Devenish PLC
    Transactions
    • 08 janv. 1991Enregistrement d'une charge
    • 02 févr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Fixed and floating charge
    Créé le 31 déc. 1990
    Livré le 08 janv. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever in accordance with the finance agreements. (As therein defined).
    Brèves mentions
    (See form 395 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Swiss Bank Corporation.
    Transactions
    • 08 janv. 1991Enregistrement d'une charge
    • 06 sept. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0