CARLYLE LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCARLYLE LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02555206
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CARLYLE LIMITED ?

    • Exploitation d'entrepôts et de terminaux de stockage pour le transport terrestre (52103) / Transports et stockage

    Où se situe CARLYLE LIMITED ?

    Adresse du siège social
    KROLL ADVISORY LTD
    4b Cornerblock 2 Cornwall Street
    B3 2DX Birmingham
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de CARLYLE LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    CARLYLE BUS & COACH LIMITED13 mai 199913 mai 1999
    CARLYLE PARTS AND SERVICE LIMITED13 déc. 199413 déc. 1994
    CARLYLE PARTS LIMITED05 nov. 199005 nov. 1990

    Quels sont les derniers comptes de CARLYLE LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2020

    Quels sont les derniers dépôts pour CARLYLE LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Avis de transition de l'administration à la dissolution

    37 pagesAM23

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    34 pagesAM10

    Déclaration des affaires avec le formulaire AM02SOA

    15 pagesAM02

    Avis d'approbation réputée des propositions

    3 pagesAM06

    Déclaration de la proposition de l'administrateur

    51 pagesAM03

    Changement d'adresse du siège social de Carlyle Business Park Ham Lane Kingswinford West Midlands DY6 7JL United Kingdom à 4B Cornerblock 2 Cornwall Street Birmingham B3 2DX le 27 oct. 2022

    2 pagesAD01

    Nomination d'un administrateur

    3 pagesAM01

    Modification des coordonnées du secrétaire Mrs Susan Denise Moon le 02 août 2022

    1 pagesCH03

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Laurie Paul Moon le 02 août 2022

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Steven John Speak le 02 août 2022

    2 pagesCH01

    Changement d'adresse du siège social de Carlyle Business Park Great Bridge Street Swan Village West Bromwich West Midlands B70 0XA à Carlyle Business Park Ham Lane Kingswinford West Midlands DY6 7JL le 02 août 2022

    1 pagesAD01

    Inscription de la charge 025552060015, créée le 18 juil. 2022

    30 pagesMR01

    Cessation de la nomination de Monir-Jason Hassanyeh en tant que directeur le 05 avr. 2022

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 22 déc. 2021 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2020

    30 pagesAA

    Satisfaction de la charge 025552060011 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 025552060010 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 025552060012 en totalité

    1 pagesMR04

    Inscription de la charge 025552060014, créée le 04 nov. 2021

    31 pagesMR01

    Inscription de la charge 025552060013, créée le 03 nov. 2021

    39 pagesMR01

    Satisfaction de la charge 5 en totalité

    1 pagesMR04

    Déclaration de confirmation établie le 22 déc. 2020 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Notification de Lpw Group Ltd en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 22 déc. 2020

    2 pagesPSC02

    Cessation de Lpw (Europe) Ltd en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 22 déc. 2020

    1 pagesPSC07

    Qui sont les dirigeants de CARLYLE LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MOON, Susan Denise
    Ham Lane
    DY6 7JL Kingswinford
    Carlyle Business Park
    West Midlands
    United Kingdom
    Secrétaire
    Ham Lane
    DY6 7JL Kingswinford
    Carlyle Business Park
    West Midlands
    United Kingdom
    265559830001
    MOON, Laurie Paul
    Ham Lane
    DY6 7JL Kingswinford
    Carlyle Business Park
    West Midlands
    United Kingdom
    Administrateur
    Ham Lane
    DY6 7JL Kingswinford
    Carlyle Business Park
    West Midlands
    United Kingdom
    United KingdomBritish10813040004
    SPEAK, Steven John
    Ham Lane
    DY6 7JL Kingswinford
    Carlyle Business Park
    West Midlands
    England
    Administrateur
    Ham Lane
    DY6 7JL Kingswinford
    Carlyle Business Park
    West Midlands
    England
    EnglandBritish237411880001
    TURTON, John Randolph
    18 Whitehill Road
    DY11 6JJ Kidderminster
    Worcestershire
    Secrétaire
    18 Whitehill Road
    DY11 6JJ Kidderminster
    Worcestershire
    British12717230001
    BOTTRILL, Neil Evans
    Old Timbers
    Pumphouse Lane Hanbury
    B60 4BX Bromsgrove
    Worcestershire
    Administrateur
    Old Timbers
    Pumphouse Lane Hanbury
    B60 4BX Bromsgrove
    Worcestershire
    United KingdomBritish12645610002
    CROFTS, John Edward
    86 Windy Arbour
    CV8 2BB Kenilworth
    Warwickshire
    Administrateur
    86 Windy Arbour
    CV8 2BB Kenilworth
    Warwickshire
    British33687320001
    DUNN, Stephen Alan
    2 Rodway Close
    WV4 6AX Wolverhampton
    West Midlands
    Administrateur
    2 Rodway Close
    WV4 6AX Wolverhampton
    West Midlands
    IrelandBritish18453030001
    FORTT, Michael John
    17 Meadow Close
    Downend
    BS16 6QS Bristol
    Avon
    Administrateur
    17 Meadow Close
    Downend
    BS16 6QS Bristol
    Avon
    EnglandBritish41158730001
    HASSANYEH, Monir-Jason
    Carlyle Business Park
    Great Bridge Street
    B70 0XA Swan Village West Bromwich
    West Midlands
    Administrateur
    Carlyle Business Park
    Great Bridge Street
    B70 0XA Swan Village West Bromwich
    West Midlands
    United KingdomBritish237416140002
    HOPPER, John Terence
    9 Thackholme
    WR4 0RZ Worcester
    Worcestershire
    Administrateur
    9 Thackholme
    WR4 0RZ Worcester
    Worcestershire
    British58835430002
    MOON, Gary
    Carlyle Business Park
    Great Bridge Street
    B70 0XA Swan Village West Bromwich
    West Midlands
    Administrateur
    Carlyle Business Park
    Great Bridge Street
    B70 0XA Swan Village West Bromwich
    West Midlands
    EnglandBritish12069370005
    PENN, William John Bannister
    35 Stuarts Green
    DY9 0XR Stourbridge
    West Midlands
    Administrateur
    35 Stuarts Green
    DY9 0XR Stourbridge
    West Midlands
    EnglandBritish66966100002
    SMITH, Neil Patrick
    2 Mears Close
    New Oscott
    B23 5YJ Birmingham
    West Midlands
    Administrateur
    2 Mears Close
    New Oscott
    B23 5YJ Birmingham
    West Midlands
    EnglandBritish41159030001
    TURTON, John Randolph
    18 Whitehill Road
    DY11 6JJ Kidderminster
    Worcestershire
    Administrateur
    18 Whitehill Road
    DY11 6JJ Kidderminster
    Worcestershire
    EnglandBritish12717230001
    WAILING, Michael David
    Bridge House
    Fish House Lane
    B60 4JT Stoke Prior
    Worcestershire
    Administrateur
    Bridge House
    Fish House Lane
    B60 4JT Stoke Prior
    Worcestershire
    British25246550003
    WAINE, Christopher Robert
    4 The Bowers
    PR7 3LA Chorley
    Lancashire
    Administrateur
    4 The Bowers
    PR7 3LA Chorley
    Lancashire
    EnglandBritish119803270001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur CARLYLE LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Lpw Group Ltd
    Great Bridge Street
    Swan Village
    B70 0XA West Bromwich
    Carlyle Business Park
    West Midlands
    United Kingdom
    22 déc. 2020
    Great Bridge Street
    Swan Village
    B70 0XA West Bromwich
    Carlyle Business Park
    West Midlands
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueLimited
    Pays d'enregistrementEngland And Wales
    Autorité légaleCompanies Act
    Lieu d'enregistrementEngland & Wales
    Numéro d'enregistrement12903678
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.
    Great Bridge Street
    Swan Village
    B70 0XA West Bromwich
    Carlyle Business Park
    England
    22 août 2019
    Great Bridge Street
    Swan Village
    B70 0XA West Bromwich
    Carlyle Business Park
    England
    Oui
    Forme juridiquePrivate Limited Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement06381094
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.
    Mr John Randolph Turton
    Carlyle Business Park
    Great Bridge Street
    B70 0XA Swan Village West Bromwich
    West Midlands
    05 nov. 2016
    Carlyle Business Park
    Great Bridge Street
    B70 0XA Swan Village West Bromwich
    West Midlands
    Oui
    Nationalité: British
    Pays de résidence: United Kingdom
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des actions de la société.
    Mr Neil Evans Bottrill
    Carlyle Business Park
    Great Bridge Street
    B70 0XA Swan Village West Bromwich
    West Midlands
    05 nov. 2016
    Carlyle Business Park
    Great Bridge Street
    B70 0XA Swan Village West Bromwich
    West Midlands
    Oui
    Nationalité: British
    Pays de résidence: United Kingdom
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des actions de la société.

    CARLYLE LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 18 juil. 2022
    Livré le 19 juil. 2022
    En cours
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Carlyle Investments Limited
    Transactions
    • 19 juil. 2022Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 04 nov. 2021
    Livré le 04 nov. 2021
    En cours
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Carlyle Investments Limited
    Transactions
    • 04 nov. 2021Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 03 nov. 2021
    Livré le 04 nov. 2021
    En cours
    Brève description
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the termsof the aforementionedinstrument creating or evidencing the charge. Details:. Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, bookdebts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • 4SYTE Limited
    Transactions
    • 04 nov. 2021Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 18 oct. 2019
    Livré le 04 nov. 2019
    Totalement satisfaite
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Breal Zeta Cf Limited
    Transactions
    • 04 nov. 2019Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 15 nov. 2021Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 18 oct. 2019
    Livré le 22 oct. 2019
    Totalement satisfaite
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Breal Zeta Cf Limited
    Transactions
    • 22 oct. 2019Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 15 nov. 2021Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 22 août 2019
    Livré le 28 août 2019
    Totalement satisfaite
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Lmn Finance Designated Activity Company
    Transactions
    • 28 août 2019Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 15 nov. 2021Satisfaction d'une charge (MR04)
    Floating charge (all assets)
    Créé le 13 janv. 2011
    Livré le 15 janv. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of floating charge all the undertaking of the company and all assets whatsoever and wheresoever including stock in trade and uncalled capital but excluding any debts and associated rights relating thereto.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Invoice Finance (UK) LTD ("the Security Holder")
    Transactions
    • 15 janv. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 20 janv. 2020Satisfaction d'une charge (MR04)
    Fixed charge on purchased debts which fail to vest
    Créé le 13 janv. 2011
    Livré le 15 janv. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of fixed equitable charge all debts purchased or purported to be purchased by the security holder pursuant to an agreement for the purchase of debts between the security holder and the company (including associated rights relating thereto) which fail to vest effectively or absolutely in the security holder for any reason.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Invoice Finance (UK) Limited
    Transactions
    • 15 janv. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 20 janv. 2020Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal assignment
    Créé le 17 juil. 2007
    Livré le 25 juil. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any credit balance due to the company under condition 13 of the agreement for the purchase of debts and includes any discounting allowances the benefit of the contract and all securities for the contract.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 25 juil. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 janv. 2020Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 16 juil. 2007
    Livré le 24 juil. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 24 juil. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 janv. 2020Satisfaction d'une charge (MR04)
    Rent deposit deed
    Créé le 17 janv. 2006
    Livré le 02 févr. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All the interest in the interest earning deposit account of £8,643.96. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Ubs Global Asset Management (UK) LTD
    Transactions
    • 02 févr. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 oct. 2021Satisfaction d'une charge (MR04)
    Fixed equitable charge
    Créé le 15 nov. 1994
    Livré le 18 nov. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All book and other debts and/or other forms of obligations hte subject of a factoring agreement. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Griffin Factors Limited
    Transactions
    • 18 nov. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 janv. 2020Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 17 août 1994
    Livré le 22 août 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 22 août 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 mai 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed and floating charge
    Créé le 02 juil. 1992
    Livré le 06 juil. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital patents.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 06 juil. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 sept. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed and floating charge
    Créé le 12 déc. 1990
    Livré le 24 déc. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Westpac Banking Corporation
    Transactions
    • 24 déc. 1990Enregistrement d'une charge
    • 22 juil. 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    CARLYLE LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    20 oct. 2022Administration started
    26 oct. 2023Administration ended
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Steven Muncaster
    Kroll Advisory Ltd The Chancery
    58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    practitioner
    Kroll Advisory Ltd The Chancery
    58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    Matthew Ingram
    4b Cornerblock, 2 Cornwall Street
    B3 2DX Birmingham
    practitioner
    4b Cornerblock, 2 Cornwall Street
    B3 2DX Birmingham

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0