SIMPLY NEWS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSIMPLY NEWS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02555216
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de SIMPLY NEWS LIMITED ?

    • Vente au détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé (47620) / Commerce de gros et de détail ; réparation de véhicules automobiles et de motocycles

    Où se situe SIMPLY NEWS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    322 Manchester Road
    BL3 2QS Bolton
    Greater Manchester
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de SIMPLY NEWS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    ALEEF GARAGES LIMITED05 nov. 199005 nov. 1990

    Quels sont les derniers comptes de SIMPLY NEWS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 oct. 2017

    Quels sont les derniers dépôts pour SIMPLY NEWS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    2 pagesDS01

    État du capital après une attribution d'actions au 10 déc. 2019

    • Capital: GBP 127,032
    3 pagesSH01

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution d'attribution de valeurs mobilières

    RES10
    capital

    Résolution de suppression des droits de préemption

    RES11

    Déclaration de confirmation établie le 06 oct. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Période comptable précédente raccourcie du 29 oct. 2018 au 28 oct. 2018

    1 pagesAA01

    Période comptable précédente raccourcie du 30 oct. 2018 au 29 oct. 2018

    1 pagesAA01

    Satisfaction de la charge 31 en totalité

    1 pagesMR04

    Déclaration de confirmation établie le 06 oct. 2018 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale établis au 30 oct. 2017

    11 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 06 oct. 2017 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Période comptable actuelle prolongée du 30 avr. 2017 au 30 oct. 2017

    1 pagesAA01

    Comptes annuels établis au 30 avr. 2016

    17 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 06 oct. 2016 avec mises à jour

    8 pagesCS01

    Déclaration annuelle jusqu'au 06 oct. 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital14 oct. 2015

    État du capital au 14 oct. 2015

    • Capital: GBP 107,097
    SH01

    Comptes annuels établis au 30 avr. 2015

    18 pagesAA

    Comptes annuels établis au 30 avr. 2014

    19 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 06 oct. 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital12 nov. 2014

    État du capital au 12 nov. 2014

    • Capital: GBP 107,097
    SH01

    Démission de l'auditeur

    1 pagesAUD

    Comptes annuels établis au 30 avr. 2013

    19 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 06 oct. 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital07 nov. 2013

    État du capital au 07 nov. 2013

    • Capital: GBP 107,097
    SH01

    Changement d'adresse du siège social de * Aleef House 322 Manchester Road Bolton Greater Manchester BL3 2QS* le 07 nov. 2013

    1 pagesAD01

    Comptes annuels établis au 30 avr. 2012

    20 pagesAA

    Certificat de changement de nom

    Company name changed aleef garages LIMITED\certificate issued on 21/01/13
    3 pagesCERTNM
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name21 janv. 2013

    Résolution de changement de nom

    RES15
    change-of-name21 janv. 2013

    Changement de nom" par résolution

    NM01

    Qui sont les dirigeants de SIMPLY NEWS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    PATEL, Anis
    Manchester Road
    BL3 2QS Bolton
    322
    Greater Manchester
    England
    Secrétaire
    Manchester Road
    BL3 2QS Bolton
    322
    Greater Manchester
    England
    British125303340001
    PATEL, Abid Iqbal
    Manchester Road
    BL3 2QS Bolton
    322
    Greater Manchester
    England
    Administrateur
    Manchester Road
    BL3 2QS Bolton
    322
    Greater Manchester
    England
    EnglandBritish91714040001
    PATEL, Anis
    Manchester Road
    BL3 2QS Bolton
    322
    Greater Manchester
    England
    Administrateur
    Manchester Road
    BL3 2QS Bolton
    322
    Greater Manchester
    England
    EnglandBritish125303340001
    PATEL, Asif Iqbal
    Manchester Road
    BL3 2QS Bolton
    322
    Greater Manchester
    England
    Administrateur
    Manchester Road
    BL3 2QS Bolton
    322
    Greater Manchester
    England
    EnglandBritish91714090002
    PATEL, Iqbal Ahmed
    90 Headingley Way
    Westcourt Gardens
    BL3 3EQ Bolton
    Lancashire
    Secrétaire
    90 Headingley Way
    Westcourt Gardens
    BL3 3EQ Bolton
    Lancashire
    British21995220001
    PATEL, Mustaq Hussain
    1 Canterbury Grove
    Westcourt Gardens
    BL3 3EF Bolton
    Lancashire
    Secrétaire
    1 Canterbury Grove
    Westcourt Gardens
    BL3 3EF Bolton
    Lancashire
    British35704940001
    PATEL, Ahmed
    86 Headinglyway
    West Coast Garden
    B13 3EQ Bolton
    Greater Manchester
    Administrateur
    86 Headinglyway
    West Coast Garden
    B13 3EQ Bolton
    Greater Manchester
    British45650050001
    PATEL, Amina Ahmed
    86 Headinglyway
    B13 3EQ Bolton
    Greater Manchester
    Administrateur
    86 Headinglyway
    B13 3EQ Bolton
    Greater Manchester
    British45650110001
    PATEL, Iqbal Ahmed
    90 Headingley Way
    Westcourt Gardens
    BL3 3EQ Bolton
    Lancashire
    Administrateur
    90 Headingley Way
    Westcourt Gardens
    BL3 3EQ Bolton
    Lancashire
    EnglandBritish21995220001
    PATEL, Mubarakali Ahmed
    87 Headingley Way
    Westcourt Gardens
    BL3 3EQ Bolton
    Lancashire
    Administrateur
    87 Headingley Way
    Westcourt Gardens
    BL3 3EQ Bolton
    Lancashire
    British21995240001
    PATEL, Mustaq Hussain
    1 Canterbury Grove
    Westcourt Gardens
    BL3 3EF Bolton
    Lancashire
    Administrateur
    1 Canterbury Grove
    Westcourt Gardens
    BL3 3EF Bolton
    Lancashire
    EnglandBritish35704940001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur SIMPLY NEWS LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Mr Abid Patel
    Manchester Road
    BL3 2QS Bolton
    322
    Greater Manchester
    19 sept. 2016
    Manchester Road
    BL3 2QS Bolton
    322
    Greater Manchester
    Non
    Nationalité: British
    Pays de résidence: United Kingdom
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des droits de vote dans la société.
    Mr Anis Patel
    Manchester Road
    BL3 2QS Bolton
    322
    Greater Manchester
    19 sept. 2016
    Manchester Road
    BL3 2QS Bolton
    322
    Greater Manchester
    Non
    Nationalité: British
    Pays de résidence: England
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des droits de vote dans la société.
    Mr Asif Iqbal Patel
    Manchester Road
    BL3 2QS Bolton
    322
    Greater Manchester
    19 sept. 2016
    Manchester Road
    BL3 2QS Bolton
    322
    Greater Manchester
    Non
    Nationalité: British
    Pays de résidence: England
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des droits de vote dans la société.

    SIMPLY NEWS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal charge
    Créé le 25 janv. 2010
    Livré le 27 janv. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Savoy service station 80 blackburn road darwen.
    Personnes ayant droit
    • Shell U.K. Limited
    Transactions
    • 27 janv. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 19 juil. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 25 janv. 2010
    Livré le 27 janv. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Orchard service station 1 buckingham road manchester.
    Personnes ayant droit
    • Shell U.K. Limited
    Transactions
    • 27 janv. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 19 juil. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 04 févr. 2009
    Livré le 10 févr. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 10 févr. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 juil. 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 18 mars 2008
    Livré le 08 avr. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 08 avr. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 févr. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 11 mars 2008
    Livré le 12 mars 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Orchard service station wilbraham road chorlton cum hardy manchester by way of fixed charge, the benefit of all covenants & rights concerning the property & all plant machinery, fixtures, fittings, furniture, equipment, implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 12 mars 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 sept. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 30 avr. 2007
    Livré le 01 mai 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Texaco service station, seedley road, salford. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 01 mai 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 mars 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 30 avr. 2007
    Livré le 01 mai 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Texaco service station, 25 broughton lane, salford. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 01 mai 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 oct. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 30 avr. 2007
    Livré le 01 mai 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Texaco service station, oldfield road, manchester. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 01 mai 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 oct. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 30 avr. 2007
    Livré le 01 mai 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Texaco service station, castle irwell, cromwell road, salford. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 01 mai 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 oct. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of charge
    Créé le 26 avr. 2007
    Livré le 01 mai 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    F/H land and premises at chorlton motoring centre, 423 barlow moor road, manchester.
    Personnes ayant droit
    • Bp Oil UK Limited
    Transactions
    • 01 mai 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 juil. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 26 avr. 2007
    Livré le 28 avr. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    423 barlow moor road, chorlton, manchester. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 28 avr. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 oct. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 30 janv. 2007
    Livré le 01 févr. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Borsdane service station 276 atherton road hindley wigan greater manchester. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 01 févr. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 10 janv. 2007
    Livré le 13 janv. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    322 manchester road bolton greater manchester. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 13 janv. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 06 avr. 2006
    Livré le 08 avr. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Hyde road service station, hyde road, mottram, tameside, greater manchester. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 08 avr. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 oct. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 27 juil. 2005
    Livré le 03 août 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Savoy service station 80 blackburn road darwen lancs, all fixtures and fittings, all rental income, all rights and claims against all lessees sub-lessees licensees or occupiers of the property, goodwill, book debts, floating charge plant machinery and equipment, capital profits, all the undertaking and assets of the company present and future,. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bp Oil UK Limited
    Transactions
    • 03 août 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 janv. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 22 juin 2005
    Livré le 25 juin 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Alexandra park service station park road oldham greater manchester. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 25 juin 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 oct. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 05 avr. 2005
    Livré le 08 avr. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Bp paddock bury new road prestwich manchester t/no GM870578. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 08 avr. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 oct. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 14 déc. 2004
    Livré le 18 déc. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Preston service staton,preston road,chorley lancashire PR7 1PZ. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 18 déc. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 oct. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 14 déc. 2004
    Livré le 18 déc. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Barlow moor service station,302 barlow moor road,chorlton cum hardy,greater manchester. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 18 déc. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 oct. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal mortgage
    Créé le 10 déc. 2004
    Livré le 16 déc. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Property at seedley road service station seedley road pendleton salford t/nos: LA8357 LA218772 & LA218773. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 16 déc. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 mars 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 10 déc. 2004
    Livré le 14 déc. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Broughton lane service station broughton lane salford t/no LA205254. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 14 déc. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 mars 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 10 déc. 2004
    Livré le 14 déc. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Oldfield road service station oldfield road salford t/no LA211565. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 14 déc. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 mars 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 10 déc. 2004
    Livré le 14 déc. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Castle irwell service station cromwell road pendleton salford t/no LA66353. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 14 déc. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 mars 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 05 nov. 2004
    Livré le 13 nov. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Meadow lane filling station, 1041 bury road, bolton, greater manchester. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 13 nov. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 oct. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 26 oct. 2004
    Livré le 30 oct. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Darley service station, albert road, farnworth, bolton, greater manchester. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 30 oct. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 oct. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0