MATRIX (HIGHLANDS) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéMATRIX (HIGHLANDS) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02558700
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de MATRIX (HIGHLANDS) LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe MATRIX (HIGHLANDS) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Gladstone Place
    36-38 Upper Marlborough Road
    AL1 3UU St. Albans
    Hertfordshire
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de MATRIX (HIGHLANDS) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    TRAVELBASIC LIMITED15 nov. 199015 nov. 1990

    Quels sont les derniers comptes de MATRIX (HIGHLANDS) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2019

    Quels sont les derniers dépôts pour MATRIX (HIGHLANDS) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    État du capital au 12 févr. 2021

    • Capital: GBP 1
    3 pagesSH19

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Share premium account cancelled 26/01/2021
    RES13
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Déclaration de confirmation établie le 15 nov. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 31 déc. 2019

    20 pagesAA

    legacy

    79 pagesPARENT_ACC

    legacy

    3 pagesGUARANTEE2

    legacy

    1 pagesAGREEMENT2

    Déclaration de confirmation établie le 15 nov. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 31 déc. 2018

    20 pagesAA

    legacy

    64 pagesPARENT_ACC

    legacy

    3 pagesGUARANTEE2

    legacy

    1 pagesAGREEMENT2

    Modification des détails de Malthurst Petroleum Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 16 juil. 2019

    2 pagesPSC05

    Nomination de Thomas Mckenzie Biggart en tant qu'administrateur le 11 mars 2019

    2 pagesAP01

    Nomination de Pinsent Masons Secretarial Limited en tant que secrétaire le 07 mars 2019

    2 pagesAP04

    Cessation de la nomination de David Hathaway en tant que secrétaire le 07 mars 2019

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Graham Paul Timbers en tant que directeur le 12 févr. 2019

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Simon Paul Lane en tant qu'administrateur le 19 déc. 2018

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr William Bahlsen Bannister en tant qu'administrateur le 19 déc. 2018

    2 pagesAP01

    Changement d'adresse du siège social de Vincent House 4 Grove Lane Epping Essex CM16 4LH à Gladstone Place 36-38 Upper Marlborough Road St. Albans Hertfordshire AL1 3UU le 21 déc. 2018

    1 pagesAD01

    Qui sont les dirigeants de MATRIX (HIGHLANDS) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED
    Park Row
    LS1 5AB Leeds
    1
    England
    Secrétaire
    Park Row
    LS1 5AB Leeds
    1
    England
    Type d'identificationSociété à responsabilité limitée du Royaume-Uni
    Numéro d'enregistrement02318923
    76579530001
    BANNISTER, William Bahlsen
    36-38 Upper Marlborough Road
    AL1 3UU St. Albans
    Gladstone Place
    Hertfordshire
    England
    Administrateur
    36-38 Upper Marlborough Road
    AL1 3UU St. Albans
    Gladstone Place
    Hertfordshire
    England
    United KingdomBritish252731900001
    BIGGART, Thomas Mckenzie
    36-38 Upper Marlborough Road
    AL1 3UU St. Albans
    Gladstone Place
    Hertfordshire
    England
    Administrateur
    36-38 Upper Marlborough Road
    AL1 3UU St. Albans
    Gladstone Place
    Hertfordshire
    England
    ScotlandBritish215843640001
    LANE, Simon Paul
    36-38 Upper Marlborough Road
    AL1 3UU St. Albans
    Gladstone Place
    Hertfordshire
    England
    Administrateur
    36-38 Upper Marlborough Road
    AL1 3UU St. Albans
    Gladstone Place
    Hertfordshire
    England
    EnglandBritish252862090001
    HATHAWAY, David
    36-38 Upper Marlborough Road
    AL1 3UU St. Albans
    Gladstone Place
    Hertfordshire
    England
    Secrétaire
    36-38 Upper Marlborough Road
    AL1 3UU St. Albans
    Gladstone Place
    Hertfordshire
    England
    173702820001
    IQBAL, Damian Shameem
    4 Grove Lane
    CM16 4LH Epping
    Vincent House
    Essex
    England
    Secrétaire
    4 Grove Lane
    CM16 4LH Epping
    Vincent House
    Essex
    England
    173703080001
    KERRIDGE, Nicola Jane
    Melway House
    Child Okeford
    DT11 8EW Blandford Forum
    Dorset
    Secrétaire
    Melway House
    Child Okeford
    DT11 8EW Blandford Forum
    Dorset
    British20367220003
    BACK, Steven John
    4 Grove Lane
    CM16 4LH Epping
    Vincent House
    Essex
    Administrateur
    4 Grove Lane
    CM16 4LH Epping
    Vincent House
    Essex
    United KingdomBritish205661380001
    DICKENS, Karen Juanita, Dr
    4 Grove Lane
    CM16 4LH Epping
    Vincent House
    Essex
    Administrateur
    4 Grove Lane
    CM16 4LH Epping
    Vincent House
    Essex
    United KingdomBritish124061360001
    GRAY, Michael Stuart
    Slackbuie Way
    IV2 6AT Inverness
    16
    Inverness-Shire
    United Kingdom
    Administrateur
    Slackbuie Way
    IV2 6AT Inverness
    16
    Inverness-Shire
    United Kingdom
    United KingdomBritish82067270002
    KERRIDGE, Mark William
    Melway House
    Child Okeford
    DT11 8EW Blandford Forum
    Dorset
    Administrateur
    Melway House
    Child Okeford
    DT11 8EW Blandford Forum
    Dorset
    United KingdomBritish9965070004
    KERRIDGE, Nicola Jane
    Melway House
    Child Okeford
    DT11 8EW Blandford Forum
    Dorset
    Administrateur
    Melway House
    Child Okeford
    DT11 8EW Blandford Forum
    Dorset
    United KingdomBritish20367220003
    KERRIDGE, William Nicholas
    Prowtings
    Chawton
    GU34 1SD Alton
    Hampshire
    Administrateur
    Prowtings
    Chawton
    GU34 1SD Alton
    Hampshire
    United KingdomBritish9299940001
    LYNN, John Charles
    4 Grove Lane
    CM16 4LH Epping
    Vincent House
    Essex
    England
    Administrateur
    4 Grove Lane
    CM16 4LH Epping
    Vincent House
    Essex
    England
    United KingdomBritish29838790004
    PEACOCK, Graham Frederick
    4 Grove Lane
    CM16 4LH Epping
    Vincent House
    Essex
    England
    Administrateur
    4 Grove Lane
    CM16 4LH Epping
    Vincent House
    Essex
    England
    United KingdomBritish5133310002
    SCOTT, Richard Antony Cargill
    4 Grove Lane
    CM16 4LH Epping
    Vincent House
    Essex
    England
    Administrateur
    4 Grove Lane
    CM16 4LH Epping
    Vincent House
    Essex
    England
    EnglandBritish107002130001
    TIMBERS, Graham Paul
    36-38 Upper Marlborough Road
    AL1 3UU St. Albans
    Gladstone Place
    Hertfordshire
    England
    Administrateur
    36-38 Upper Marlborough Road
    AL1 3UU St. Albans
    Gladstone Place
    Hertfordshire
    England
    EnglandBritish127888240001
    TOBBELL, Susan Margaret
    4 Grove Lane
    CM16 4LH Epping
    Vincent House
    Essex
    England
    Administrateur
    4 Grove Lane
    CM16 4LH Epping
    Vincent House
    Essex
    England
    United KingdomBritish17957620003

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur MATRIX (HIGHLANDS) LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Malthurst Petroleum Limited
    36-38 Upper Marlborough Road
    AL1 3UU St Albans
    Gladstone Place
    Hertfordshire
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    36-38 Upper Marlborough Road
    AL1 3UU St Albans
    Gladstone Place
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiquePrivate Limited Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementEngland And Wales
    Numéro d'enregistrement00762360
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.

    MATRIX (HIGHLANDS) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 20 août 2015
    Livré le 25 août 2015
    Totalement satisfaite
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Agent
    Transactions
    • 25 août 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 06 mars 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 10 déc. 2009
    Livré le 15 déc. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 15 déc. 2009Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 06 mars 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Standard security
    Créé le 30 nov. 2009
    Livré le 02 févr. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All and whole the subjects k/a and forming that area of ground at mintlaw service station south street mintlaw aberdeen comprising first:- (first) (one) all and whole that piece of ground lying in the village and lands and estate of mintlaw in the parish of longside and county of aberdeen, being the area of ground more particularly described in and shown delinated and coloured pink on the plan annexed (two) all and whole that lot of area of ground situated in the square in the village of mintlaw in the parish of longside and county of aberdeen see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 02 févr. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 20 août 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 8 january 2007 and
    Créé le 03 janv. 2007
    Livré le 24 janv. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Pitlochry service station perth road pitlochry.
    Personnes ayant droit
    • Bp Oil UK Limited
    Transactions
    • 24 janv. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 août 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 20TH september 2000 and
    Créé le 31 août 2000
    Livré le 28 sept. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    That area of ground extending to 91 poles 24 square yards or thereby lying in the former burgh of forres and county of moray together with the whole buildings and other erections thereon; all fittings fixtures therein and all right,title and interest thereon. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Girobank PLC
    Transactions
    • 28 sept. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 janv. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Standard security
    Créé le 02 oct. 1992
    Livré le 16 oct. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee in terms of a minute of agreement dated 1ST and 22ND july 1992 and any future agreement.
    Brèves mentions
    All and whole the dominium utile and dominium directum of all and whole that piece of ground lying in the village and lands and estate of mintlaw in the parish of longside and county of aberdeen. For full details please see doc M385C.
    Personnes ayant droit
    • Bp Oil UK Limited
    Transactions
    • 16 oct. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 août 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Standard security
    Créé le 19 juin 1991
    Livré le 27 juin 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £91800 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the guarantee by F.W.kerridge limited in respect of the obligations of the company
    Brèves mentions
    All and whole that area of ground extending to ninety one poles, twenty four square yards of thereby imperial standard measure lying in the former burgh of forres and county of moray see form 395 for details.
    Personnes ayant droit
    • Texaco Limited
    Transactions
    • 27 juin 1991Enregistrement d'une charge
    • 15 juin 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0