TAUNTON CIDER
Vue d'ensemble
| Nom de la société | TAUNTON CIDER |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société privée à responsabilité illimitée |
| Numéro de société | 02560211 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe TAUNTON CIDER ?
| Adresse du siège social | Constellation House The Guildway Old Portsmouth Road GU3 1LR Artington Guildford Surrey |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de TAUNTON CIDER ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 28 févr. 2011 |
Quels sont les derniers dépôts pour TAUNTON CIDER ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 01 nov. 2012 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 01 nov. 2011 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 28 févr. 2011 | 12 pages | AA | ||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Mr Ronald Charles Fondiller le 27 juin 2011 | 2 pages | CH03 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Perry Richard Humphrey le 27 juin 2011 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Barbara Joy Laverdi le 27 juin 2011 | 2 pages | CH03 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr David Eric Klein le 27 juin 2011 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Deepak Malhotra en tant que secrétaire | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Nomination de Mr David Eric Klein en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mr Perry Richard Humphrey en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Troy Christensen en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Francis Hetterich en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Barbara Joy Laverdi en tant que secrétaire | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Nomination de Mr Ronald Charles Fondiller en tant que secrétaire | 2 pages | AP03 | ||||||||||
legacy | 3 pages | MG02 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 01 nov. 2010 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Helen Glennie en tant que secrétaire | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 28 févr. 2010 | 4 pages | AA | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Troy Christensen le 11 juin 2010 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Nomination de Mr Francis Paul Hetterich en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mrs Helen Margaret Glennie en tant que secrétaire | 1 pages | AP03 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Helen Glennie en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de TAUNTON CIDER ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FONDILLER, Ronald Charles | Secrétaire | The Guildway Old Portsmouth Road GU3 1LR Guildford Accolade House Surrey United Kingdom | 159704710001 | |||||||
| LAVERDI, Barbara Joy | Secrétaire | The Guildway Old Portsmouth Road GU3 1LR Guildford Accolade House Surrey United Kingdom | 159704720001 | |||||||
| HUMPHREY, Perry Richard | Administrateur | The Guildway Old Portsmouth Road GU3 1LR Guildford Accolade House Surrey United Kingdom | United States | American | 159704890001 | |||||
| KLEIN, David Eric | Administrateur | The Guildway Old Portsmouth Road GU3 1LR Guildford Accolade House Surrey United Kingdom | United States | American | 153569440001 | |||||
| COLQUHOUN, Anne Therese | Secrétaire | Apartment B Kings Ride House Prince Albert Drive SL5 8AQ Ascot | British | 28396500005 | ||||||
| GIBBS, Brian | Secrétaire | Furlongs 4 Killams Green TA1 3YQ Taunton Somerset | British | 10630840002 | ||||||
| GLENNIE, Helen Margaret | Secrétaire | Constellation House The Guildway Old Portsmouth Road GU3 1LR Artington Guildford Surrey | 149568800001 | |||||||
| MALHOTRA, Deepak Kumar | Secrétaire | Constellation House The Guildway Old Portsmouth Road GU3 1LR Artington Guildford Surrey | British | 69554640002 | ||||||
| ADAMS, Peter George | Administrateur | Lower Northcott Farm Sheldon EX15 2JF Cullompton Devon | British | 112143030001 | ||||||
| BOASE, Martin | Administrateur | 27 St Leonards Terrace SW3 4QG London | United Kingdom | British | 1460150003 | |||||
| CARSON, Christopher | Administrateur | White Gates 11 Oxshott Way KT11 2RU Cobham Surrey | British | 26602290003 | ||||||
| CHRISTENSEN, Troy | Administrateur | Constellation House The Guildway Old Portsmouth Road GU3 1LR Artington Guildford Surrey | Australia | American | 130789730002 | |||||
| COLQUHOUN, Anne Therese | Administrateur | Apartment B Kings Ride House Prince Albert Drive SL5 8AQ Ascot | United Kingdom | British | 28396500005 | |||||
| COTTRELL, Michael Noel Francis | Administrateur | Laurenden Forstal Challock Lees TN25 4AU Ashford Kent | British | 16762950001 | ||||||
| CREIGHTON, Thomas Hugh | Administrateur | Apple Acre High Road CR5 3QR Chipstead Surrey | England | British | 157727790001 | |||||
| DAVIS, Peter John | Administrateur | 9 Christchurch Street SW3 4AN London | British | 988330001 | ||||||
| ETHERIDGE, Hugh Charles | Administrateur | 5 Springfield Place BA1 5RA Bath Avon | United Kingdom | British | 1491130002 | |||||
| FOTHERGILL, David | Administrateur | Woodfordes Stoke St Mary TA3 5BY Taunton Somerset | British | 35902810001 | ||||||
| GARNER, Michael Frederick | Administrateur | Old Drews Knotty Green HP9 2TT Beaconsfield Buckinghamshire | United Kingdom | British | 17481250001 | |||||
| GLENNIE, Helen Margaret | Administrateur | Constellation House The Guildway Old Portsmouth Road GU3 1LR Artington Guildford Surrey | United Kingdom | British | 137615160001 | |||||
| GOUGH, Jeremy David Erle | Administrateur | 15 Burstock Road SW15 2PW London | British | 62545050001 | ||||||
| HETTERICH, Francis Paul | Administrateur | The Guildway, Old Portsmouth Road Artington GU3 1LR Guildford Constellation House Surrey United Kingdom | United States | American | 147054340001 | |||||
| HODGES, Nigel Ian | Administrateur | Sonning House 2 Canns Lane TA6 6QF North Petherton Somerset | British | 75692570001 | ||||||
| HUNTLEY, Peter William | Administrateur | 28 Allan Glen Gardens Bishopbriggs G64 3BG Glasgow | Scotland | British | 46387640002 | |||||
| KLEIN, David | Administrateur | 45 Princes Road The Alberts TW10 6DQ Richmond Surrey | American | 119928070001 | ||||||
| LONGSTAFF, Brian William | Administrateur | The Old Rectory TA3 6AG Beer Crocombe Somerset | British | 10586030001 | ||||||
| MALHOTRA, Deepak Kumar | Administrateur | Constellation House The Guildway Old Portsmouth Road GU3 1LR Artington Guildford Surrey | United Kingdom | British | 69554640002 | |||||
| MORAMARCO, Jon | Administrateur | C8 Trinity Gate Epsom Road GU1 3PW Guildford Surrey | American | 114902210001 | ||||||
| MURRAY, Norman Loch | Administrateur | 8 Pentland Avenue EH13 0HZ Edinburgh | Scotland | British | 22920002 | |||||
| NASH, Andrew John | Administrateur | Cheddon Corner Cheddon Fitzpaine TA2 8LB Taunton Somerset | England | British | 53544690001 | |||||
| PEARCH, Nicholas Keith | Administrateur | The Close Church Street Blagdon BS18 6SJ Bristol Avon | British | 21035260001 | ||||||
| PETERS, Richard David | Administrateur | Rose Cottage, Upper House Lane Shamley Green GU5 0SX Guildford Surrey | United Kingdom | British | 60630980002 | |||||
| ROBERTS, Charles Francis Miles | Administrateur | The Poplars Staplegrove TA2 6AJ Taunton Somerset | British | 21087800001 |
TAUNTON CIDER a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Assignment | Créé le 08 nov. 1991 Livré le 26 nov. 1991 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of any relevant documents | |
Brèves mentions All rights title interest in and to the insurance policies.see schedule attachedfor details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Guarantee and debenture | Créé le 22 mai 1991 Livré le 05 juin 1991 | Totalement satisfaite | Montant garanti All moneys due or to become due from the company to the chargee under the terms of the "relevant documents" as defined in the deed | |
Brèves mentions (Please see doc M634C for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Deed of assignment of key man policies | Créé le 22 mai 1991 Livré le 05 juin 1991 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of any relevant documents (as defined) | |
Brèves mentions All the company's right title and interest in and to the interim insurance policies- see form 395 (ref 66) for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0