TAUNTON CIDER

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéTAUNTON CIDER
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété privée à responsabilité illimitée
    Numéro de société 02560211
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de TAUNTON CIDER ?

    • Activités des sièges sociaux (70100) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe TAUNTON CIDER ?

    Adresse du siège social
    Constellation House
    The Guildway Old Portsmouth Road
    GU3 1LR Artington Guildford
    Surrey
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de TAUNTON CIDER ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    TAUNTON BRANDS LIMITED14 juin 199114 juin 1991
    GRAVITAS 1001 LIMITED20 nov. 199020 nov. 1990

    Quels sont les derniers comptes de TAUNTON CIDER ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au28 févr. 2011

    Quels sont les derniers dépôts pour TAUNTON CIDER ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 nov. 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital06 nov. 2012

    État du capital au 06 nov. 2012

    • Capital: GBP .2
    SH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 nov. 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 28 févr. 2011

    12 pagesAA

    Modification des coordonnées du secrétaire Mr Ronald Charles Fondiller le 27 juin 2011

    2 pagesCH03

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Perry Richard Humphrey le 27 juin 2011

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Barbara Joy Laverdi le 27 juin 2011

    2 pagesCH03

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr David Eric Klein le 27 juin 2011

    2 pagesCH01

    Cessation de la nomination de Deepak Malhotra en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Nomination de Mr David Eric Klein en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Perry Richard Humphrey en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Troy Christensen en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Francis Hetterich en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Barbara Joy Laverdi en tant que secrétaire

    2 pagesAP03

    Nomination de Mr Ronald Charles Fondiller en tant que secrétaire

    2 pagesAP03

    legacy

    3 pagesMG02

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 nov. 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Cessation de la nomination de Helen Glennie en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Comptes pour une société dormante établis au 28 févr. 2010

    4 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Troy Christensen le 11 juin 2010

    2 pagesCH01

    Nomination de Mr Francis Paul Hetterich en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Nomination de Mrs Helen Margaret Glennie en tant que secrétaire

    1 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Helen Glennie en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de TAUNTON CIDER ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    FONDILLER, Ronald Charles
    The Guildway
    Old Portsmouth Road
    GU3 1LR Guildford
    Accolade House
    Surrey
    United Kingdom
    Secrétaire
    The Guildway
    Old Portsmouth Road
    GU3 1LR Guildford
    Accolade House
    Surrey
    United Kingdom
    159704710001
    LAVERDI, Barbara Joy
    The Guildway
    Old Portsmouth Road
    GU3 1LR Guildford
    Accolade House
    Surrey
    United Kingdom
    Secrétaire
    The Guildway
    Old Portsmouth Road
    GU3 1LR Guildford
    Accolade House
    Surrey
    United Kingdom
    159704720001
    HUMPHREY, Perry Richard
    The Guildway
    Old Portsmouth Road
    GU3 1LR Guildford
    Accolade House
    Surrey
    United Kingdom
    Administrateur
    The Guildway
    Old Portsmouth Road
    GU3 1LR Guildford
    Accolade House
    Surrey
    United Kingdom
    United StatesAmerican159704890001
    KLEIN, David Eric
    The Guildway
    Old Portsmouth Road
    GU3 1LR Guildford
    Accolade House
    Surrey
    United Kingdom
    Administrateur
    The Guildway
    Old Portsmouth Road
    GU3 1LR Guildford
    Accolade House
    Surrey
    United Kingdom
    United StatesAmerican153569440001
    COLQUHOUN, Anne Therese
    Apartment B Kings Ride House
    Prince Albert Drive
    SL5 8AQ Ascot
    Secrétaire
    Apartment B Kings Ride House
    Prince Albert Drive
    SL5 8AQ Ascot
    British28396500005
    GIBBS, Brian
    Furlongs
    4 Killams Green
    TA1 3YQ Taunton
    Somerset
    Secrétaire
    Furlongs
    4 Killams Green
    TA1 3YQ Taunton
    Somerset
    British10630840002
    GLENNIE, Helen Margaret
    Constellation House
    The Guildway Old Portsmouth Road
    GU3 1LR Artington Guildford
    Surrey
    Secrétaire
    Constellation House
    The Guildway Old Portsmouth Road
    GU3 1LR Artington Guildford
    Surrey
    149568800001
    MALHOTRA, Deepak Kumar
    Constellation House
    The Guildway Old Portsmouth Road
    GU3 1LR Artington Guildford
    Surrey
    Secrétaire
    Constellation House
    The Guildway Old Portsmouth Road
    GU3 1LR Artington Guildford
    Surrey
    British69554640002
    ADAMS, Peter George
    Lower Northcott Farm
    Sheldon
    EX15 2JF Cullompton
    Devon
    Administrateur
    Lower Northcott Farm
    Sheldon
    EX15 2JF Cullompton
    Devon
    British112143030001
    BOASE, Martin
    27 St Leonards Terrace
    SW3 4QG London
    Administrateur
    27 St Leonards Terrace
    SW3 4QG London
    United KingdomBritish1460150003
    CARSON, Christopher
    White Gates
    11 Oxshott Way
    KT11 2RU Cobham
    Surrey
    Administrateur
    White Gates
    11 Oxshott Way
    KT11 2RU Cobham
    Surrey
    British26602290003
    CHRISTENSEN, Troy
    Constellation House
    The Guildway Old Portsmouth Road
    GU3 1LR Artington Guildford
    Surrey
    Administrateur
    Constellation House
    The Guildway Old Portsmouth Road
    GU3 1LR Artington Guildford
    Surrey
    AustraliaAmerican130789730002
    COLQUHOUN, Anne Therese
    Apartment B Kings Ride House
    Prince Albert Drive
    SL5 8AQ Ascot
    Administrateur
    Apartment B Kings Ride House
    Prince Albert Drive
    SL5 8AQ Ascot
    United KingdomBritish28396500005
    COTTRELL, Michael Noel Francis
    Laurenden Forstal
    Challock Lees
    TN25 4AU Ashford
    Kent
    Administrateur
    Laurenden Forstal
    Challock Lees
    TN25 4AU Ashford
    Kent
    British16762950001
    CREIGHTON, Thomas Hugh
    Apple Acre
    High Road
    CR5 3QR Chipstead
    Surrey
    Administrateur
    Apple Acre
    High Road
    CR5 3QR Chipstead
    Surrey
    EnglandBritish157727790001
    DAVIS, Peter John
    9 Christchurch Street
    SW3 4AN London
    Administrateur
    9 Christchurch Street
    SW3 4AN London
    British988330001
    ETHERIDGE, Hugh Charles
    5 Springfield Place
    BA1 5RA Bath
    Avon
    Administrateur
    5 Springfield Place
    BA1 5RA Bath
    Avon
    United KingdomBritish1491130002
    FOTHERGILL, David
    Woodfordes
    Stoke St Mary
    TA3 5BY Taunton
    Somerset
    Administrateur
    Woodfordes
    Stoke St Mary
    TA3 5BY Taunton
    Somerset
    British35902810001
    GARNER, Michael Frederick
    Old Drews
    Knotty Green
    HP9 2TT Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Old Drews
    Knotty Green
    HP9 2TT Beaconsfield
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish17481250001
    GLENNIE, Helen Margaret
    Constellation House
    The Guildway Old Portsmouth Road
    GU3 1LR Artington Guildford
    Surrey
    Administrateur
    Constellation House
    The Guildway Old Portsmouth Road
    GU3 1LR Artington Guildford
    Surrey
    United KingdomBritish137615160001
    GOUGH, Jeremy David Erle
    15 Burstock Road
    SW15 2PW London
    Administrateur
    15 Burstock Road
    SW15 2PW London
    British62545050001
    HETTERICH, Francis Paul
    The Guildway, Old Portsmouth Road
    Artington
    GU3 1LR Guildford
    Constellation House
    Surrey
    United Kingdom
    Administrateur
    The Guildway, Old Portsmouth Road
    Artington
    GU3 1LR Guildford
    Constellation House
    Surrey
    United Kingdom
    United StatesAmerican147054340001
    HODGES, Nigel Ian
    Sonning House
    2 Canns Lane
    TA6 6QF North Petherton
    Somerset
    Administrateur
    Sonning House
    2 Canns Lane
    TA6 6QF North Petherton
    Somerset
    British75692570001
    HUNTLEY, Peter William
    28 Allan Glen Gardens
    Bishopbriggs
    G64 3BG Glasgow
    Administrateur
    28 Allan Glen Gardens
    Bishopbriggs
    G64 3BG Glasgow
    ScotlandBritish46387640002
    KLEIN, David
    45 Princes Road
    The Alberts
    TW10 6DQ Richmond
    Surrey
    Administrateur
    45 Princes Road
    The Alberts
    TW10 6DQ Richmond
    Surrey
    American119928070001
    LONGSTAFF, Brian William
    The Old Rectory
    TA3 6AG Beer Crocombe
    Somerset
    Administrateur
    The Old Rectory
    TA3 6AG Beer Crocombe
    Somerset
    British10586030001
    MALHOTRA, Deepak Kumar
    Constellation House
    The Guildway Old Portsmouth Road
    GU3 1LR Artington Guildford
    Surrey
    Administrateur
    Constellation House
    The Guildway Old Portsmouth Road
    GU3 1LR Artington Guildford
    Surrey
    United KingdomBritish69554640002
    MORAMARCO, Jon
    C8 Trinity Gate
    Epsom Road
    GU1 3PW Guildford
    Surrey
    Administrateur
    C8 Trinity Gate
    Epsom Road
    GU1 3PW Guildford
    Surrey
    American114902210001
    MURRAY, Norman Loch
    8 Pentland Avenue
    EH13 0HZ Edinburgh
    Administrateur
    8 Pentland Avenue
    EH13 0HZ Edinburgh
    ScotlandBritish22920002
    NASH, Andrew John
    Cheddon Corner
    Cheddon Fitzpaine
    TA2 8LB Taunton
    Somerset
    Administrateur
    Cheddon Corner
    Cheddon Fitzpaine
    TA2 8LB Taunton
    Somerset
    EnglandBritish53544690001
    PEARCH, Nicholas Keith
    The Close Church Street
    Blagdon
    BS18 6SJ Bristol
    Avon
    Administrateur
    The Close Church Street
    Blagdon
    BS18 6SJ Bristol
    Avon
    British21035260001
    PETERS, Richard David
    Rose Cottage, Upper House Lane
    Shamley Green
    GU5 0SX Guildford
    Surrey
    Administrateur
    Rose Cottage, Upper House Lane
    Shamley Green
    GU5 0SX Guildford
    Surrey
    United KingdomBritish60630980002
    ROBERTS, Charles Francis Miles
    The Poplars
    Staplegrove
    TA2 6AJ Taunton
    Somerset
    Administrateur
    The Poplars
    Staplegrove
    TA2 6AJ Taunton
    Somerset
    British21087800001

    TAUNTON CIDER a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Assignment
    Créé le 08 nov. 1991
    Livré le 26 nov. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of any relevant documents
    Brèves mentions
    All rights title interest in and to the insurance policies.see schedule attachedfor details.
    Personnes ayant droit
    • Samuel Montagu &Co. Limited as Trustee for the Security Beneficaries
    Transactions
    • 26 nov. 1991Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 févr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Guarantee and debenture
    Créé le 22 mai 1991
    Livré le 05 juin 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys due or to become due from the company to the chargee under the terms of the "relevant documents" as defined in the deed
    Brèves mentions
    (Please see doc M634C for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Samuel Montagu & Co. Limited(As Trustee for the Security Beneficiaries)
    Transactions
    • 05 juin 1991Enregistrement d'une charge
    • 21 août 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of assignment of key man policies
    Créé le 22 mai 1991
    Livré le 05 juin 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of any relevant documents (as defined)
    Brèves mentions
    All the company's right title and interest in and to the interim insurance policies- see form 395 (ref 66) for full details.
    Personnes ayant droit
    • Samuel Montague & Co LTD(As Trustee for the Security Beneficiaries)
    Transactions
    • 05 juin 1991Enregistrement d'une charge
    • 21 août 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0