OPEN ACCOUNTS LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | OPEN ACCOUNTS LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 02561244 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe OPEN ACCOUNTS LIMITED ?
Adresse du siège social | Munro House Portsmouth Road KT11 1TF Cobham Surrey |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de OPEN ACCOUNTS LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 28 févr. 2015 |
Quel est le statut du dernier bilan annuel pour OPEN ACCOUNTS LIMITED ?
Bilan annuel |
|
---|
Quels sont les derniers dépôts pour OPEN ACCOUNTS LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 28 févr. 2015 | 8 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de Paul David Gibson en tant que directeur le 09 sept. 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Gordon James Wilson en tant qu'administrateur le 09 sept. 2015 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Vinodka Murria en tant que directeur le 18 mai 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Barbara Ann Firth en tant que directeur le 31 mars 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Ms Vinodka Murria le 06 déc. 2014 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 22 nov. 2014 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 28 févr. 2014 | 7 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 22 nov. 2013 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 28 févr. 2013 | 7 pages | AA | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mrs Barbara Ann Firth le 11 déc. 2012 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 22 nov. 2012 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 29 févr. 2012 | 7 pages | AA | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Paul David Gibson le 06 sept. 2012 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 22 nov. 2011 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 28 févr. 2011 | 7 pages | AA | ||||||||||
legacy | 3 pages | MG02 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Hilary Lowe en tant que secrétaire | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Nomination de Hilary Anne Lowe en tant que secrétaire | 3 pages | AP03 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Paul Gibson en tant que secrétaire | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Mark Harry Thompson en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 22 nov. 2010 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de OPEN ACCOUNTS LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WILSON, Gordon James | Administrateur | Munro House Portsmouth Road KT11 1TF Cobham Surrey | United Kingdom | British | Ceo | 200853210001 | ||||
GIBSON, Paul David | Secrétaire | Munro House Portsmouth Road KT11 1TF Cobham Surrey | British | 192439290001 | ||||||
JANES, Paul Nicholas | Secrétaire | 12 Lister Drive NN4 9XE Northampton Northamptonshire | British | Chartered Accountant | 24280810002 | |||||
LINCOLN, Jeremy James Passmore | Secrétaire | The Mill House West Farndon NN11 3TX Daventry Northamptonshire | British | 77671560001 | ||||||
LOWE, Hilary Anne | Secrétaire | Portsmouth Road KT11 3HQ Cobham Munro House Surrey | British | 159477980001 | ||||||
WILLIAMS, Shirley Ann | Secrétaire | Paddocks View 15 Newland Street LE16 8LW Braybrooke Mkt Harborough | British | 32807350001 | ||||||
BRACKEN, Jennifer Mary | Administrateur | 6 Cave Close Cawston CV22 7GL Rugby Warwickshire | England | British | Marketing Director | 64931860003 | ||||
BUSHELL, Stephen | Administrateur | 23 Isham Close NN2 7AQ Northampton Northamptonshire | British | Technical Director | 64931820001 | |||||
COOK, David Anthony | Administrateur | Brailes Hill House Upper Brailes OX15 5AT Banbury | England | British | Sales And Marketing Manager | 28576840003 | ||||
COULSON, Richard John | Administrateur | New Farm Fawsley NN11 3BT Daventry Northamptonshire | British | 18833330001 | ||||||
DAVIS, James Richard | Administrateur | Church Farm View LE12 Osgathorpe Leicestershire | British | Director | 60399700001 | |||||
FIRTH, Barbara Ann | Administrateur | Munro House Portsmouth Road KT11 1TF Cobham Surrey | United Kingdom | British | Finance Director | 73934790009 | ||||
FROST, Davey | Administrateur | 21 Marriotts Road Long Buckby NN6 7QY Northampton Northamptonshire | England | English | Company Director | 17000570001 | ||||
GIBSON, Paul David | Administrateur | Munro House Portsmouth Road KT11 1TF Cobham Surrey | United Kingdom | British | Fcca | 192439290001 | ||||
JANES, Paul Nicholas | Administrateur | 12 Lister Drive NN4 9XE Northampton Northamptonshire | England | British | Chartered Accountant | 24280810002 | ||||
MURRIA, Vinodka | Administrateur | Munro House Portsmouth Road KT11 1TF Cobham Surrey | England | British | Ceo | 57998050007 | ||||
THOMPSON, Mark Harry | Administrateur | Munro House Portsmouth Road KT11 1TF Cobham Surrey | United Kingdom | British | Director | 156095450001 | ||||
TIMOTHY, Fiona Maria | Administrateur | Munro House Portsmouth Road KT11 1TF Cobham Surrey | England | British | Director | 161343370001 | ||||
WILLIAMS, Shirley Ann | Administrateur | 29 The Woodlands LE16 7BW Market Harborough Leicestershire | British | Accountant | 32807350002 |
OPEN ACCOUNTS LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Créé le 07 mars 2007 Livré le 09 mars 2007 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 07 sept. 2004 Livré le 11 sept. 2004 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions The f/h property k/a the white house church walk daventry northampton NN11 4BL t/n NN158704. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 07 sept. 2004 Livré le 11 sept. 2004 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Mortgage debenture | Créé le 24 févr. 1992 Livré le 06 mars 1992 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0