OPEN ACCOUNTS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéOPEN ACCOUNTS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02561244
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de OPEN ACCOUNTS LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe OPEN ACCOUNTS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Munro House
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Surrey
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de OPEN ACCOUNTS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    OPENAGE LIMITED14 août 199114 août 1991
    WORTHFORT LIMITED22 nov. 199022 nov. 1990

    Quels sont les derniers comptes de OPEN ACCOUNTS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au28 févr. 2015

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour OPEN ACCOUNTS LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour OPEN ACCOUNTS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Comptes pour une société dormante établis au 28 févr. 2015

    8 pagesAA

    Cessation de la nomination de Paul David Gibson en tant que directeur le 09 sept. 2015

    1 pagesTM01

    Nomination de Gordon James Wilson en tant qu'administrateur le 09 sept. 2015

    2 pagesAP01

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Cessation de la nomination de Vinodka Murria en tant que directeur le 18 mai 2015

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Barbara Ann Firth en tant que directeur le 31 mars 2015

    1 pagesTM01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Ms Vinodka Murria le 06 déc. 2014

    2 pagesCH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 22 nov. 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital16 déc. 2014

    État du capital au 16 déc. 2014

    • Capital: GBP 259,859
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 28 févr. 2014

    7 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 22 nov. 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital26 nov. 2013

    État du capital au 26 nov. 2013

    • Capital: GBP 259,859
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 28 févr. 2013

    7 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mrs Barbara Ann Firth le 11 déc. 2012

    2 pagesCH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 22 nov. 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 29 févr. 2012

    7 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Paul David Gibson le 06 sept. 2012

    2 pagesCH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 22 nov. 2011 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 28 févr. 2011

    7 pagesAA

    legacy

    3 pagesMG02

    Cessation de la nomination de Hilary Lowe en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Nomination de Hilary Anne Lowe en tant que secrétaire

    3 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Paul Gibson en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Mark Harry Thompson en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 22 nov. 2010 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Qui sont les dirigeants de OPEN ACCOUNTS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    WILSON, Gordon James
    Munro House
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Surrey
    Administrateur
    Munro House
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Surrey
    United KingdomBritishCeo200853210001
    GIBSON, Paul David
    Munro House
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Surrey
    Secrétaire
    Munro House
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Surrey
    British192439290001
    JANES, Paul Nicholas
    12 Lister Drive
    NN4 9XE Northampton
    Northamptonshire
    Secrétaire
    12 Lister Drive
    NN4 9XE Northampton
    Northamptonshire
    BritishChartered Accountant24280810002
    LINCOLN, Jeremy James Passmore
    The Mill House
    West Farndon
    NN11 3TX Daventry
    Northamptonshire
    Secrétaire
    The Mill House
    West Farndon
    NN11 3TX Daventry
    Northamptonshire
    British77671560001
    LOWE, Hilary Anne
    Portsmouth Road
    KT11 3HQ Cobham
    Munro House
    Surrey
    Secrétaire
    Portsmouth Road
    KT11 3HQ Cobham
    Munro House
    Surrey
    British159477980001
    WILLIAMS, Shirley Ann
    Paddocks View
    15 Newland Street
    LE16 8LW Braybrooke
    Mkt Harborough
    Secrétaire
    Paddocks View
    15 Newland Street
    LE16 8LW Braybrooke
    Mkt Harborough
    British32807350001
    BRACKEN, Jennifer Mary
    6 Cave Close
    Cawston
    CV22 7GL Rugby
    Warwickshire
    Administrateur
    6 Cave Close
    Cawston
    CV22 7GL Rugby
    Warwickshire
    EnglandBritishMarketing Director64931860003
    BUSHELL, Stephen
    23 Isham Close
    NN2 7AQ Northampton
    Northamptonshire
    Administrateur
    23 Isham Close
    NN2 7AQ Northampton
    Northamptonshire
    BritishTechnical Director64931820001
    COOK, David Anthony
    Brailes Hill House
    Upper Brailes
    OX15 5AT Banbury
    Administrateur
    Brailes Hill House
    Upper Brailes
    OX15 5AT Banbury
    EnglandBritishSales And Marketing Manager28576840003
    COULSON, Richard John
    New Farm
    Fawsley
    NN11 3BT Daventry
    Northamptonshire
    Administrateur
    New Farm
    Fawsley
    NN11 3BT Daventry
    Northamptonshire
    British18833330001
    DAVIS, James Richard
    Church Farm View
    LE12 Osgathorpe
    Leicestershire
    Administrateur
    Church Farm View
    LE12 Osgathorpe
    Leicestershire
    BritishDirector60399700001
    FIRTH, Barbara Ann
    Munro House
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Surrey
    Administrateur
    Munro House
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Surrey
    United KingdomBritishFinance Director73934790009
    FROST, Davey
    21 Marriotts Road
    Long Buckby
    NN6 7QY Northampton
    Northamptonshire
    Administrateur
    21 Marriotts Road
    Long Buckby
    NN6 7QY Northampton
    Northamptonshire
    EnglandEnglishCompany Director17000570001
    GIBSON, Paul David
    Munro House
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Surrey
    Administrateur
    Munro House
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Surrey
    United KingdomBritishFcca192439290001
    JANES, Paul Nicholas
    12 Lister Drive
    NN4 9XE Northampton
    Northamptonshire
    Administrateur
    12 Lister Drive
    NN4 9XE Northampton
    Northamptonshire
    EnglandBritishChartered Accountant24280810002
    MURRIA, Vinodka
    Munro House
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Surrey
    Administrateur
    Munro House
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Surrey
    EnglandBritishCeo57998050007
    THOMPSON, Mark Harry
    Munro House
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Surrey
    Administrateur
    Munro House
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Surrey
    United KingdomBritishDirector156095450001
    TIMOTHY, Fiona Maria
    Munro House
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Surrey
    Administrateur
    Munro House
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Surrey
    EnglandBritishDirector161343370001
    WILLIAMS, Shirley Ann
    29 The Woodlands
    LE16 7BW Market Harborough
    Leicestershire
    Administrateur
    29 The Woodlands
    LE16 7BW Market Harborough
    Leicestershire
    BritishAccountant32807350002

    OPEN ACCOUNTS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 07 mars 2007
    Livré le 09 mars 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 09 mars 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 juil. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 07 sept. 2004
    Livré le 11 sept. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The f/h property k/a the white house church walk daventry northampton NN11 4BL t/n NN158704. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 11 sept. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 avr. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 07 sept. 2004
    Livré le 11 sept. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 11 sept. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 mai 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 24 févr. 1992
    Livré le 06 mars 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 06 mars 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 juin 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0