SHOREPAC LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSHOREPAC LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02562324
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de SHOREPAC LIMITED ?

    • (2121) /

    Où se situe SHOREPAC LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Beech House Whitebrook Park
    68 Lower Cookham Road
    SL6 8XY Maidenhead
    Berkshire
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de SHOREPAC LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 avr. 2010

    Quels sont les derniers dépôts pour SHOREPAC LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Déclaration de biens vacants

    1 pagesBONA

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Cessation de la nomination de Carolyn Cattermole en tant que directeur

    1 pagesTM01

    La procédure de radiation volontaire a été suspendue.

    1 pagesSOAS(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 10 mai 2011

    • Capital: GBP 10
    4 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Déclaration des objets de la société

    2 pagesCC04

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution de modification des statuts

    RES01

    Déclaration annuelle jusqu'au 17 sept. 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 avr. 2010

    7 pagesAA

    Cessation de la nomination de Alexander Manisty en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Anthony Thorne en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Miles William Roberts en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 avr. 2009

    7 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Alexander Manisty le 01 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Dr Anthony David Thorne le 01 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Stephen William Dryden le 01 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Carolyn Tracy Cattermole le 01 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Anne Steele le 01 oct. 2009

    1 pagesCH03

    legacy

    4 pages363a

    legacy

    1 pages287

    Qui sont les dirigeants de SHOREPAC LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    STEELE, Anne
    Whitebrook Park
    68 Lower Cookham Road
    SL6 8XY Maidenhead
    Beech House
    Berkshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Whitebrook Park
    68 Lower Cookham Road
    SL6 8XY Maidenhead
    Beech House
    Berkshire
    United Kingdom
    British77624110001
    DRYDEN, Stephen William
    Whitebrook Park
    68 Lower Cookham Road
    SL6 8XY Maidenhead
    Beech House
    Berkshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Whitebrook Park
    68 Lower Cookham Road
    SL6 8XY Maidenhead
    Beech House
    Berkshire
    United Kingdom
    EnglandBritish47821400004
    ROBERTS, Miles William
    Whitebrook Park
    68 Lower Cookham Road
    SL6 8XY Maidenhead
    Beech House
    Berkshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Whitebrook Park
    68 Lower Cookham Road
    SL6 8XY Maidenhead
    Beech House
    Berkshire
    United Kingdom
    EnglandBritish57880630003
    BALL, Janet Vivien
    The Beeches St Marys Lane
    LN11 0DU Louth
    Lincolnshire
    Secrétaire
    The Beeches St Marys Lane
    LN11 0DU Louth
    Lincolnshire
    British22587470002
    FENSOME, Richard James
    Ravenscroft
    15 Fulmer Drive
    SL9 7HH Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    Ravenscroft
    15 Fulmer Drive
    SL9 7HH Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    British84096960001
    ULYATT, Ann
    Raybecca
    Main Road Thimbleby
    LN9 5RB Horncastle
    Lincolnshire
    Secrétaire
    Raybecca
    Main Road Thimbleby
    LN9 5RB Horncastle
    Lincolnshire
    British20885500001
    BALL, Janet Vivien
    The Beeches St Marys Lane
    LN11 0DU Louth
    Lincolnshire
    Administrateur
    The Beeches St Marys Lane
    LN11 0DU Louth
    Lincolnshire
    British22587470002
    BALL, Kenneth William
    The Beeches St Marys Lane
    LN11 0DU Louth
    Lincolnshire
    Administrateur
    The Beeches St Marys Lane
    LN11 0DU Louth
    Lincolnshire
    EnglandBritish4246970002
    BLACKFORD, Christopher Fitzgerald
    .
    Dovecote Church Road, Walpole St Peter
    PE14 7NS Wisbech
    Administrateur
    .
    Dovecote Church Road, Walpole St Peter
    PE14 7NS Wisbech
    British61034050002
    BROUGHTON, Geoffrey
    17 St James View
    LN11 9XY Louth
    Lincolnshire
    Administrateur
    17 St James View
    LN11 9XY Louth
    Lincolnshire
    British45727470002
    BUTTON, Graham Christopher
    1 Harmston Park Avenue
    LN5 9GF Lincoln
    Lincolnshire
    Administrateur
    1 Harmston Park Avenue
    LN5 9GF Lincoln
    Lincolnshire
    British77558190002
    CATTERMOLE, Carolyn Tracy
    Whitebrook Park
    68 Lower Cookham Road
    SL6 8XY Maidenhead
    Beech House
    Berkshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Whitebrook Park
    68 Lower Cookham Road
    SL6 8XY Maidenhead
    Beech House
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish53026290002
    GOULSBRA, Andrew
    4 Alfred Smith Way
    Legbourne
    LN11 8NE Louth
    Lincolnshire
    Administrateur
    4 Alfred Smith Way
    Legbourne
    LN11 8NE Louth
    Lincolnshire
    British45727460001
    LOWE, John Arthur
    14 North Park Road
    LS8 1JD Leeds
    Administrateur
    14 North Park Road
    LS8 1JD Leeds
    British51404250001
    MANISTY, Alexander
    Whitebrook Park
    68 Lower Cookham Road
    SL6 8XY Maidenhead
    Beech House
    Berkshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Whitebrook Park
    68 Lower Cookham Road
    SL6 8XY Maidenhead
    Beech House
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish72427180001
    MORRIS, Gavin Mathew
    20 Argyll Road
    W8 7BG London
    Administrateur
    20 Argyll Road
    W8 7BG London
    EnglandBritish16228990001
    THORNE, Anthony David
    Whitebrook Park
    68 Lower Cookham Road
    SL6 8XY Maidenhead
    Beech House
    Berkshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Whitebrook Park
    68 Lower Cookham Road
    SL6 8XY Maidenhead
    Beech House
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish40130640001
    ULYATT, Ann
    Raybecca
    Main Road Thimbleby
    LN9 5RB Horncastle
    Lincolnshire
    Administrateur
    Raybecca
    Main Road Thimbleby
    LN9 5RB Horncastle
    Lincolnshire
    British20885500001

    SHOREPAC LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    An omnibus guarantee and set-off agreement dated
    Créé le 22 mars 2004
    Livré le 25 mars 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling or in a currency or currencies other than sterling;.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 25 mars 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 mai 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    A deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 20 march 2002
    Créé le 18 mai 2003
    Livré le 30 mai 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 30 mai 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 nov. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Single debenture
    Créé le 05 avr. 1993
    Livré le 08 avr. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 08 avr. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 juil. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 02 avr. 1993
    Livré le 09 avr. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Factory premises at warwick road fairfield industrial estate louth lincs and goodwill of the business. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 09 avr. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 nov. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0