SOMERFIELD MERCHANT SERVICES LIMITED

SOMERFIELD MERCHANT SERVICES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSOMERFIELD MERCHANT SERVICES LIMITED
    Statut de la sociétéConverti / Fermé
    Forme juridiqueConverti ou fermé
    Numéro de société 02563625
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de SOMERFIELD MERCHANT SERVICES LIMITED ?

    • (7487) /

    Où se situe SOMERFIELD MERCHANT SERVICES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de SOMERFIELD MERCHANT SERVICES LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    NEW SAXON FARM PRODUCTS LIMITED 29 nov. 199029 nov. 1990

    Quels sont les derniers comptes de SOMERFIELD MERCHANT SERVICES LIMITED ?

    En retardOui
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le04 janv. 2011
    Date d'échéance des prochains comptes04 oct. 2011
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au02 janv. 2010

    Quels sont les derniers dépôts pour SOMERFIELD MERCHANT SERVICES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Certificat d'immatriculation d'une société de secours mutuel

    pagesCERTIPS

    Divers

    Forms b and z to convert to i&ps
    pagesMISC

    Résolutions

    Resolutions
    pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Convert to an i&ps 22/09/2010
    RES13

    État du capital après une attribution d'actions au 22 sept. 2010

    • Capital: GBP 2
    pagesSH01

    État du capital après une attribution d'actions au 22 sept. 2010

    • Capital: GBP 2
    pagesSH01

    Nomination de Stephen Parry en tant que secrétaire

    pagesAP03

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 sept. 2010 avec liste complète des actionnaires

    pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 02 janv. 2010

    pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Timothy Hurrell le 01 août 2010

    pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Stephen Humes le 01 août 2010

    pagesCH01

    Comptes pour une société dormante établis au 02 mai 2009

    pagesAA

    Période comptable actuelle raccourcie du 27 avr. 2010 au 04 janv. 2010

    pagesAA01

    Changement d'adresse du siège social de Somerfield House Whitchurch Lane Bristol BS14 0TJ le 20 nov. 2009

    pagesAD01

    Cessation de la nomination de Emily Martin en tant que secrétaire

    pagesTM02

    Cessation de la nomination de William Robson en tant que directeur

    pagesTM01

    Nomination de Mrs Caroline Jane Sellers en tant que secrétaire

    pagesAP03

    legacy

    pages363a

    legacy

    pages403a

    legacy

    pages288b

    legacy

    pages288a

    legacy

    pages288b

    legacy

    pages288b

    legacy

    pages288a

    legacy

    pages288b

    legacy

    pages288a

    Qui sont les dirigeants de SOMERFIELD MERCHANT SERVICES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    PARRY, Stephen
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    New Century House
    United Kingdom
    Secrétaire
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    New Century House
    United Kingdom
    154306180001
    SELLERS, Caroline Jane
    c/o Governance Dept
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    New Century House
    United Kingdom
    Secrétaire
    c/o Governance Dept
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    New Century House
    United Kingdom
    146968750001
    HUMES, Stephen
    5th Floor, New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    C/O Governance Department
    United Kingdom
    Administrateur
    5th Floor, New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    C/O Governance Department
    United Kingdom
    United KingdomBritishFinance Director84087790001
    HURRELL, Timothy
    5th Floor, New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    C/O Governance Department
    United Kingdom
    Administrateur
    5th Floor, New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    C/O Governance Department
    United Kingdom
    United KingdomBritishGeneral Manager Food Group99724260001
    FAIRCLOUGH, Nicholas Humphrey
    Peckforton Hall
    Peckforton Hall Lane, Peckforton
    CW6 9TH Tarporley
    Cheshire
    Secrétaire
    Peckforton Hall
    Peckforton Hall Lane, Peckforton
    CW6 9TH Tarporley
    Cheshire
    BritishCheshire67981940001
    GRANT, Stephen Martin
    3 Trelawn Court
    Rodney Road
    GL50 1JJ Cheltenham
    Gloucestershire
    Secrétaire
    3 Trelawn Court
    Rodney Road
    GL50 1JJ Cheltenham
    Gloucestershire
    British20888800002
    HAWKINS, Carolynne
    26 Sandhurst Drive
    Aintree
    L10 6LX Liverpool
    Merseyside
    Secrétaire
    26 Sandhurst Drive
    Aintree
    L10 6LX Liverpool
    Merseyside
    British45041470002
    HENSHAW, Stephen Anthony
    Eastleigh Stables
    Bishopstrow
    BA12 9HW Warminster
    Wiltshire
    Secrétaire
    Eastleigh Stables
    Bishopstrow
    BA12 9HW Warminster
    Wiltshire
    BritishCompany Secretary91828160006
    HERON, Beryl Mary
    Flat 5 Beechwood Court
    Maghull
    L31 6EG Liverpool
    Merseyside
    Secrétaire
    Flat 5 Beechwood Court
    Maghull
    L31 6EG Liverpool
    Merseyside
    British20544550001
    MARTIN, Emily Louise
    49 Henley Park
    Yatton
    BS49 4JJ Bristol
    Secrétaire
    49 Henley Park
    Yatton
    BS49 4JJ Bristol
    BritishCompany Secretary115285710001
    BACK, Steven John
    Fennels 119 Bicester Road
    Lower End
    HP18 9EF Long Crendon
    Administrateur
    Fennels 119 Bicester Road
    Lower End
    HP18 9EF Long Crendon
    United KingdomBritishFinance Director85825120001
    BICKERSTAFFE, Katie
    Aston Lodge
    5 Highdale Road
    BS21 7UW Clevedon
    Avon
    Administrateur
    Aston Lodge
    5 Highdale Road
    BS21 7UW Clevedon
    Avon
    BritishCompany Director110621690001
    BOWLER, Graeme John
    10 Curzon Park North
    CH4 8AR Chester
    Cheshire
    Administrateur
    10 Curzon Park North
    CH4 8AR Chester
    Cheshire
    AustralianManaging Dir & Chief Executive36127280002
    CHEYNE, David George Thomson
    The Covert 98 Woodlands Road
    Ashurst
    SO40 7AH Southampton
    Hampshire
    Administrateur
    The Covert 98 Woodlands Road
    Ashurst
    SO40 7AH Southampton
    Hampshire
    BritainBritishCompany Director74956170001
    CLELAND, Jonathan Bradley
    70 Andes Close
    Ocean Village
    SO14 3HS Southampton
    Administrateur
    70 Andes Close
    Ocean Village
    SO14 3HS Southampton
    BritishRetail Director111624590001
    FAIRCLOUGH, Nicholas Humphrey
    Peckforton Hall
    Peckforton Hall Lane, Peckforton
    CW6 9TH Tarporley
    Cheshire
    Administrateur
    Peckforton Hall
    Peckforton Hall Lane, Peckforton
    CW6 9TH Tarporley
    Cheshire
    BritishSolicitor67981940001
    GATTO, Salvatore Martin
    11 Cavendish Lodge
    Cavendish Road
    BA1 2UD Bath
    Avon
    Administrateur
    11 Cavendish Lodge
    Cavendish Road
    BA1 2UD Bath
    Avon
    United KingdomBritishFinance Director37327260002
    GRANT, Stephen Martin
    3 Trelawn Court
    Rodney Road
    GL50 1JJ Cheltenham
    Gloucestershire
    Administrateur
    3 Trelawn Court
    Rodney Road
    GL50 1JJ Cheltenham
    Gloucestershire
    BritishCompany Secretary20888800002
    HENSHAW, Stephen Anthony
    2 Ashton Coombe Lower Road
    Bratton
    BA13 4JQ Westbury
    Wiltshire
    Administrateur
    2 Ashton Coombe Lower Road
    Bratton
    BA13 4JQ Westbury
    Wiltshire
    BritishDirector91828160003
    HERON, Beryl Mary
    Flat 5 Beechwood Court
    Maghull
    L31 6EG Liverpool
    Merseyside
    Administrateur
    Flat 5 Beechwood Court
    Maghull
    L31 6EG Liverpool
    Merseyside
    BritishDirector20544550001
    MASON, Paul
    Moor Lane
    Burley Woodhead
    LS29 7SW Ilkley
    Moorlands
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Moor Lane
    Burley Woodhead
    LS29 7SW Ilkley
    Moorlands
    West Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector141310720001
    MILLS, Fredrick Reginald
    10 Hall Lane
    Connahs Quay
    CH5 4LX Deeside
    Clwyd
    Administrateur
    10 Hall Lane
    Connahs Quay
    CH5 4LX Deeside
    Clwyd
    BritishDeputy Managing Director33349390001
    MOFFAT, Simon Alexander
    11 The Park
    Christleton
    CH3 7AR Chester
    Cheshire
    Administrateur
    11 The Park
    Christleton
    CH3 7AR Chester
    Cheshire
    BritishGroup Finance Director41139540001
    MURPHY, John Conan
    Moor Hall
    Prescot Road
    L39 6RT Ormskirk
    Lancashire
    Administrateur
    Moor Hall
    Prescot Road
    L39 6RT Ormskirk
    Lancashire
    BritishCompany Director80004900001
    OAKES, Martin Nicholas
    Oakhurst House
    Fulready, Ettington
    CV37 7PE Stratford-Upon-Avon
    Warwickshire
    Administrateur
    Oakhurst House
    Fulready, Ettington
    CV37 7PE Stratford-Upon-Avon
    Warwickshire
    United KingdomBritishLogistics Director86206380002
    PRETTY, Derek William Methven
    18 Richmond Hill
    Clifton
    BS8 1BA Bristol
    Avon
    Administrateur
    18 Richmond Hill
    Clifton
    BS8 1BA Bristol
    Avon
    United KingdomBritishFinancial Executive65944140001
    ROBSON, William Henry Mark
    12 Kimble Close
    Knightcote
    CV47 2SJ Southam
    Warwickshire
    Administrateur
    12 Kimble Close
    Knightcote
    CV47 2SJ Southam
    Warwickshire
    EnglandBritishFinance Director57803420002
    SEABROOK, Graeme
    29 Curzon Park South
    CH4 8AA Chester
    Cheshire
    Administrateur
    29 Curzon Park South
    CH4 8AA Chester
    Cheshire
    AustralianChief Executive3911900001
    SMITH, Colin George
    Tallius
    Jubilee Road, Finchampstead
    RG40 3SR Wokingham
    Berkshire
    Administrateur
    Tallius
    Jubilee Road, Finchampstead
    RG40 3SR Wokingham
    Berkshire
    BritishDirector111628890001

    SOMERFIELD MERCHANT SERVICES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Supplemental debenture
    Créé le 06 mars 2006
    Livré le 14 mars 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to any senior creditor and any pik creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC (Security Agent)
    Transactions
    • 14 mars 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 juin 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 23 déc. 2005
    Livré le 05 janv. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to any rcf creditor under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 05 janv. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 juil. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    A target group debenture
    Créé le 23 déc. 2005
    Livré le 28 déc. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to any senior creditor and any pik creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland (The Security Agent)
    Transactions
    • 28 déc. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 juin 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0