KM REALISATIONS (2009) LIMITED

KM REALISATIONS (2009) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéKM REALISATIONS (2009) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02567238
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de KM REALISATIONS (2009) LIMITED ?

    • (5242) /
    • (9231) /

    Où se situe KM REALISATIONS (2009) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Hill House
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de KM REALISATIONS (2009) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    KAREN MILLEN LIMITED10 janv. 199110 janv. 1991
    OVAL (676) LIMITED10 déc. 199010 déc. 1990

    Quels sont les derniers comptes de KM REALISATIONS (2009) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au26 janv. 2008

    Quels sont les derniers dépôts pour KM REALISATIONS (2009) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Avis de transition de l'administration à la dissolution le 30 nov. 2011

    27 pages2.35B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 01 mars 2011

    21 pages2.24B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 01 sept. 2011

    21 pages2.24B

    Avis de prolongation de la période de l'administration

    1 pages2.31B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 01 sept. 2010

    28 pages2.24B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 01 sept. 2010

    22 pages2.24B

    Avis de prolongation de la période de l'administration

    1 pages2.31B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 01 mars 2010

    45 pages2.24B

    Avis de prolongation de la période de l'administration

    1 pages2.31B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 01 sept. 2009

    19 pages2.24B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 01 sept. 2009

    17 pages2.24B

    Certificat de changement de nom

    Company name changed karen millen LIMITED\certificate issued on 01/09/09
    2 pagesCERTNM

    Déclaration des affaires avec le formulaire 2.14B

    16 pages2.16B

    Déclaration de la proposition de l'administrateur

    33 pages2.17B

    legacy

    1 pages287

    legacy

    5 pages395

    Nomination d'un administrateur

    1 pages2.12B

    Comptes annuels établis au 26 janv. 2008

    21 pagesAA

    legacy

    1 pages288c

    Comptes annuels établis au 27 janv. 2007

    21 pagesAA

    legacy

    8 pages395

    legacy

    6 pages363a

    legacy

    2 pages403b

    legacy

    2 pages403b

    Qui sont les dirigeants de KM REALISATIONS (2009) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    GLANVILLE, Richard Spencer
    Babshole Farm
    Sudburys Farm Road
    CM12 9SP Little Burstead
    Essex
    Secrétaire
    Babshole Farm
    Sudburys Farm Road
    CM12 9SP Little Burstead
    Essex
    British69669910005
    WILKS, Jessica
    1 Forge Cottages
    High Street
    RH8 0DT Limpsfield
    Surrey
    Secrétaire
    1 Forge Cottages
    High Street
    RH8 0DT Limpsfield
    Surrey
    British116562380001
    GLANVILLE, Richard Spencer
    Babshole Farm
    Sudburys Farm Road
    CM12 9SP Little Burstead
    Essex
    Administrateur
    Babshole Farm
    Sudburys Farm Road
    CM12 9SP Little Burstead
    Essex
    United KingdomBritish69669910005
    LOVELOCK, Derek John
    Oldfields Farm
    Amersham Road
    HP9 2UG Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Oldfields Farm
    Amersham Road
    HP9 2UG Beaconsfield
    Buckinghamshire
    EnglandBritish116560620001
    LUSTMAN, Margaret Eve
    Exeter Road
    NW2 4SE London
    49
    Administrateur
    Exeter Road
    NW2 4SE London
    49
    EnglandBritish40930620002
    SHEARWOOD, Mike
    Upton Fields House
    Upton Road
    NG25 0QA Southwell
    Nottinghamshire
    Administrateur
    Upton Fields House
    Upton Road
    NG25 0QA Southwell
    Nottinghamshire
    EnglandBritish95093740001
    LAMBERT, Roy Jefferson
    6 Middle Street
    EC1A 7JA London
    Secrétaire
    6 Middle Street
    EC1A 7JA London
    British7959460002
    SHARMA, Sanjib
    Apartment A609 The Jam Factory
    27 Green Walk
    SE1 4TU London Bridge
    London
    Secrétaire
    Apartment A609 The Jam Factory
    27 Green Walk
    SE1 4TU London Bridge
    London
    British111733770001
    STANFORD, Kevin Gerald
    The Dower House
    Royden Hall Road
    TN12 5NH East Peckham
    Kent
    Secrétaire
    The Dower House
    Royden Hall Road
    TN12 5NH East Peckham
    Kent
    British83560040001
    GOLDSBROUGH, Sandy
    Loft 3 Building 7
    30-32 Shepherdess Walk
    N1 7LB London
    Administrateur
    Loft 3 Building 7
    30-32 Shepherdess Walk
    N1 7LB London
    British113880110001
    MILLEN, Karen Denise
    243-245 The Lodge
    Tonbridge Road
    ME18 5PA Wateringbury Nr Kent
    Kent
    Administrateur
    243-245 The Lodge
    Tonbridge Road
    ME18 5PA Wateringbury Nr Kent
    Kent
    United KingdomBritish141602700001
    SAMUEL, Nicholas Michael
    133 Saint Josephs Vale
    SE3 0XQ London
    Administrateur
    133 Saint Josephs Vale
    SE3 0XQ London
    British78875220001
    SHARMA, Sanjib
    Apartment A609 The Jam Factory
    27 Green Walk
    SE1 4TU London Bridge
    London
    Administrateur
    Apartment A609 The Jam Factory
    27 Green Walk
    SE1 4TU London Bridge
    London
    British111733770001
    SIGURDSSON, Gunnar
    4 Greenlink Walk
    Kew Riverside
    TW9 4AF Richmond Upon Thames
    London
    Administrateur
    4 Greenlink Walk
    Kew Riverside
    TW9 4AF Richmond Upon Thames
    London
    EnglandIcelandic114179720001
    STANFORD, Kevin Gerald
    The Dower House
    Royden Hall Road
    TN12 5NH East Peckham
    Kent
    Administrateur
    The Dower House
    Royden Hall Road
    TN12 5NH East Peckham
    Kent
    United KingdomBritish83560040001

    KM REALISATIONS (2009) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Deed of charge over credit balances
    Créé le 26 févr. 2009
    Livré le 13 mars 2009
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Barclays bank PLC re karen millen limited business premium account a/n 73087859, euro current account a/n 55407599, euro business premium account a/n 42498555 the charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) & the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon. It also creates an assignment by the chargor for the purposes of & to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) & interest thereon.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 13 mars 2009Enregistrement d'une charge (395)
    Charge on shares
    Créé le 14 mars 2008
    Livré le 27 mars 2008
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any group company to the chargee and/or the other finance parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The shares, the derivative assets; all dividends see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Kaupthing Bank Hf. (As Security Trustee for the Finance Parties)(in Such Capacity, the Security Trustee)
    Transactions
    • 27 mars 2008Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 28 déc. 2007
    Livré le 05 janv. 2008
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any group company to the security trustee and/or the other financial parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Kaupthing Bank Hf (Security Trustee)
    Transactions
    • 05 janv. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 31 janv. 2008Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    Amendment agreement to a charge on shares dated 12 october 2006
    Créé le 21 mai 2007
    Livré le 23 mai 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any group company to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The shares, the derivative assets, all dividends interest and other income deriving from any stocks shares or other securities and all moneys income and amounts from all or any part of the shares or T. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Kaupthing Bank Hf (As Security Trustee for the Secured Parties) (in Such Capacity the Securitytrustee)
    Transactions
    • 23 mai 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Charge on shares
    Créé le 12 oct. 2006
    Livré le 21 oct. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any group company to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The shares the derivative assets all dividends. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Kaupthing Bank Hf (As Security Trustee for the Secured Parties) the Security Trustee
    Transactions
    • 21 oct. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 12 oct. 2006
    Livré le 21 oct. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any group company to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Kaupthing Bank Hf. (As Security Trustee for the Secured Parties) (the "Security Trustee")
    Transactions
    • 21 oct. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 31 janv. 2008Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    Share pledge agreement
    Créé le 27 juil. 2004
    Livré le 11 août 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the security trustee, and/or the security beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Pursuant to the share pledge, the pledgor pledged under the belgian act of 5 may 1872 to the pledgee by way of first ranking pledge as security for the due performance of the secured liabilities, the shares, together with the other pledged assets;. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (Acting as Security Trustee)
    Transactions
    • 11 août 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 oct. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Supplemental deed to the composite guarantee and debenture dated 15 november 2003
    Créé le 25 juin 2004
    Livré le 07 juil. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each charging company to the security trustee and/or the security beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The Security Trustee)
    Transactions
    • 07 juil. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 oct. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 28 oct. 2003
    Livré le 07 nov. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H premises unit 4, the barkers centre, kensington high street, london.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 07 nov. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 31 juil. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of assignment
    Créé le 28 oct. 2003
    Livré le 07 nov. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Th registered trade marks being, mark: press & bastyan, no: 2103182, class: 25, and the full benefit of all rights and remedies of the company. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 07 nov. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 31 juil. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee & debenture
    Créé le 28 oct. 2003
    Livré le 31 oct. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company or karen millen holdings limited or press & bastyan limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Kaupthing Bank Hf
    Transactions
    • 31 oct. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 31 juil. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 25 juil. 2002
    Livré le 09 août 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 09 août 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 août 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee & debenture
    Créé le 29 avr. 2002
    Livré le 07 mai 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 07 mai 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 31 juil. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 05 nov. 1998
    Livré le 07 nov. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 07 nov. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 nov. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 22 févr. 1996
    Livré le 24 févr. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Basement ground and first floors of 17 - 19 neal street london WC2 benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating to the property any shares or membership rights in ant management company for the property any goodwill of any business at the property any rental and other money payable and all other payments whatever. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 24 févr. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 sept. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 05 févr. 1996
    Livré le 13 févr. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/Hold property - unit 4 barkers arcade high st,kensington,london W.8 with all fixtures/fittings; the goodwill of business and all rights/licences.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 13 févr. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 sept. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed and floating charge
    Créé le 24 août 1995
    Livré le 31 août 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 31 août 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 nov. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage of keyman insurance policy
    Créé le 28 juin 1993
    Livré le 07 juil. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    The benefit of the policey insurance dated 28/06/93 no 14B 75J60 with J.rothschild assurance in the amount of £1000000.
    Personnes ayant droit
    • Aitken Hume Bank PLC
    Transactions
    • 07 juil. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 janv. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed and floating charge
    Créé le 11 juin 1993
    Livré le 25 juin 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the facility letter and/or this charge
    Brèves mentions
    Unit 7 barkers kensington high street london together with all fixtures and fittings and all right title estates and all stocks shares and other securities together with all dividends and a floating charge over the companys undertaking and all its assets and the goodwill of the business.
    Personnes ayant droit
    • Aitken Hume Bank PLC
    Transactions
    • 25 juin 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 févr. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed and floating charge
    Créé le 16 nov. 1992
    Livré le 19 nov. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 19 nov. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 juin 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    KM REALISATIONS (2009) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    02 mars 2009Administration started
    30 nov. 2011Administration ended
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Philip Stephen Bowers
    Po Box 810, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    practitioner
    Po Box 810, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Neville Barry Khan
    Po Box 810, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    practitioner
    Po Box 810, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Lee Antony Manning
    Po Box 810, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    practitioner
    Po Box 810, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0