FFASTFILL F D LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéFFASTFILL F D LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02571397
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de FFASTFILL F D LIMITED ?

    • Développement de logiciels professionnels et grand public (62012) / Information et communication

    Où se situe FFASTFILL F D LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Level 26 30 St. Mary Axe
    EC3A 8EP London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de FFASTFILL F D LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    FUTURE DYNAMICS LIMITED19 oct. 199919 oct. 1999
    GLOBAL ONE TECHNOLOGY LIMITED10 sept. 199910 sept. 1999
    RESOLUTION SQL LIMITED23 oct. 199123 oct. 1991
    CHOQS 220 LIMITED03 janv. 199103 janv. 1991

    Quels sont les derniers comptes de FFASTFILL F D LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2013

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour FFASTFILL F D LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour FFASTFILL F D LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 27 mai 2015

    • Capital: GBP 0.000005
    4 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Satisfaction de la charge 3 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 5 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 6 en totalité

    1 pagesMR04

    Déclaration annuelle jusqu'au 14 déc. 2014 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital24 déc. 2014

    État du capital au 24 déc. 2014

    • Capital: GBP 597.4051
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Thomas Keith Todd le 01 déc. 2014

    2 pagesCH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2013

    5 pagesAA

    Cessation de la nomination de Mark Andrew Russell Carlisle en tant que directeur le 02 sept. 2014

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Mark Andrew Carlisle en tant que secrétaire le 02 sept. 2014

    1 pagesTM02

    Déclaration annuelle jusqu'au 14 déc. 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital08 janv. 2014

    État du capital au 08 janv. 2014

    • Capital: GBP 597.4051
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2013

    6 pagesAA

    Période comptable actuelle raccourcie du 31 mars 2014 au 31 déc. 2013

    1 pagesAA01

    Cessation de la nomination de Hamish Purdey en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Changement d'adresse du siège social de * 35 Vine Street London EC3N 2AA* le 30 juil. 2013

    1 pagesAD01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2012

    7 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 14 déc. 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Hamish John Purdey le 14 déc. 2012

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Thomas Keith Todd le 14 déc. 2012

    2 pagesCH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 14 déc. 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Qui sont les dirigeants de FFASTFILL F D LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    TODD, Thomas Keith
    30 St. Mary Axe
    EC3A 8EP London
    Level 26
    Administrateur
    30 St. Mary Axe
    EC3A 8EP London
    Level 26
    EnglandBritish74302420002
    BARTLETT, Aidan
    15 Garrett Road
    Finchampstead
    RG40 4RX Wokingham
    Berkshire
    Secrétaire
    15 Garrett Road
    Finchampstead
    RG40 4RX Wokingham
    Berkshire
    British67529020001
    CARLISLE, Mark Andrew
    30 St. Mary Axe
    EC3A 8EP London
    Level 26
    England
    Secrétaire
    30 St. Mary Axe
    EC3A 8EP London
    Level 26
    England
    161936460001
    COLCOMBE, Paul Andrew
    Scotch Firs
    GL2 3SW Longney
    Gloucestershire
    Secrétaire
    Scotch Firs
    GL2 3SW Longney
    Gloucestershire
    British100860410001
    GROB, Stephen Paul
    10 Elgin Place
    St Georges Avenue
    KT13 0BE Weybridge
    Surrey
    Secrétaire
    10 Elgin Place
    St Georges Avenue
    KT13 0BE Weybridge
    Surrey
    British25855270004
    HARRISON, Caroline Ruth
    111 East Park Farm Drive
    RG10 9UQ Charvil
    Berkshire
    Secrétaire
    111 East Park Farm Drive
    RG10 9UQ Charvil
    Berkshire
    British73990210001
    KNOWLES, Stephen Nicholas
    41 Prospect Road
    Southborough
    TN4 0EH Tunbridge Wells
    Kent
    Secrétaire
    41 Prospect Road
    Southborough
    TN4 0EH Tunbridge Wells
    Kent
    British22152590001
    SYMONS, Kenneth Geoffrey Alan
    107 The Grove
    BR4 9LA West Wickham
    Kent
    Secrétaire
    107 The Grove
    BR4 9LA West Wickham
    Kent
    British2786950001
    BARTLETT, Aidan
    15 Garrett Road
    Finchampstead
    RG40 4RX Wokingham
    Berkshire
    Administrateur
    15 Garrett Road
    Finchampstead
    RG40 4RX Wokingham
    Berkshire
    British67529020001
    BROWN, Gerald Frank
    Crossways
    1 Wolseley Road
    GU7 3DX Godalming
    Surrey
    Administrateur
    Crossways
    1 Wolseley Road
    GU7 3DX Godalming
    Surrey
    British66855310002
    CARLISLE, Mark Andrew Russell
    30 St. Mary Axe
    EC3A 8EP London
    Level 26
    England
    Administrateur
    30 St. Mary Axe
    EC3A 8EP London
    Level 26
    England
    United KingdomBritish161119690001
    CATHERALL, Michael James
    21 Julian Road
    BR6 6HT Chelsfield
    Kent
    Administrateur
    21 Julian Road
    BR6 6HT Chelsfield
    Kent
    British93906500001
    FARRANT, Mervyn John
    1 Suckley Road
    Leigh
    WR6 5LE Worcester
    Worcestershire
    Administrateur
    1 Suckley Road
    Leigh
    WR6 5LE Worcester
    Worcestershire
    British36402210001
    FARRANT, Mervyn John
    1 Suckley Road
    Leigh
    WR6 5LE Worcester
    Worcestershire
    Administrateur
    1 Suckley Road
    Leigh
    WR6 5LE Worcester
    Worcestershire
    British36402210001
    GILBOY, Stefan Martin
    12 Barn Lane
    Oakley
    RG23 7HT Basingstoke
    Hampshire
    Administrateur
    12 Barn Lane
    Oakley
    RG23 7HT Basingstoke
    Hampshire
    British2179640002
    GROB, Stephen Paul
    10 Elgin Place
    St Georges Avenue
    KT13 0BE Weybridge
    Surrey
    Administrateur
    10 Elgin Place
    St Georges Avenue
    KT13 0BE Weybridge
    Surrey
    British25855270004
    HARTNELL, Nigel Raymond
    7 North Avenue
    Ealing
    W13 8AP London
    Administrateur
    7 North Avenue
    Ealing
    W13 8AP London
    EnglandBritish13121930001
    HAVERS, Simon William
    Mint House
    77 Mansell Street
    E1 8AF London
    Administrateur
    Mint House
    77 Mansell Street
    E1 8AF London
    United KingdomBritish53426230002
    HIPPERSON, James Joseph
    3 Eagles Drive
    Tatsfield
    TN16 2PB Westerham
    Kent
    Administrateur
    3 Eagles Drive
    Tatsfield
    TN16 2PB Westerham
    Kent
    British21157140001
    KNOWLES, Stephen Nicholas
    41 Prospect Road
    Southborough
    TN4 0EH Tunbridge Wells
    Kent
    Administrateur
    41 Prospect Road
    Southborough
    TN4 0EH Tunbridge Wells
    Kent
    United KingdomBritish22152590001
    MADDOX, Carolyn Lucy
    40 Belitha Villas
    N1 1PD London
    Administrateur
    40 Belitha Villas
    N1 1PD London
    United KingdomBritish54184630001
    PURDEY, Hamish John
    30 St. Mary Axe
    EC3A 8EP London
    Level 26
    England
    Administrateur
    30 St. Mary Axe
    EC3A 8EP London
    Level 26
    England
    United KingdomAustralian,British137529190002
    ROSA, Antonio Andrade
    4 Old House Close
    Church Road Wimbledon Village
    SW19 5AW London
    Administrateur
    4 Old House Close
    Church Road Wimbledon Village
    SW19 5AW London
    British35818700001
    SYMONS, Kenneth Geoffrey Alan
    The Park Beckenham Place Park
    BR3 2BS Beckenham
    Kent
    Administrateur
    The Park Beckenham Place Park
    BR3 2BS Beckenham
    Kent
    British2786950002

    FFASTFILL F D LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Mortgage debenture
    Créé le 18 avr. 2001
    Livré le 24 avr. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies and liabilities due owing or incurred from the company to the noteholder pursuant to or in respect of the guarantee granted by the company in favour of the noteholder of even date pursuant to which the company has inter alia guaranteed to pay the noteholder any amounts due to the noteholder under or in connection with a loan instrument made by the company's parent company future dynamics holdings limited relating to the issue of secured series "c" loan notes dated 7 february 2001 and a loan note instrument made by the company's parent company future dynamics holdings limited relating to the issue of series "d" loan notes dated 7 february 2001 (and any loan notes certificate issued pursuant to either of their respective terms) or pursuant to the terms of the mortgage debenture
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • European Financial Services Venture Fund Limited General Partner of Theeuropean Financial Services Venture Fund Comprising the European Financial Services Venture Fund Limited Partnerships (No.1 and No. 2)
    Transactions
    • 24 avr. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 janv. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 28 févr. 2000
    Livré le 03 mars 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 03 mars 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 janv. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Security deposit deed supplemental to a lease dated 4 february 2000
    Créé le 04 févr. 2000
    Livré le 19 févr. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £27,692 due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    £27,762.
    Personnes ayant droit
    • London Life Limited
    Transactions
    • 19 févr. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 avr. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Security deposit deed
    Créé le 04 févr. 2000
    Livré le 09 févr. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a lease of even date
    Brèves mentions
    Initial deposit of £27,692. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • London Life Limited
    Transactions
    • 09 févr. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 avr. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Mortgage debenture
    Créé le 15 déc. 1999
    Livré le 18 déc. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or in connection with a guarantee dated 15 december 1999 or pursuant to the terms of the mortgage debenture
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barings (Guernsey) Limited(as Trustee for the Fifth Abn Amro Causeway Development Capital Fund)
    Transactions
    • 18 déc. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 janv. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Rent deposit deed
    Créé le 02 mars 1998
    Livré le 02 mars 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the rent deposit deed
    Brèves mentions
    The tenants interest under their respective leases the deposit sum of £12,000 and all interest earned on the deposit.
    Personnes ayant droit
    • Ambergrange Limited
    Transactions
    • 02 mars 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 avr. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Guarantee and debenture
    Créé le 30 juin 1995
    Livré le 12 juil. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 12 juil. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 févr. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed and floating charge
    Créé le 24 oct. 1991
    Livré le 30 oct. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    (A) a first fixed legal charge on all the present freehold and leasehold properties of the barrower (plsease see doc M395 ref M99 c for full details).
    Personnes ayant droit
    • Resolution Systems PLC
    Transactions
    • 30 oct. 1991Enregistrement d'une charge
    • 07 juil. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0