BLAF (NO. 10) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéBLAF (NO. 10) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02577579
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de BLAF (NO. 10) LIMITED ?

    • Crédit-bail (64910) / Activités financières et d'assurance

    Où se situe BLAF (NO. 10) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Hill House
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de BLAF (NO. 10) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2012

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour BLAF (NO. 10) LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour BLAF (NO. 10) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    4 pages4.71

    Résolution d'insolvabilité

    Resolution insolvency:res re liquidator's account
    1 pagesLIQ MISC RES

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de 1 Churchill Place London E14 5HP

    2 pagesAD02

    Changement d'adresse du siège social de * Churchill Plaza Churchill Way Basingstoke Hampshire RG21 7GP* le 08 août 2013

    2 pagesAD01

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    2 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation

    LRESSP

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2012

    26 pagesAA

    Période comptable précédente raccourcie du 24 mai 2013 au 31 déc. 2012

    1 pagesAA01

    Comptes annuels établis au 24 mai 2012

    27 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 janv. 2013 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital17 janv. 2013

    État du capital au 17 janv. 2013

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Période comptable précédente raccourcie du 31 déc. 2012 au 24 mai 2012

    1 pagesAA01

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2011

    26 pagesAA

    Cessation de la nomination de Thomas Geoffrey Ridout en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 janv. 2012 avec liste complète des actionnaires

    8 pagesAR01

    Cessation de la nomination de Darren Hare en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2010

    25 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 janv. 2011 avec liste complète des actionnaires

    8 pagesAR01

    Nomination de Thomas Geoffrey Ridout en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination d'un directeur

    1 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de BLAF (NO. 10) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BARCOSEC LIMITED
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Secrétaire
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    49004930002
    LEATHER, Jonathan Terence
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Administrateur
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    EnglandBritish69140360004
    ROWBERRY, Duncan John
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Administrateur
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    EnglandBritish49237880004
    WATSON, Hazel Anne Marie
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Administrateur
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    EnglandIrish122291210001
    MCMILLAN, Richard John
    17 Hawthorn Close
    Colden Common
    SO21 1UX Winchester
    Hampshire
    Secrétaire
    17 Hawthorn Close
    Colden Common
    SO21 1UX Winchester
    Hampshire
    British68601920001
    SHOOLBRED, Charles Frederick
    Timbers
    Dean Oak Lane
    RH2 8PZ Leigh
    Surrey
    Secrétaire
    Timbers
    Dean Oak Lane
    RH2 8PZ Leigh
    Surrey
    British540290002
    ABLITT, Denis Raymond
    Woodcocks
    38 Park Avenue, Old Basing
    RG24 7HT Basingstoke
    Hampshire
    Administrateur
    Woodcocks
    38 Park Avenue, Old Basing
    RG24 7HT Basingstoke
    Hampshire
    British71782000001
    BOOBYER, Christopher Leslie Richard
    54 Lombard Street
    EC3P 3AH London
    Administrateur
    54 Lombard Street
    EC3P 3AH London
    British92233050001
    BOX, Sarah
    Court Lodge Lower Road
    West Farleigh
    ME15 0PD Maidstone
    Kent
    Administrateur
    Court Lodge Lower Road
    West Farleigh
    ME15 0PD Maidstone
    Kent
    British47381630004
    CALLENDER, John Dalrymple
    Fairway Heights
    GU15 1NJ Camberley
    14
    Surrey
    Administrateur
    Fairway Heights
    GU15 1NJ Camberley
    14
    Surrey
    United KingdomBritish2444200001
    CLARK, Thomas Martin
    Hatch Hill Hatch Lane
    Kingsley Green
    GU27 3LJ Haslemere
    Surrey
    Administrateur
    Hatch Hill Hatch Lane
    Kingsley Green
    GU27 3LJ Haslemere
    Surrey
    British5529800001
    DOWDING, Eric Robert
    23 Waldorf Heights
    Blackwater Howley Hill
    GU17 9JH Camberley
    Surrey
    Administrateur
    23 Waldorf Heights
    Blackwater Howley Hill
    GU17 9JH Camberley
    Surrey
    British46728970001
    ELLIS, David James
    Batts Row Cottage
    Laverstoke Lane, Laverstoke
    RG28 7PA Whitchurch
    Hampshire
    Administrateur
    Batts Row Cottage
    Laverstoke Lane, Laverstoke
    RG28 7PA Whitchurch
    Hampshire
    EnglandBritish113760650001
    EVANS, Christopher Hewitt
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Administrateur
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    British121774150001
    HARE, Darren Mark
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    Administrateur
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    United KingdomBritish127470250001
    HILLS, Richard Allan
    11 Countess Gardens
    Littledown
    BH7 7RR Bournemouth
    Dorset
    Administrateur
    11 Countess Gardens
    Littledown
    BH7 7RR Bournemouth
    Dorset
    United KingdomBritish71778800001
    MACINTOSH, Gordon Paterson
    7 Paddock Field
    Chilbolton
    SO20 6AU Stockbridge
    Hampshire
    Administrateur
    7 Paddock Field
    Chilbolton
    SO20 6AU Stockbridge
    Hampshire
    British25737780001
    MCMILLAN, Richard John
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Administrateur
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    British68601920003
    MILES, Martin Graham
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Administrateur
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    United KingdomBritish108439150001
    RIDOUT, Thomas Geoffrey
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    Administrateur
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    EnglandBritish155056490001
    ROSE, Stephen George
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Administrateur
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    British143870380001
    ROWAN, Charles Paul
    32 Queens Park West Drive
    Queens Park
    BH8 9DD Bournemouth
    Dorset
    Administrateur
    32 Queens Park West Drive
    Queens Park
    BH8 9DD Bournemouth
    Dorset
    British49237910001
    SILCOCK, Frank Avis
    Charleston 74 Wellhouse Road
    Beech
    GU34 4AG Alton
    Hampshire
    Administrateur
    Charleston 74 Wellhouse Road
    Beech
    GU34 4AG Alton
    Hampshire
    British32895910001
    WEAL, Barry
    Orchard Gate
    Mill Lane Bramley
    GU5 0HW Guildford
    Surrey
    Administrateur
    Orchard Gate
    Mill Lane Bramley
    GU5 0HW Guildford
    Surrey
    British40203100001
    WEAVING, John Martin
    57 Bridle Way
    Colehill
    BH21 2UP Wimborne
    Dorset
    Administrateur
    57 Bridle Way
    Colehill
    BH21 2UP Wimborne
    Dorset
    British58523120001
    BARCOSEC LIMITED
    54 Lombard Street
    EC3P 3AH London
    Administrateur
    54 Lombard Street
    EC3P 3AH London
    49004930001
    BAROMETERS LIMITED
    54 Lombard Street
    EC3P 3AH London
    Administrateur
    54 Lombard Street
    EC3P 3AH London
    57357300002

    BLAF (NO. 10) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A first priority norwegian mortgage
    Créé le 06 févr. 2003
    Livré le 20 févr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The norwegian registered vessel M.V. 'jo sequoia' (ex hull no. 141 at kleven floro) and all euqipment and appurtenances.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Intermediate Leasing (UK) Limited
    Transactions
    • 20 févr. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 mai 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Deed of covenant
    Créé le 06 févr. 2003
    Livré le 18 févr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All rights,title,benefit and interest in and to insurances of M.V."jo sequoia",hull no 141 at kleven floro and all sums of money payable thereon and proceeds of any policy or contract. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Intermediate Leasing (UK) Limited
    Transactions
    • 18 févr. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 mai 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Assignment of builder's warranties
    Créé le 05 févr. 2003
    Livré le 24 févr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All the company's rights title and interest in the warranties.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Intermediate Leasing (UK) LTD
    Transactions
    • 24 févr. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 mai 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Lessor proceeds account assignment
    Créé le 05 févr. 2003
    Livré le 18 févr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All rights,title and interest in and to the interest bearing dollar account of the company with union bank of norway designated "jo sequoia-dollar proceeds account",acct/no 8210.04.04385. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Intermediate Leasing (UK) Limited
    Transactions
    • 18 févr. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 mai 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)

    BLAF (NO. 10) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    30 juil. 2013Commencement of winding up
    30 juin 2014Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Stephen Roland Browne
    Athene Place
    66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    practitioner
    Athene Place
    66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    Christopher Richard Frederick Day
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    practitioner
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0