WOODCHESTER EQUIPMENT FINANCE LIMITED

WOODCHESTER EQUIPMENT FINANCE LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéWOODCHESTER EQUIPMENT FINANCE LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02579337
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de WOODCHESTER EQUIPMENT FINANCE LIMITED ?

    • (6521) /

    Où se situe WOODCHESTER EQUIPMENT FINANCE LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Mulberry House
    53 Church Street
    KT13 8DJ Weybridge
    Surrey
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de WOODCHESTER EQUIPMENT FINANCE LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    SUMMIT LEASE FINANCE (NO.3) LIMITED22 mai 199122 mai 1991
    TRUSHELFCO (NO. 1685) LIMITED01 févr. 199101 févr. 1991

    Quels sont les derniers comptes de WOODCHESTER EQUIPMENT FINANCE LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2007

    Quels sont les derniers dépôts pour WOODCHESTER EQUIPMENT FINANCE LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    3 pages4.71

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    1 pages287

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 20 févr. 2009

    LRESSP

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    4 pages363a

    legacy

    1 pages288a

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2007

    11 pagesAA

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    4 pages363a

    legacy

    1 pages288a

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2006

    12 pagesAA

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    3 pages288a

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    1 pages288b

    Qui sont les dirigeants de WOODCHESTER EQUIPMENT FINANCE LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    ESSEX, Alicia
    Meadowview
    21 Meadowside
    KT12 3LS Walton On Thames
    Surrey
    Secrétaire
    Meadowview
    21 Meadowside
    KT12 3LS Walton On Thames
    Surrey
    British55569560002
    BARR, Ciaran Joseph
    256a Sutton Park
    IRISH Dublin
    Ireland
    Administrateur
    256a Sutton Park
    IRISH Dublin
    Ireland
    Irish115548940001
    MCGIBBON, William Hall
    Marina Place
    Hampton Wick
    KT1 4BH Kingston Upon Thames
    53
    Surrey
    England
    Administrateur
    Marina Place
    Hampton Wick
    KT1 4BH Kingston Upon Thames
    53
    Surrey
    England
    United KingdomBritish131612680004
    GREGORY, Janet Ailsa
    Eastwood Lodge
    Whitfield
    GL12 8EA Wotton Under Edge
    Gloucestershire
    Secrétaire
    Eastwood Lodge
    Whitfield
    GL12 8EA Wotton Under Edge
    Gloucestershire
    British54836580002
    LAWRENCE, William Sackville Gwynne
    7 Byam Street
    SW6 2RB London
    Secrétaire
    7 Byam Street
    SW6 2RB London
    British32571030001
    RYAN, Gerard Jude
    47 Kingsmead Road
    Tulse Hill
    SW2 3HY London
    Secrétaire
    47 Kingsmead Road
    Tulse Hill
    SW2 3HY London
    Irish32962580001
    TRUSEC LIMITED
    35 Basinghall Street
    EC2V 5DB London
    Secrétaire désigné
    35 Basinghall Street
    EC2V 5DB London
    900007200001
    BABER, Jeremy David
    94 Candwr Park
    Ponthir
    NP18 1HN Newport
    Gwent
    Administrateur
    94 Candwr Park
    Ponthir
    NP18 1HN Newport
    Gwent
    British109606970001
    BARRATT, Simon James Knevett
    33 Stadium Street
    SW10 0PU London
    Administrateur
    33 Stadium Street
    SW10 0PU London
    British25864760002
    BRAMHALL, John Robert
    11 Stoke Hill
    Stoke Bishop
    BS9 1JL Bristol
    Administrateur
    11 Stoke Hill
    Stoke Bishop
    BS9 1JL Bristol
    British1020270002
    CHANDLER, Christine Anne
    31 Chesnut Grove
    New Malden
    Surrey
    Administrateur désigné
    31 Chesnut Grove
    New Malden
    Surrey
    British900007180001
    DHALIWAL, Harminder
    5 Watson Close
    RG40 4YF Wokingham
    Berkshire
    Administrateur
    5 Watson Close
    RG40 4YF Wokingham
    Berkshire
    British80423030001
    ELLIS, Christopher
    12 Lattimer Place
    Chiswick
    W4 2UA London
    Administrateur
    12 Lattimer Place
    Chiswick
    W4 2UA London
    British52013970001
    FIELDEN, David Shaw
    Kingsfield
    Old Midford Road
    BA2 7DH Bath
    Administrateur
    Kingsfield
    Old Midford Road
    BA2 7DH Bath
    EnglandBritish8502310001
    GANE, Peter Anthony
    Herb Cottage 5 Red Pitt
    Dilton Marsh
    BA13 4BJ Westbury
    Wiltshire
    Administrateur
    Herb Cottage 5 Red Pitt
    Dilton Marsh
    BA13 4BJ Westbury
    Wiltshire
    British81248280001
    GIRARD, Sylvain Andre
    9 Redcliffe Gardens
    66 Grove Park Road
    W4 London
    Administrateur
    9 Redcliffe Gardens
    66 Grove Park Road
    W4 London
    EnglandCanadian85777970002
    GREEN, Richard William
    Sandy Lane
    Sunningdale
    SL5 OND Ascot
    Richborough House
    Berkshire
    Uk
    Administrateur
    Sandy Lane
    Sunningdale
    SL5 OND Ascot
    Richborough House
    Berkshire
    Uk
    British121346530001
    GREEN, Robert
    Tavistock
    Christ Church Road
    GU25 4PT Virginia Water
    Surrey
    Administrateur
    Tavistock
    Christ Church Road
    GU25 4PT Virginia Water
    Surrey
    American79378980001
    GREGORY, Janet Ailsa
    Eastwood Lodge
    Whitfield
    GL12 8EA Wotton Under Edge
    Gloucestershire
    Administrateur
    Eastwood Lodge
    Whitfield
    GL12 8EA Wotton Under Edge
    Gloucestershire
    British54836580002
    HARROLD, Alan Henry
    Cherry Tree House
    The Drive
    SL8 5RE Bourne End
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Cherry Tree House
    The Drive
    SL8 5RE Bourne End
    Buckinghamshire
    EnglandBritish88772110001
    HEUVEL, Christopher Edward Francis Van Den
    7 Hawkes Leap
    GU20 6JL Windlesham
    Surrey
    Administrateur
    7 Hawkes Leap
    GU20 6JL Windlesham
    Surrey
    British14296970001
    HURST, Martin Peter
    18 The Lawns
    Gotherington
    GL52 9QT Cheltenham
    Gloucestershire
    Administrateur
    18 The Lawns
    Gotherington
    GL52 9QT Cheltenham
    Gloucestershire
    British116377130001
    HURST, Tiffany
    Flat 6
    24 Collingham Gardens
    SW5 0HN London
    Administrateur
    Flat 6
    24 Collingham Gardens
    SW5 0HN London
    American94387970002
    IVERSEN, Arnold
    Hamilton House
    Blackwell Hall L Ane Leyhill
    HP5 1UN Chesham
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Hamilton House
    Blackwell Hall L Ane Leyhill
    HP5 1UN Chesham
    Buckinghamshire
    British90729600001
    JURRIES, Donald Lewis
    12 Russell Close
    Regency Quay Chiswick
    W4 2NU London
    Administrateur
    12 Russell Close
    Regency Quay Chiswick
    W4 2NU London
    American71266350001
    KEANE, Raymond John Michael
    Beanstlk Cottage Ipsley Lane
    Ipsley
    B98 0AP Redditch
    Worcestershire
    Administrateur
    Beanstlk Cottage Ipsley Lane
    Ipsley
    B98 0AP Redditch
    Worcestershire
    EnglandBritish60812750001
    MCCLELLAND, Lynn Fiona
    85 St George Place
    Deanery Road
    BS1 5QH Bristol
    Administrateur
    85 St George Place
    Deanery Road
    BS1 5QH Bristol
    British108053630001
    MCNAMARA, Mary Jane
    96 Lake Rise
    RM1 4EE Gidea Park
    Essex
    Administrateur
    96 Lake Rise
    RM1 4EE Gidea Park
    Essex
    British69295880001
    MORRIS, Gavin Peter
    93 Reedley Road
    Westbury On Trym
    BS9 3TB Bristol
    Administrateur
    93 Reedley Road
    Westbury On Trym
    BS9 3TB Bristol
    United KingdomBritish209898490001
    NAGARAJAN, Sriram
    53 Deneary Road
    BS1 5QH Bristol
    Administrateur
    53 Deneary Road
    BS1 5QH Bristol
    British96764950003
    PEARCE, Nigel
    17 Greenfinch Close
    Heathlake Park
    RG45 6TZ Crowthorpe
    Berkshire
    Administrateur
    17 Greenfinch Close
    Heathlake Park
    RG45 6TZ Crowthorpe
    Berkshire
    British78720980001
    REEVE, Robert Arthur
    6 Wellesford Close
    SM7 2HL Banstead
    Surrey
    Administrateur désigné
    6 Wellesford Close
    SM7 2HL Banstead
    Surrey
    British900007190001
    RENDELL, David Richard
    Old Post Office
    Ferry Lane Medmenham
    SL7 2EZ Marlow
    Administrateur
    Old Post Office
    Ferry Lane Medmenham
    SL7 2EZ Marlow
    EnglandBritish74264230001
    RENDELL, David Richard
    Old Post Office
    Ferry Lane Medmenham
    SL7 2EZ Marlow
    Administrateur
    Old Post Office
    Ferry Lane Medmenham
    SL7 2EZ Marlow
    EnglandBritish74264230001
    ROBERTS, Neil Anthony
    Lynwood Ockham Road North
    West Horsley
    KT24 6PF Leatherhead
    Surrey
    Administrateur
    Lynwood Ockham Road North
    West Horsley
    KT24 6PF Leatherhead
    Surrey
    British12016400001

    WOODCHESTER EQUIPMENT FINANCE LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Deed
    Créé le 04 juil. 1996
    Livré le 22 juil. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the hp facility agreement, any hire purchase agreement or any other transaction document
    Brèves mentions
    All of the company's right, title and interest in and to the sterling money market deposits. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank Austria Ag
    Transactions
    • 22 juil. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 déc. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 04 juil. 1996
    Livré le 22 juil. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the hp facility agreement, any hire purchase agreement or any other transaction document
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank Austria Ag
    Transactions
    • 22 juil. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 janv. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed
    Créé le 04 juil. 1996
    Livré le 22 juil. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the hp facility agreement, any hire purchase agreement or any other transaction document
    Brèves mentions
    All of the company's right, title and interest in and to account no: 8088353 of the company with barclays bank PLC. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank Austria A.G.
    Transactions
    • 22 juil. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 déc. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed
    Créé le 04 juil. 1996
    Livré le 22 juil. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the hp facility agreement, any hire purchase agreement or any other transaction document
    Brèves mentions
    All the company's right, title, benefit and interest in the leases. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank Austria Ag
    Transactions
    • 22 juil. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 déc. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Money market deposit assignment
    Créé le 21 déc. 1993
    Livré le 24 déc. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee or to the owners (or any of them) on any account whatsoever under or pursuant to the hp facility agreement and/or any transaction document
    Brèves mentions
    All the company's right title and interest in and to the money market rights. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank Austria, London Branch (As Agent for the Owners Under the Hp Facility Agreement)
    Transactions
    • 24 déc. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 déc. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Lease assignment
    Créé le 31 déc. 1991
    Livré le 09 janv. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee for details see form 395
    Brèves mentions
    All the hirers right title and benefit A10 interst in and to the lease for full details see form 395.
    Personnes ayant droit
    • The Financial Institutionsas Therein Defined
    Transactions
    • 09 janv. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 déc. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Lease assignment
    Créé le 31 oct. 1991
    Livré le 05 nov. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the co.to british commonwealth merchant bank PLC as agent for itself and its financial institutions as defined therein under the terms of the H.P. facility agreements and/or any transaction documents.
    Brèves mentions
    All the hirer's right title and benefit and interest to and in the leases described in the schedules. See form 395 'M1'for details.
    Personnes ayant droit
    • British & Commonwealth Merchant Bank PLC
    Transactions
    • 05 nov. 1991Enregistrement d'une charge
    • 12 déc. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Lease assignment
    Créé le 30 sept. 1991
    Livré le 01 oct. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on its own behalf and as agent for the owners under the terms of the h p facility agreement dated 12/6/91 and/or any transaction documents
    Brèves mentions
    All the hires right title & interest to and in the leases described in the schedule (for full details see form 395 & schecule).
    Personnes ayant droit
    • British Commonwealth Merchant Bank PLC
    Transactions
    • 01 oct. 1991Enregistrement d'une charge
    • 12 déc. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Lease assignment
    Créé le 30 août 1991
    Livré le 10 sept. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee the agent and to the owners (as defined therein) under the terms of the facility agreement dated 12/6/91 and/or any transaction document
    Brèves mentions
    All the hirers right title & benefit & interest in the leases see 395 for details.
    Personnes ayant droit
    • British & Commonwealth Merchant Bank Plcas Agent
    Transactions
    • 10 sept. 1991Enregistrement d'une charge
    • 12 déc. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Lease assignment
    Créé le 28 juin 1991
    Livré le 04 juil. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the h p facility agreement dated 12/6/91 and/or any transacaton documents
    Brèves mentions
    All the hirers right title & interest & benefit in and to the leases desc ribed in the schedule to the lease assignment (for full details see form 395).
    Personnes ayant droit
    • British & Commonwealth Merchant Bank Plcan Its Own Behalf and as the Owners
    Transactions
    • 04 juil. 1991Enregistrement d'une charge
    • 12 déc. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Bank account assignment
    Créé le 24 juin 1991
    Livré le 25 juin 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due from the company the the british & commonwealth merchant bank PLC as agent for itself and as agent for the owners (as defined therein) under the L/P facility agreement dated 12/6/91 and/or any fransaction document
    Brèves mentions
    All the company's right title and interest in and to account no 80880353 held at barclays bank PLC sort code 20658L.
    Personnes ayant droit
    • British & Commonwealth Merchant Bank PLC
    Transactions
    • 25 juin 1991Enregistrement d'une charge
    • 12 déc. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 12 juin 1991
    Livré le 19 juin 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee as agentfor itself and the lenders under the terms of the charge the facility agreement and/or transaction document as defined.
    Brèves mentions
    (For full details see form 395). undertaking and all property and assets.
    Personnes ayant droit
    • British & Commonwealth Merchant Bank PLC.
    Transactions
    • 19 juin 1991Enregistrement d'une charge
    • 23 janv. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    WOODCHESTER EQUIPMENT FINANCE LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    09 janv. 2010Dissolved on
    20 févr. 2009Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Tony James Thompson
    Piper Thompson
    Mulberry House
    KT13 8DJ 53 Church Street
    Weybridge Surrey
    practitioner
    Piper Thompson
    Mulberry House
    KT13 8DJ 53 Church Street
    Weybridge Surrey

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0