QUADRANT INTEGRATED SYSTEMS LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | QUADRANT INTEGRATED SYSTEMS LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 02583461 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe QUADRANT INTEGRATED SYSTEMS LIMITED ?
| Adresse du siège social | Synectics House 3-4 Broadfield Close S8 0XN Sheffield England |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de QUADRANT INTEGRATED SYSTEMS LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 30 nov. 2019 |
Quels sont les derniers dépôts pour QUADRANT INTEGRATED SYSTEMS LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 1 pages | DS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 nov. 2019 | 3 pages | AA | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Avis de changement de nom" | 2 pages | CONNOT | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 05 févr. 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Nomination de Mr David Michael Bedford en tant qu'administrateur le 06 janv. 2020 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Amanda Louise Larnder en tant que directeur le 06 janv. 2020 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de C/O Synectics Plc Studley Point 88 Birmingham Road Studley Warwickshire B80 7AS à Synectics House 3-4 Broadfield Close Sheffield S8 0XN le 02 déc. 2019 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 nov. 2018 | 3 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Mrs Amanda Louise Larnder en tant qu'administrateur le 18 avr. 2019 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Mark Gerald Goodwin en tant que directeur le 18 avr. 2019 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Simon Beswick en tant que directeur le 18 avr. 2019 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mrs Claire Susan Stewart en tant que secrétaire le 04 mars 2019 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Simon Beswick en tant que secrétaire le 04 mars 2019 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 05 févr. 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Nomination de Mr Simon Beswick en tant qu'administrateur le 30 nov. 2018 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mr Simon Beswick en tant que secrétaire le 30 nov. 2018 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Michael James Stilwell en tant que directeur le 30 nov. 2018 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Michael James Stilwell en tant que secrétaire le 30 nov. 2018 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 nov. 2017 | 4 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Mr Mark Gerald Goodwin en tant qu'administrateur le 06 avr. 2018 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Richard Paul Brierley en tant que directeur le 06 avr. 2018 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Michael James Stilwell en tant que secrétaire le 06 avr. 2018 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de QUADRANT INTEGRATED SYSTEMS LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEWART, Claire Susan | Secrétaire | 3-4 Broadfield Close S8 0XN Sheffield Synectics House England | 255934560001 | |||||||
| BEDFORD, David Michael | Administrateur | 3-4 Broadfield Close S8 0XN Sheffield Synectics House England | England | British | 302295360001 | |||||
| BESWICK, Simon | Secrétaire | 3-4 Broadfield Close S8 0XN Sheffield Synectics House England | 253087930001 | |||||||
| BRIERLEY, Richard Paul | Secrétaire | c/o Synectics Plc 88 Birmingham Road B80 7AS Studley Studley Point Warwickshire United Kingdom | 209176920001 | |||||||
| GERAGHTY, Paul Kevin Ian | Secrétaire | Monkwood Cottage Whitakers Way IG10 1SQ Loughton Essex | British | 86029660001 | ||||||
| GOSS, Mark William | Secrétaire | 57 Highfield Drive Royton OL2 6AF Oldham Lancashire | British | 3859880002 | ||||||
| HISCOCK, Bruce Edward Heath | Secrétaire | 2 Webbs Cottages The Green RG29 1HF North Warnborough Hampshire | British | 74922870001 | ||||||
| MIGHELL, Howard Stanley | Secrétaire | 25 Goldings Close Kings Hill ME19 4BE West Malling Kent | British | 60739240001 | ||||||
| POULTNEY, Nigel Charles | Secrétaire | 4 Holt Road B80 7NX Studley Warwickshire | British | 8488600002 | ||||||
| STILWELL, Michael James | Secrétaire | c/o Synectics Plc 88 Birmingham Road B80 7AS Studley Studley Point Warwickshire | 245091810001 | |||||||
| BRITANNIA COMPANY FORMATIONS LIMITED | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester | 900001550001 | |||||||
| BAKER, Terence Ernest | Administrateur | Pentewan Gravesend Road Wrotham TN15 7JS Sevenoaks Kent | British | 20512740001 | ||||||
| BENTLEY, Christopher John | Administrateur | 6 Cornwall Crescent Diggle OL3 5PW Oldham Lancashire | England | British | 49363770001 | |||||
| BESWICK, Simon | Administrateur | 3-4 Broadfield Close S8 0XN Sheffield Synectics House England | Scotland | British | 133770010001 | |||||
| BRIERLEY, Richard Paul | Administrateur | c/o Synectics Plc 88 Birmingham Road B80 7AS Studley Studley Point Warwickshire United Kingdom | United Kingdom | British | 209175910001 | |||||
| GERAGHTY, Paul Kevin Ian | Administrateur | Monkwood Cottage Whitakers Way IG10 1SQ Loughton Essex | United Kingdom | British | 86029660001 | |||||
| GOODWIN, Mark Gerald | Administrateur | c/o Synectics Plc 88 Birmingham Road B80 7AS Studley Studley Point Warwickshire | England | British | 233845210001 | |||||
| GOSS, Mark William | Administrateur | 57 Highfield Drive Royton OL2 6AF Oldham Lancashire | England | British | 3859880002 | |||||
| HISCOCK, Bruce Edward Heath | Administrateur | 2 Webbs Cottages The Green RG29 1HF North Warnborough Hampshire | United Kingdom | British | 74922870001 | |||||
| KENWAY, Ian David | Administrateur | 5 Duncote Grove Royton OL2 6LL Oldham Lancashire | British | 3859890003 | ||||||
| LARNDER, Amanda Louise | Administrateur | 3-4 Broadfield Close S8 0XN Sheffield Synectics House England | England | British | 257818550001 | |||||
| MIGHELL, Howard Stanley | Administrateur | 25 Goldings Close Kings Hill ME19 4BE West Malling Kent | United Kingdom | British | 60739240001 | |||||
| MOIR, William John Wallace | Administrateur | Shrublands Lockhampton Hill GL53 9QJ Cheltenham Gloucestershire | United Kingdom | British | 394130001 | |||||
| MOIR, William John Wallace | Administrateur | Shrublands Lockhampton Hill GL53 9QJ Cheltenham Gloucestershire | United Kingdom | British | 394130001 | |||||
| PARKER, Philip Hull | Administrateur | 1 Quarry Lane Lower Shiplake RG9 3JW Henley Oxfordshire | British | 99496350001 | ||||||
| POULTNEY, Nigel Charles | Administrateur | 4 Holt Road B80 7NX Studley Warwickshire | England | British | 8488600002 | |||||
| RICKS, Roy William | Administrateur | 87 St Marys Drive SS7 1LH Benfleet Essex | British | 68026600001 | ||||||
| SHEPHERD, John, Mr. | Administrateur | c/o Synectics Plc 88 Birmingham Road B80 7AS Studley Studley Point Warwickshire United Kingdom | United Kingdom | British | 151588320001 | |||||
| SINGLETON, Russell Craig | Administrateur | 417 Whirlowdale Road S11 9NG Sheffield South Yorkshire | England | British | 3492940001 | |||||
| SMITH, Clive Alan | Administrateur | The Spinney Devenish Lane SL5 9QU Ascot Berkshire | British | 62182450003 | ||||||
| STILWELL, Michael James | Administrateur | c/o Synectics Plc 88 Birmingham Road B80 7AS Studley Studley Point Warwickshire | England | British | 194783340001 | |||||
| TAYLOR, Roger | Administrateur | St Georges House St Georges Place GY1 2BH St Peter Port Guernsey | Channel Islands | British | 109462320001 | |||||
| UNWIN, Michael Richard | Administrateur | Beechcomber Station Road RH19 4NY Sharpethorne West Sussex | West Sussex | British | 43396130001 | |||||
| DEANSGATE COMPANY FORMATIONS LIMITED | Administrateur désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester | 900001540001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur QUADRANT INTEGRATED SYSTEMS LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Protec Plc | 06 avr. 2016 | 88 Birmingham Road B80 7AS Studley Studley Point England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
QUADRANT INTEGRATED SYSTEMS LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Mortgage debenture | Créé le 29 mai 1996 Livré le 05 juin 1996 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0