PRODRIVE AUTOMOTIVE TECHNOLOGY LIMITED

PRODRIVE AUTOMOTIVE TECHNOLOGY LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéPRODRIVE AUTOMOTIVE TECHNOLOGY LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02584542
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de PRODRIVE AUTOMOTIVE TECHNOLOGY LIMITED ?

    • Activités des sièges sociaux (70100) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe PRODRIVE AUTOMOTIVE TECHNOLOGY LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Prodrive Headquarters
    Chalker Way
    OX16 4XD Banbury
    Oxfordshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de PRODRIVE AUTOMOTIVE TECHNOLOGY LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    TICKFORD LIMITED30 mars 199130 mars 1991
    DACRON SERVICES LIMITED21 févr. 199121 févr. 1991

    Quels sont les derniers comptes de PRODRIVE AUTOMOTIVE TECHNOLOGY LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2014

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour PRODRIVE AUTOMOTIVE TECHNOLOGY LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour PRODRIVE AUTOMOTIVE TECHNOLOGY LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    La procédure de radiation volontaire a été suspendue.

    1 pagesSOAS(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 23 déc. 2015

    • Capital: GBP 1.00
    4 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Démission de l'auditeur

    2 pagesAUD

    Nomination de Mr Tim Mark Colchester en tant qu'administrateur le 16 déc. 2015

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Dominic Owen Cartwright en tant que directeur le 16 déc. 2015

    1 pagesTM01

    Démission de l'auditeur

    2 pagesAUD

    Déclaration annuelle jusqu'au 05 nov. 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital10 nov. 2015

    État du capital au 10 nov. 2015

    • Capital: GBP 270,401
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2014

    12 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de Acorn Way Banbury Oxfordshire OX16 3ER à Prodrive Headquarters Chalker Way Banbury Oxfordshire OX16 4XD le 20 avr. 2015

    1 pagesAD01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Dominic Owen Cartwright le 05 févr. 2015

    2 pagesCH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2013

    12 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 05 nov. 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital02 déc. 2014

    État du capital au 02 déc. 2014

    • Capital: GBP 270,401
    SH01

    Nomination de Mr Dominic Cartwright en tant qu'administrateur le 26 sept. 2014

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Anthony Butcher en tant que directeur le 18 sept. 2014

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Anthony Butcher en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Clive Scrivener en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr David Pender Richards en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Déclaration annuelle jusqu'au 05 nov. 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital25 nov. 2013

    État du capital au 25 nov. 2013

    • Capital: GBP 270,401
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Clive Gerald Scrivener le 25 nov. 2013

    2 pagesCH01

    Qui sont les dirigeants de PRODRIVE AUTOMOTIVE TECHNOLOGY LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BAILEY, Timothy Carew
    Chalker Way
    OX16 4XD Banbury
    Prodrive Headquarters
    Oxfordshire
    England
    Secrétaire
    Chalker Way
    OX16 4XD Banbury
    Prodrive Headquarters
    Oxfordshire
    England
    British122203180001
    COLCHESTER, Tim Mark
    Chalker Way
    OX16 4XD Banbury
    Prodrive Headquarters
    Oxfordshire
    Administrateur
    Chalker Way
    OX16 4XD Banbury
    Prodrive Headquarters
    Oxfordshire
    EnglandBritishAccountant184641070001
    RICHARDS, David Pender
    Chalker Way
    OX16 4XD Banbury
    Prodrive Headquarters
    Oxfordshire
    England
    Administrateur
    Chalker Way
    OX16 4XD Banbury
    Prodrive Headquarters
    Oxfordshire
    England
    EnglandBritishChief Executive11410420001
    HALL, David
    8 Tanners Drive
    Blakelands
    MK14 5BN Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    8 Tanners Drive
    Blakelands
    MK14 5BN Milton Keynes
    Buckinghamshire
    BritishCompany Director19284930001
    HORSLEY, Richard Geoffrey Courtenay
    Elliotts Farmhouse
    Adstone
    NN12 8DY Towcester
    Northamptonshire
    Secrétaire
    Elliotts Farmhouse
    Adstone
    NN12 8DY Towcester
    Northamptonshire
    British83097700001
    COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    Secrétaire désigné
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    900000080001
    BURNICLE, David Simpson
    29 Rowsham Dell
    Giffard Park
    MK14 5JS Milton Keynes
    Bucks
    Administrateur
    29 Rowsham Dell
    Giffard Park
    MK14 5JS Milton Keynes
    Bucks
    BritishCompany Director33492910001
    BUTCHER, Anthony James
    Acorn Way
    Banbury
    OX16 3ER Oxfordshire
    Administrateur
    Acorn Way
    Banbury
    OX16 3ER Oxfordshire
    EnglandBritishManaging Director192406620001
    CARTWRIGHT, Dominic Owen
    Chalker Way
    OX16 4XD Banbury
    Prodrive Headquarters
    Oxfordshire
    England
    Administrateur
    Chalker Way
    OX16 4XD Banbury
    Prodrive Headquarters
    Oxfordshire
    England
    EnglandBritishManaging Director191286570002
    FLINT, David
    22 Wombat Drive
    Eltham
    Victroia 3095
    Australia
    Administrateur
    22 Wombat Drive
    Eltham
    Victroia 3095
    Australia
    BritishCompany Director24273060004
    FRY, Nicholas Richard
    41 Hobson Road
    Summertown
    OX2 7JU Oxford
    Oxfordshire
    Administrateur
    41 Hobson Road
    Summertown
    OX2 7JU Oxford
    Oxfordshire
    BritishDirector95886760001
    HALL, David
    Ash Tree House Leys Lane
    Preston Bissett
    MK18 4LX Buckingham
    Bucks
    Administrateur
    Ash Tree House Leys Lane
    Preston Bissett
    MK18 4LX Buckingham
    Bucks
    BritishFinance Director24273020001
    HORSLEY, Richard Geoffrey Courtenay
    Elliotts Farmhouse
    Adstone
    NN12 8DY Towcester
    Northamptonshire
    Administrateur
    Elliotts Farmhouse
    Adstone
    NN12 8DY Towcester
    Northamptonshire
    EnglandBritishChartered Accountant83097700001
    MORGAN, David Barrie
    3 Huxley Close
    MK16 8RA Newport Pagnell
    Buckinghamshire
    Administrateur
    3 Huxley Close
    MK16 8RA Newport Pagnell
    Buckinghamshire
    BritishEngineer24273040001
    ROSS, Anne Therese
    80 Brown Street
    Heidelberg Vic
    Victoria 3084
    Australia
    Administrateur
    80 Brown Street
    Heidelberg Vic
    Victoria 3084
    Australia
    AustraliaAustralianAccountant75903380001
    RYDER, Paul Jeffrey
    Orchard House
    Icomb
    GL54 1JD Cheltenham
    Gloucestershire
    Administrateur
    Orchard House
    Icomb
    GL54 1JD Cheltenham
    Gloucestershire
    BritishCompany Director74324270004
    SCRIVENER, Clive Gerald
    Acorn Way
    Banbury
    OX16 3ER Oxfordshire
    Administrateur
    Acorn Way
    Banbury
    OX16 3ER Oxfordshire
    United KingdomBritishFinance Director116990890001
    SERVATI, Hamid
    30974 Sturbridge
    Farmingtonhills
    Michigan 48331
    Usa
    Administrateur
    30974 Sturbridge
    Farmingtonhills
    Michigan 48331
    Usa
    AmericanDirector48674550001
    THURSTON, John
    Grange Farm
    Hatch Lane
    NN7 2AR Horton
    Northamptonshire
    Administrateur
    Grange Farm
    Hatch Lane
    NN7 2AR Horton
    Northamptonshire
    BritishCompany Director5658990003
    COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    Administrateur désigné
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    900000080001

    PRODRIVE AUTOMOTIVE TECHNOLOGY LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A pledge agreement
    Créé le 26 oct. 2007
    Livré le 07 nov. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or the borrower to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    A security interest in the following (a) all shares of the capital stock of the us subsidiary and the certificates representing the shares of such capital stock all options and warrants for the purchase of shares of the capital stock of the us subsidiary. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 07 nov. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Intellectual property charge
    Créé le 17 mai 2001
    Livré le 01 juin 2001
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All intellectual property rights (as defined) all right title and interest throughout the world in all those third party rights together with the entire benefit of the third party rights and all proceeds money and other rights and benefits in respect of the exercise of such intellectual property rights and/or third party rights. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 01 juin 2001Enregistrement d'une charge (395)
    Deed of accession to a composite guarantee and debenture
    Créé le 17 mai 2001
    Livré le 01 juin 2001
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 01 juin 2001Enregistrement d'une charge (395)
    Equitable mortgage of shares
    Créé le 17 mai 2001
    Livré le 22 mai 2001
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any group member to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    (A) all present shares (b) all acquired shares and the new rights, as the company acquires them; and (c) all deposited shares, when the certificates and transfers in respect of those shares are deposited in accordance with clause 2.4 of the mortgage. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 22 mai 2001Enregistrement d'une charge (395)
    Chattel mortgage
    Créé le 24 déc. 1993
    Livré le 07 janv. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All the assets together with all additions, alterations, accessories, replacements and renewals of component parts thereto (as listed in the schedule to the form 395 tc ref: M377C) inclusive of 14 seiko sewing machines model lsw 8BL. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Legal and General Assurance Society Limited
    • Martin Emmison
    • John Thurston
    Transactions
    • 07 janv. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 août 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Chattel mortgage
    Créé le 01 août 1991
    Livré le 16 août 1991
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    List of plant & equipment etc. shown fully on form 395.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 16 août 1991Enregistrement d'une charge
    • 12 août 1995Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    Chattel mortgage
    Créé le 01 août 1991
    Livré le 16 août 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Rover 820 registration no. F 579 xok ford transit registration no. F157 oyf.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 16 août 1991Enregistrement d'une charge
    • 01 sept. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee & debenture
    Créé le 04 juil. 1991
    Livré le 12 juil. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or dacron limited to the chargee on any account whatsoever.
    Brèves mentions
    (See doc M692C for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 12 juil. 1991Enregistrement d'une charge
    • 12 août 1995Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 01 sept. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 07 mai 1991
    Livré le 14 mai 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £10,000 and all monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • David Flint
    Transactions
    • 14 mai 1991Enregistrement d'une charge
    • 12 août 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 07 mai 1991
    Livré le 14 mai 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £10,000 and all monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • David Simpson Burnicle
    Transactions
    • 14 mai 1991Enregistrement d'une charge
    • 12 août 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 07 mai 1991
    Livré le 14 mai 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £10,000 and all monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • David Hall
    Transactions
    • 14 mai 1991Enregistrement d'une charge
    • 12 août 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 07 mai 1991
    Livré le 14 mai 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £10,000 and all monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • David Barrie Morgan
    Transactions
    • 14 mai 1991Enregistrement d'une charge
    • 12 août 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 07 mai 1991
    Livré le 14 mai 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £100,000 and all monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Taffsworth Limited
    Transactions
    • 14 mai 1991Enregistrement d'une charge
    • 12 août 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 07 mai 1991
    Livré le 14 mai 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £60,000 and all monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • John Thurston
    Transactions
    • 14 mai 1991Enregistrement d'une charge
    • 12 août 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 15 mars 1991
    Livré le 26 mars 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 26 mars 1991Enregistrement d'une charge
    • 12 août 1995Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 01 sept. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0