HERON HOLDINGS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéHERON HOLDINGS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02585408
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de HERON HOLDINGS LIMITED ?

    • Vente de voitures d'occasion et de véhicules légers (45112) / Commerce de gros et de détail ; réparation de véhicules automobiles et de motocycles

    Où se situe HERON HOLDINGS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Barclays Bank Chambers
    Market Street
    HX7 6AD Hebden Bridge
    West Yorkshire
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de HERON HOLDINGS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    HERON GRANTHAM LIMITED02 déc. 199302 déc. 1993
    KEY WEST (GRANTHAM) LIMITED10 mai 199110 mai 1991
    LEONAWAY ENTERPRISES LIMITED25 févr. 199125 févr. 1991

    Quels sont les derniers comptes de HERON HOLDINGS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2013

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour HERON HOLDINGS LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour HERON HOLDINGS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Changement d'adresse du siège social de The Birches 2a Marlowe Drive Balderton Newark Nottinghamshire NG24 3QZ England à Barclays Bank Chambers Market Street Hebden Bridge West Yorkshire HX7 6AD le 14 févr. 2015

    1 pagesAD01

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Modification des coordonnées du secrétaire Mrs Veronica Jane Knill Theobald le 19 mars 2014

    1 pagesCH03

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mrs Veronica Jane Knill Theobald le 19 mars 2014

    2 pagesCH01

    Changement d'adresse du siège social de 18 the Lawns Collingham Newark Nottinghamshire NG23 7NT le 19 mars 2014

    1 pagesAD01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Michael David Theobald le 19 mars 2014

    2 pagesCH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 25 févr. 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital26 févr. 2014

    État du capital au 26 févr. 2014

    • Capital: GBP 361,950
    SH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 sept. 2013

    6 pagesAA

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 sept. 2012

    6 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 25 févr. 2013 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Déclaration annuelle jusqu'au 25 févr. 2012 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    La procédure de radiation d'office a été abandonnée

    1 pagesDISS40

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 sept. 2011

    9 pagesAA

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    accounts-with-accounts-type-

    7 pagesAA

    Période comptable précédente raccourcie du 31 déc. 2010 au 30 sept. 2010

    1 pagesAA01

    Déclaration annuelle jusqu'au 25 févr. 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Changement d'adresse du siège social de Northern Road Newark Nottinghamshire NG24 2ET le 01 mars 2011

    2 pagesAD01

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    Comptes consolidés établis au 31 déc. 2009

    21 pagesAA

    Nomination de Mrs Veronica Jane Knill Theobald en tant que secrétaire

    1 pagesAP03

    Cessation de la nomination de David Hodgson en tant que secrétaire

    2 pagesTM02

    Qui sont les dirigeants de HERON HOLDINGS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    THEOBALD, Veronica Jane Knill
    2a Marlowe Drive
    Balderton
    NG24 3QZ Newark
    The Birches
    Nottinghamshire
    England
    Secrétaire
    2a Marlowe Drive
    Balderton
    NG24 3QZ Newark
    The Birches
    Nottinghamshire
    England
    154350610001
    THEOBALD, Michael David
    2a Marlowe Drive
    Balderton
    NG24 3QZ Newark
    The Birches
    Nottinghamshire
    England
    Administrateur
    2a Marlowe Drive
    Balderton
    NG24 3QZ Newark
    The Birches
    Nottinghamshire
    England
    United KingdomBritish26464880003
    THEOBALD, Veronica Jane Knill
    2a Marlowe Drive
    Balderton
    NG24 3QZ Newark
    The Birches
    Nottinghamshire
    England
    Administrateur
    2a Marlowe Drive
    Balderton
    NG24 3QZ Newark
    The Birches
    Nottinghamshire
    England
    United KingdomBritish29141950002
    HODGSON, David William
    23 Washingborough Road
    Heighington
    LN4 1QW Lincoln
    Lincolnshire
    Secrétaire
    23 Washingborough Road
    Heighington
    LN4 1QW Lincoln
    Lincolnshire
    British47003620002
    THEOBALD, Veronica Jane Knill
    18 The Lawns
    Collingham
    NG23 7NT Newark
    Nottinghamshire
    Secrétaire
    18 The Lawns
    Collingham
    NG23 7NT Newark
    Nottinghamshire
    British29141950001
    WAYGOOD WEST, Caroline Ann
    Swanage Farm
    Washpond Lane
    BH19 1QA Swanage
    Dorset
    Secrétaire
    Swanage Farm
    Washpond Lane
    BH19 1QA Swanage
    Dorset
    British75388970001
    WAYGOOD-WEST, Kevin
    14 Chedburgh Close
    Doddington Park
    LN6 0SU Lincoln
    Lincolnshire
    Secrétaire
    14 Chedburgh Close
    Doddington Park
    LN6 0SU Lincoln
    Lincolnshire
    British32923670001
    COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    Secrétaire désigné
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    900000080001
    CLIFFORD, Stephen John
    67 Olney Road
    Emberton
    MK46 5BU Olney
    Buckinghamshire
    Administrateur
    67 Olney Road
    Emberton
    MK46 5BU Olney
    Buckinghamshire
    British43921070001
    FELL, John Michael
    59 Cliffe Road
    Ryhope Village
    SR2 0NW Sunderland
    Tyne & Wear
    Administrateur
    59 Cliffe Road
    Ryhope Village
    SR2 0NW Sunderland
    Tyne & Wear
    British56249460001
    GREGORY, Robert
    48 Holmefield
    Farndon
    NG24 3TZ Newark
    Nottinghamshire
    Administrateur
    48 Holmefield
    Farndon
    NG24 3TZ Newark
    Nottinghamshire
    British47003560001
    HEATHER, Philip William
    2 Spring Close
    Colwall
    WR13 6RE Malvern
    Worcestershire
    Administrateur
    2 Spring Close
    Colwall
    WR13 6RE Malvern
    Worcestershire
    English35271660001
    HODGSON, David William
    23 Washingborough Road
    Heighington
    LN4 1QW Lincoln
    Lincolnshire
    Administrateur
    23 Washingborough Road
    Heighington
    LN4 1QW Lincoln
    Lincolnshire
    United KingdomBritish47003620002
    ICETON, Ian Gordon
    7 Wharf View
    MK18 1XF Buckingham
    Administrateur
    7 Wharf View
    MK18 1XF Buckingham
    British53359540001
    WAYGOOD-WEST, Kevin
    14 Chedburgh Close
    Doddington Park
    LN6 0SU Lincoln
    Lincolnshire
    Administrateur
    14 Chedburgh Close
    Doddington Park
    LN6 0SU Lincoln
    Lincolnshire
    British32923670001
    COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    Administrateur désigné
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    900000080001

    HERON HOLDINGS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    General charge
    Créé le 03 août 1994
    Livré le 05 août 1994
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All the companys assets present & future (including uncalled capital).
    Personnes ayant droit
    • Volkswagen Financial Services (UK) Limited
    Transactions
    • 05 août 1994Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 24 mars 1994
    Livré le 26 mars 1994
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    All monies owing to the company by V.A.G. (united kingdom) limited in respect of refunds of monies paid by or by the direction of the company to V.A.G. (united kingdom) limited by way of deposit on the acquisition of motor vehicles on a consignment basis.
    Personnes ayant droit
    • Volkswagen Financial Services (UK) Limited
    Transactions
    • 26 mars 1994Enregistrement d'une charge (395)
    General charge
    Créé le 09 sept. 1993
    Livré le 10 sept. 1993
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All the company's assets present and future (including uncalled capital).
    Personnes ayant droit
    • V.A.G. Finance Limited
    Transactions
    • 10 sept. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    General charge
    Créé le 09 sept. 1993
    Livré le 10 sept. 1993
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All the company's assets present and future (including uncalled capital).
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transactions
    • 10 sept. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 19 août 1992
    Livré le 21 août 1992
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an offer letter dated 30TH may 1991
    Brèves mentions
    L/H land and premises situate at spittlegate level, grantham, lincs. As described in a lease dated 13.6.91. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • V.A.G. (United Kingdom) Limited
    Transactions
    • 21 août 1992Enregistrement d'une charge (395)
    Legal mortgage
    Créé le 15 nov. 1991
    Livré le 04 déc. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land & premises k/a keywest (grantham) limited,spittlegate level,grantham,lincolnshire and proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 04 déc. 1991Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 févr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 02 sept. 1991
    Livré le 05 sept. 1991
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All monies owing to the company in respect of refunds of monies paid by the company to V.A.G. (united kingdom) LTD. See 395 for details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transactions
    • 05 sept. 1991Enregistrement d'une charge
    Mortgage debenture
    Créé le 13 juin 1991
    Livré le 03 juil. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 03 juil. 1991Enregistrement d'une charge
    • 01 févr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0