HERON HOLDINGS LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | HERON HOLDINGS LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 02585408 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe HERON HOLDINGS LIMITED ?
| Adresse du siège social | Barclays Bank Chambers Market Street HX7 6AD Hebden Bridge West Yorkshire England |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de HERON HOLDINGS LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 30 sept. 2013 |
Quel est le statut du dernier bilan annuel pour HERON HOLDINGS LIMITED ?
| Bilan annuel |
|
|---|
Quels sont les derniers dépôts pour HERON HOLDINGS LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de The Birches 2a Marlowe Drive Balderton Newark Nottinghamshire NG24 3QZ England à Barclays Bank Chambers Market Street Hebden Bridge West Yorkshire HX7 6AD le 14 févr. 2015 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Mrs Veronica Jane Knill Theobald le 19 mars 2014 | 1 pages | CH03 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mrs Veronica Jane Knill Theobald le 19 mars 2014 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 18 the Lawns Collingham Newark Nottinghamshire NG23 7NT le 19 mars 2014 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Michael David Theobald le 19 mars 2014 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 25 févr. 2014 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 sept. 2013 | 6 pages | AA | ||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 sept. 2012 | 6 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 25 févr. 2013 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 25 févr. 2012 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
La procédure de radiation d'office a été abandonnée | 1 pages | DISS40 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 sept. 2011 | 9 pages | AA | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office | 1 pages | GAZ1 | ||||||||||
accounts-with-accounts-type- | 7 pages | AA | ||||||||||
Période comptable précédente raccourcie du 31 déc. 2010 au 30 sept. 2010 | 1 pages | AA01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 25 févr. 2011 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Northern Road Newark Nottinghamshire NG24 2ET le 01 mars 2011 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
legacy | 3 pages | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 pages | MG02 | ||||||||||
Comptes consolidés établis au 31 déc. 2009 | 21 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Mrs Veronica Jane Knill Theobald en tant que secrétaire | 1 pages | AP03 | ||||||||||
Cessation de la nomination de David Hodgson en tant que secrétaire | 2 pages | TM02 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de HERON HOLDINGS LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THEOBALD, Veronica Jane Knill | Secrétaire | 2a Marlowe Drive Balderton NG24 3QZ Newark The Birches Nottinghamshire England | 154350610001 | |||||||
| THEOBALD, Michael David | Administrateur | 2a Marlowe Drive Balderton NG24 3QZ Newark The Birches Nottinghamshire England | United Kingdom | British | 26464880003 | |||||
| THEOBALD, Veronica Jane Knill | Administrateur | 2a Marlowe Drive Balderton NG24 3QZ Newark The Birches Nottinghamshire England | United Kingdom | British | 29141950002 | |||||
| HODGSON, David William | Secrétaire | 23 Washingborough Road Heighington LN4 1QW Lincoln Lincolnshire | British | 47003620002 | ||||||
| THEOBALD, Veronica Jane Knill | Secrétaire | 18 The Lawns Collingham NG23 7NT Newark Nottinghamshire | British | 29141950001 | ||||||
| WAYGOOD WEST, Caroline Ann | Secrétaire | Swanage Farm Washpond Lane BH19 1QA Swanage Dorset | British | 75388970001 | ||||||
| WAYGOOD-WEST, Kevin | Secrétaire | 14 Chedburgh Close Doddington Park LN6 0SU Lincoln Lincolnshire | British | 32923670001 | ||||||
| COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secrétaire désigné | Victoria House 64 Paul Street EC2A 4NG London | 900000080001 | |||||||
| CLIFFORD, Stephen John | Administrateur | 67 Olney Road Emberton MK46 5BU Olney Buckinghamshire | British | 43921070001 | ||||||
| FELL, John Michael | Administrateur | 59 Cliffe Road Ryhope Village SR2 0NW Sunderland Tyne & Wear | British | 56249460001 | ||||||
| GREGORY, Robert | Administrateur | 48 Holmefield Farndon NG24 3TZ Newark Nottinghamshire | British | 47003560001 | ||||||
| HEATHER, Philip William | Administrateur | 2 Spring Close Colwall WR13 6RE Malvern Worcestershire | English | 35271660001 | ||||||
| HODGSON, David William | Administrateur | 23 Washingborough Road Heighington LN4 1QW Lincoln Lincolnshire | United Kingdom | British | 47003620002 | |||||
| ICETON, Ian Gordon | Administrateur | 7 Wharf View MK18 1XF Buckingham | British | 53359540001 | ||||||
| WAYGOOD-WEST, Kevin | Administrateur | 14 Chedburgh Close Doddington Park LN6 0SU Lincoln Lincolnshire | British | 32923670001 | ||||||
| COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Administrateur désigné | Victoria House 64 Paul Street EC2A 4NG London | 900000080001 |
HERON HOLDINGS LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| General charge | Créé le 03 août 1994 Livré le 05 août 1994 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions All the companys assets present & future (including uncalled capital). | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 24 mars 1994 Livré le 26 mars 1994 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Brèves mentions All monies owing to the company by V.A.G. (united kingdom) limited in respect of refunds of monies paid by or by the direction of the company to V.A.G. (united kingdom) limited by way of deposit on the acquisition of motor vehicles on a consignment basis. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| General charge | Créé le 09 sept. 1993 Livré le 10 sept. 1993 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions All the company's assets present and future (including uncalled capital). | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| General charge | Créé le 09 sept. 1993 Livré le 10 sept. 1993 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions All the company's assets present and future (including uncalled capital). | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 19 août 1992 Livré le 21 août 1992 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an offer letter dated 30TH may 1991 | |
Brèves mentions L/H land and premises situate at spittlegate level, grantham, lincs. As described in a lease dated 13.6.91. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal mortgage | Créé le 15 nov. 1991 Livré le 04 déc. 1991 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Land & premises k/a keywest (grantham) limited,spittlegate level,grantham,lincolnshire and proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 02 sept. 1991 Livré le 05 sept. 1991 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions All monies owing to the company in respect of refunds of monies paid by the company to V.A.G. (united kingdom) LTD. See 395 for details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Mortgage debenture | Créé le 13 juin 1991 Livré le 03 juil. 1991 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0