COMMERCIAL LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCOMMERCIAL LIMITED
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02589514
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de COMMERCIAL LIMITED ?

    • Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (82990) / Activités administratives et de soutien

    Où se situe COMMERCIAL LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Commercial House Old Station Drive
    Leckhampton
    GL53 0DL Cheltenham
    Gloucestershire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de COMMERCIAL LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    RAKEACRE LIMITED07 mars 199107 mars 1991

    Quels sont les derniers comptes de COMMERCIAL LIMITED ?

    En retardNon
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le30 juin 2024
    Date d'échéance des prochains comptes31 mars 2025
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 juin 2023

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour COMMERCIAL LIMITED ?

    En retardOui
    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au26 févr. 2025
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation12 mars 2025
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au26 févr. 2024
    En retardOui

    Quels sont les derniers dépôts pour COMMERCIAL LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Nomination de Mr Dean Chester en tant qu'administrateur le 01 juil. 2024

    2 pagesAP01

    Comptes annuels établis au 30 juin 2023

    24 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 26 févr. 2024 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 30 juin 2022

    25 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 07 mars 2023 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Déclaration de confirmation établie le 07 mars 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 30 juin 2021

    26 pagesAA

    Période comptable précédente prolongée du 30 janv. 2021 au 30 juin 2021

    1 pagesAA01

    Déclaration de confirmation établie le 07 mars 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 janv. 2020

    25 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 07 mars 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Eileen Margaret Booth en tant que secrétaire le 01 févr. 2020

    1 pagesTM02

    Comptes annuels établis au 31 janv. 2019

    23 pagesAA

    Satisfaction de la charge 3 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 4 en totalité

    2 pagesMR04

    Inscription de la charge 025895140005, créée le 03 mai 2019

    23 pagesMR01

    Déclaration de confirmation établie le 07 mars 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 janv. 2018

    22 pagesAA

    Période comptable précédente raccourcie du 31 janv. 2018 au 30 janv. 2018

    1 pagesAA01

    Cessation de la nomination de Richard Keatinge en tant que directeur le 31 mars 2018

    1 pagesTM01

    État du capital après une attribution d'actions au 12 janv. 2017

    • Capital: GBP 10,802.30
    4 pagesSH01

    Résolutions

    Resolutions
    25 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01

    Déclaration de confirmation établie le 07 mars 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 janv. 2017

    22 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 07 mars 2017 avec mises à jour

    8 pagesCS01

    Qui sont les dirigeants de COMMERCIAL LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    ADAMS, Alastair John De Quincy
    Cranford
    71 Christ Church Road
    GL50 2PS Cheltenham
    Gloucestershire
    Administrateur
    Cranford
    71 Christ Church Road
    GL50 2PS Cheltenham
    Gloucestershire
    United KingdomBritishSales Director28323860003
    CHESTER, Dean
    Old Station Drive
    Leckhampton
    GL53 0DL Cheltenham
    Commercial House
    Gloucestershire
    Administrateur
    Old Station Drive
    Leckhampton
    GL53 0DL Cheltenham
    Commercial House
    Gloucestershire
    EnglandBritishFinance Director324702240001
    HINDMARCH, Arthur Michael Stephen
    Ashcombe House 96 Evesham Road
    GL52 2AL Cheltenham
    Gloucestershire
    Administrateur
    Ashcombe House 96 Evesham Road
    GL52 2AL Cheltenham
    Gloucestershire
    EnglandBritishManaging Director38806350005
    HINDMARCH-BYE, Simone Denise
    Barnstone
    New Road, Woodmancote
    GL52 4PX Cheltenham
    Gloucestershire
    Administrateur
    Barnstone
    New Road, Woodmancote
    GL52 4PX Cheltenham
    Gloucestershire
    United KingdomBritishDirector52736220004
    BOOTH, Eileen Margaret
    Hilpsford Biggar Village
    Walney
    LA14 3YG Barrow In Furness
    Cumbria
    Secrétaire
    Hilpsford Biggar Village
    Walney
    LA14 3YG Barrow In Furness
    Cumbria
    BritishCompany Secretary53497530001
    DUNN, Alan
    6-9 Lawson Street
    Barrow In Furness
    LA14 2LT
    Cumbria
    Secrétaire
    6-9 Lawson Street
    Barrow In Furness
    LA14 2LT
    Cumbria
    British17716180001
    MBC SECRETARIES LIMITED
    Classic House
    174-180 Old Street
    EC1V 9BP London
    Secrétaire désigné
    Classic House
    174-180 Old Street
    EC1V 9BP London
    900000700001
    HICKMAN, Alan Trevor
    Ridgewood House
    26 High Street
    DN10 4RG Gringley On The Hill
    Nottinghamshire
    Administrateur
    Ridgewood House
    26 High Street
    DN10 4RG Gringley On The Hill
    Nottinghamshire
    EnglandBritishConsultant37719040003
    HINDMARCH, Michael
    The Old Coach House
    Lansdown Crescent
    GL50 2JX Cheltenham
    Gloucestershire
    Administrateur
    The Old Coach House
    Lansdown Crescent
    GL50 2JX Cheltenham
    Gloucestershire
    BritishService General Manager59883270001
    JACKSON, Karl
    42 Clent View Road
    B63 2JB Halesowen
    West Midlands
    Administrateur
    42 Clent View Road
    B63 2JB Halesowen
    West Midlands
    BritishService Director28323840001
    KEATINGE, Richard
    Keynsham Road
    GL53 7PX Cheltenham
    18
    Gloucestershire
    United Kingdom
    Administrateur
    Keynsham Road
    GL53 7PX Cheltenham
    18
    Gloucestershire
    United Kingdom
    United KingdomBritishChief Operating Officer154731810001
    MBC NOMINEES LIMITED
    Classic House
    174-180 Old Street
    EC1V 9BP London
    Administrateur désigné
    Classic House
    174-180 Old Street
    EC1V 9BP London
    900000690001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur COMMERCIAL LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Mr Arthur Michael Stephen Hindmarch
    Old Station Drive
    Leckhampton
    GL53 0DL Cheltenham
    Commercial House
    Gloucestershire
    06 avr. 2016
    Old Station Drive
    Leckhampton
    GL53 0DL Cheltenham
    Commercial House
    Gloucestershire
    Non
    Nationalité: British
    Pays de résidence: England
    Nature du contrôle
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.
    Mrs Simone Denise Hindmarch-Bye
    Old Station Drive
    Leckhampton
    GL53 0DL Cheltenham
    Commercial House
    Gloucestershire
    06 avr. 2016
    Old Station Drive
    Leckhampton
    GL53 0DL Cheltenham
    Commercial House
    Gloucestershire
    Non
    Nationalité: British
    Pays de résidence: England
    Nature du contrôle
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.
    Mr Alistair John De Quincy Adams
    Old Station Drive
    Leckhampton
    GL53 0DL Cheltenham
    Commercial House
    Gloucestershire
    06 avr. 2016
    Old Station Drive
    Leckhampton
    GL53 0DL Cheltenham
    Commercial House
    Gloucestershire
    Non
    Nationalité: British
    Pays de résidence: England
    Nature du contrôle
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.
    Commercial Corporate Services Ltd
    Liddington Industrial Estate, Old Station Drive
    GL53 0DL Cheltenham
    Commercial House
    Gloucestershire
    England
    06 avr. 2016
    Liddington Industrial Estate, Old Station Drive
    GL53 0DL Cheltenham
    Commercial House
    Gloucestershire
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCompanies Acts
    Lieu d'enregistrementCardiff
    Numéro d'enregistrement07531759
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    COMMERCIAL LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 03 mai 2019
    Livré le 07 mai 2019
    En cours
    Brève description
    All freehold and leasehold property owned by the company at the charge creation date together with all buildings, structures, fixtures and fittings (including trade and tenant’s fixtures) now thereon or thereon after the charge creation date.. All future freehold and leasehold property of the company together with all buildings, structures, fixtures and fittings (including trade and tenant’s fixtures) now thereon or thereon after the charge creation date.. All present and future patents, patent applications, trade marks and service marks (whether registered or not), design rights (whether registered or not), copyrights and all other intellectual property rights whatsoever and all rights relating thereto (including, without limitation, by way of license) legally or beneficially owned by the company.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Santander UK PLC
    Transactions
    • 07 mai 2019Enregistrement d'une charge (MR01)
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Créé le 13 août 2012
    Livré le 14 août 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sums or sums standing to the credit of any one or more of any present of future accounts of the company with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in any other currency or currency unit, and the debt or debts owing by the bank represented by any such sum or sums (each such sum and debt being a credit balance).
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 14 août 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 13 mai 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    Single debenture
    Créé le 07 juil. 1993
    Livré le 12 juil. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 12 juil. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 mai 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 25 nov. 1991
    Livré le 04 déc. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 04 déc. 1991Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 juil. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Rental deposit deed.
    Créé le 26 juin 1991
    Livré le 03 juil. 1991
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease dated 16/8/73
    Brèves mentions
    All the tenants' interest in the deposit account and all money from time to time withdrawn from the deposit account.
    Personnes ayant droit
    • Minster Insurance Company Limited
    Transactions
    • 03 juil. 1991Enregistrement d'une charge

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0