STANNIFER LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSTANNIFER LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02597049
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de STANNIFER LIMITED ?

    • Développement de projets de construction (41100) / Construction

    Où se situe STANNIFER LIMITED ?

    Adresse du siège social
    25 Harley Street
    London
    W1G 9BR
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de STANNIFER LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    SHELFCO (NO. 616) LIMITED02 avr. 199102 avr. 1991

    Quels sont les derniers comptes de STANNIFER LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2011

    Quels sont les derniers dépôts pour STANNIFER LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    État du capital au 06 août 2013

    • Capital: GBP 1
    4 pagesSH19

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Déclaration annuelle jusqu'au 02 avr. 2013 avec liste complète des actionnaires

    8 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2011

    13 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 02 avr. 2012 avec liste complète des actionnaires

    8 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Stephane Abraham Joseph Nahum le 28 juin 2011

    2 pagesCH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2010

    12 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Malcolm Robin Turner le 28 juin 2011

    2 pagesCH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 02 avr. 2011 avec liste complète des actionnaires

    8 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2009

    12 pagesAA

    Nomination de Ms Jennifer Grace Draper en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de David Collins en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Malcolm Robin Turner le 01 janv. 2010

    2 pagesCH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 02 avr. 2010 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Stephane Abraham Joseph Nahum le 01 janv. 2010

    3 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Patrick Colin O'driscoll le 01 janv. 2010

    3 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Malcolm Robin Turner le 01 janv. 2010

    3 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr David John Collins le 03 déc. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr James Lane Tuckey le 03 déc. 2009

    2 pagesCH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2008

    12 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de STANNIFER LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    E L SERVICES LIMITED
    25 Harley Street
    W1G 9BR London
    Secrétaire
    25 Harley Street
    W1G 9BR London
    78638580003
    DRAPER, Jennifer Grace
    Hanover Square
    W1S 1JB London
    23
    United Kingdom
    Administrateur
    Hanover Square
    W1S 1JB London
    23
    United Kingdom
    United KingdomAustralian152638020001
    NAHUM, Stephane Abraham Joseph
    21-24 Millbank
    SW1P 4QP London
    4th Floor Millbank Tower
    Administrateur
    21-24 Millbank
    SW1P 4QP London
    4th Floor Millbank Tower
    United KingdomFrench99292580014
    O'DRISCOLL, Patrick Colin
    21-24 Millbank
    SW1P 4QP London
    4th Floor Millbank Tower
    Administrateur
    21-24 Millbank
    SW1P 4QP London
    4th Floor Millbank Tower
    EnglandIrish75571770001
    TUCKEY, James Lane
    Hanover Square
    W1S 1JB London
    23
    United Kingdom
    Administrateur
    Hanover Square
    W1S 1JB London
    23
    United Kingdom
    United KingdomBritish35019240001
    TURNER, Malcolm Robin
    Millbank
    SW1P 4QP London
    4th Floor Millbank Tower 21-24
    Administrateur
    Millbank
    SW1P 4QP London
    4th Floor Millbank Tower 21-24
    United KingdomBritish60293070008
    BLAIR, James Don
    9 Rosebank Grove
    EH5 3QN Edinburgh
    Midlothian
    Secrétaire
    9 Rosebank Grove
    EH5 3QN Edinburgh
    Midlothian
    British85605320001
    HEARN, Paul Leonard
    Fairhaven Featherbed Lane
    CV37 0ER Pathlow
    Warwickshire
    Secrétaire
    Fairhaven Featherbed Lane
    CV37 0ER Pathlow
    Warwickshire
    British10456600005
    MACLEAN, Robert William
    18 Fulton Gardens
    PA6 7NU Houston
    Renfrewshire
    Secrétaire
    18 Fulton Gardens
    PA6 7NU Houston
    Renfrewshire
    British89832510001
    E P S SECRETARIES LIMITED
    50 Stratton Street
    W1X 6NX London
    Secrétaire désigné
    50 Stratton Street
    W1X 6NX London
    900004930001
    BARROTT, Ronald Stephen
    Foxborough
    Drovers Hill
    GL55 6UW Chipping Campden
    Gloucestershire
    Administrateur
    Foxborough
    Drovers Hill
    GL55 6UW Chipping Campden
    Gloucestershire
    EnglandBritish9892700002
    BLAIR, James Don
    9 Rosebank Grove
    EH5 3QN Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    9 Rosebank Grove
    EH5 3QN Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish85605320001
    COLLINS, David John
    Hanover Square
    W1S 1JB London
    23
    United Kingdom
    Administrateur
    Hanover Square
    W1S 1JB London
    23
    United Kingdom
    United KingdomAustralian119898430001
    HUDSON, Geoffrey Grant
    La Boutefeve
    Blanches Pierres Lane
    GY4 6SA St Martins
    Guernsey
    Administrateur
    La Boutefeve
    Blanches Pierres Lane
    GY4 6SA St Martins
    Guernsey
    GuernseyBritish87308690001
    MCDIVEN, Ross Arnold
    U 9 38 Bay Street
    NSW 2028 Double Bay
    New South Wales
    Australia
    Administrateur
    U 9 38 Bay Street
    NSW 2028 Double Bay
    New South Wales
    Australia
    Australian108719480001
    MCGIVERN, Jayne Eleanor
    9 Northumberland Place
    W2 5BS London
    Administrateur
    9 Northumberland Place
    W2 5BS London
    British106563070002
    PEDERSEN, Karen Maree
    22a Kentville Avenue
    Annandale
    Nsw 2038
    Administrateur
    22a Kentville Avenue
    Annandale
    Nsw 2038
    Australian109087760001
    SHEARD, Michael John
    The Old Mill House 2 High Street
    Barford
    CV35 8BU Warwick
    Administrateur
    The Old Mill House 2 High Street
    Barford
    CV35 8BU Warwick
    United KingdomBritish10973520002
    C L LIMITED
    16/18 Athol Street
    ISLEMAN Douglas
    Isle Of Man
    Administrateur
    16/18 Athol Street
    ISLEMAN Douglas
    Isle Of Man
    42022230001
    MIKJON LIMITED
    50 Stratton Street
    W1X 5FL London
    Administrateur désigné
    50 Stratton Street
    W1X 5FL London
    900004920001

    STANNIFER LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Assignation in security
    Créé le 13 juil. 2004
    Livré le 20 juil. 2004
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The rental account being account number 06005311 held with the lender together with all balances standing to the credit thereof and agreements or intruments entered into in relation to the rental account. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 20 juil. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    Deed of variation re debenture dated 15 december 2000 and
    Créé le 13 juil. 2004
    Livré le 20 juil. 2004
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed charge all the company's goodwill and uncalled capital, all present and future stocks, shares and other securities, all patents, patent applications and trade marks etc., all present and future book and other debts, all plant and machinery and all bank accounts, cash at bank and credit balances. Floating charge all the assets being the whole of the property and undertaking of the company (including uncalled capital). See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 20 juil. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    Deed of accession relating to a security deed dated 26TH march 2004 between the original chargor and the security agent (the security agreement) and
    Créé le 18 juin 2004
    Livré le 30 juin 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to any secured creditor under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The Security Agent)
    Transactions
    • 30 juin 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 sept. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 15 déc. 2000
    Livré le 22 déc. 2000
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 22 déc. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 20DECEMBER 2000
    Créé le 29 nov. 2000
    Livré le 23 déc. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee in the terms of personal bond dated 29 november 2000
    Brèves mentions
    Property k/a fife central retail park kirkcaldy.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 23 déc. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 avr. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Assignation of rents
    Créé le 18 juil. 2000
    Livré le 19 juil. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All present and future obligations and liabilities whether owed jointly or severally or in any capacity whatsoever by the company and any other obligor to the chargee under each finance document (as defined in the credit agreement dated 16TH january 1998) as the same was supplemented by supplemental agreement dated 6TH september 1999 and supplemental agreement dated 24TH february 2000
    Brèves mentions
    All right title and interest in the rental income (as defined in the credit agreement) in respect of lease between the company and larsen & ross northern limited dated 27/07/00.
    Personnes ayant droit
    • Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Aktiengesellschaft
    Transactions
    • 19 juil. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 juil. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Supplementary assignation of rents
    Créé le 29 mars 2000
    Livré le 01 avr. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All present and future obligations and liabilities due or to become due from the company and/or any other obligor (as defined in credit facility agreement dated 16 june 1999 between the company and the bank (wherein they are named bayerische hypotheken-und wechsel bank ag) as supplemental by supplemental agreement dated 6TH september 1999 and supplemental agreement dated 24 february 2000, as the same may have been or may be extended, amended, varied, supplemented, novated, restated, replaced or renewed from time to time ("the credit agreement")) to the chargee under each finance document (as defined in credit agreement)
    Brèves mentions
    The company's right title and interest in and to the rental income (as defined in the credit agreement) in respect of the lease between the company and boots the chemists limited dated 21 and 25 february 2000 relative to unit 11, fife central retail park kirkcaldy.
    Personnes ayant droit
    • Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Aktiengesellschaft
    Transactions
    • 01 avr. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 juil. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Assignation and irrevocable mandate
    Créé le 23 juil. 1999
    Livré le 11 août 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The company's whole right title and interest in and its right to rents. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 11 août 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 avr. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Assignation of performance bond
    Créé le 23 juil. 1999
    Livré le 11 août 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    The loan due or to become due from the company to the chargee made available to the company
    Brèves mentions
    The company's whole right title and interest in the performance bond dated 1 july 1999.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 11 août 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 avr. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 4TH august 1999
    Créé le 23 juil. 1999
    Livré le 10 août 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee in terms of a facility letter dated 13TH july 1999 and accepted by the company on 19TH july 1999
    Brèves mentions
    Development site at drip road stirling.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 10 août 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 avr. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Assignation of rents
    Créé le 22 sept. 1998
    Livré le 25 sept. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All obligations and liabilities whatsoever due from the company and/or any obligor (as defined) to the chargee under each finance document (as defined)
    Brèves mentions
    All rights,title and interest in and to all rental income (as defined in the credit agreement) payable in respect of the piece of land to the north of chapel level,kirkcaldy,county of fife; t/no ffe 10316. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Ag
    Transactions
    • 25 sept. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 juil. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge
    Créé le 16 janv. 1998
    Livré le 28 janv. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All present and future obligations and liabilities whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever of the company and each guarantor to the chargee under each finance document except for any obligation which, if it were so included, would result in the charge contravening section 151 of the companies act 1985
    Brèves mentions
    By way of first fixed charge all moneys standing to the credit of the security account; all benefits in respect of the insurances and all claims and returns of premiums in respect of them; the benefit of all licences consents and authorisations (statutory or otherwise) held in connection with its business or the use of any security assets specified in any other sub-paragraph in these short particulars and the right to recover and receive all compensation which may be payable to it in respect of them;. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bayerische Hypotheken-Und Wechsel-Bank Aktiengesellschaft
    Transactions
    • 28 janv. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 juil. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Assignation of rents
    Créé le 16 janv. 1998
    Livré le 21 janv. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under each finance document (as therein defined)
    Brèves mentions
    All rental income due under the leases as listed on the schedule to the form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bayerische Hypotheken-Und Wechsel-Bank Ag
    Transactions
    • 21 janv. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 juil. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 19 january 1998 and
    Créé le 13 janv. 1998
    Livré le 24 janv. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or any other obligor (as defined in the credit agreement) to the chargee and its successors and assignees whomsoever on any account whatsoever including without prejudice to the foregoing generality all present and future obligations and liabilities of each obligor to the chargee under or pursuant to a credit agreement executed by the company on 13 january 1998 but dated 16 january 1998 between the company and the chargee and each finance document referred to as such in the credit agreement except for any obligation which if it were so included would result in the standard security contravening section 151 of the companies act 1985
    Brèves mentions
    All and whole the subjects registered under t/n FFE10316 and being that area or piece of ground lying generally on or towards thenorth of chapel level kirkcaldy fife and bounded on all sides by land belonging to the fife council k/a chapel farm chapel level kirkcaldy. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bayerische Hypotheken-Und Wechsel-Bank Ag
    Transactions
    • 24 janv. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 31 juil. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Standard security presented for registration in scotland on 29TH july 1996
    Créé le 29 juil. 1996
    Livré le 01 août 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Area or piece of ground lying generally on or towards the north of chapel level kirkcaldy in the county of fife k/a chapel farm chapel level kirkaaldy t/no:-FFE10316. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland International Limited
    Transactions
    • 01 août 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 août 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of legal charge
    Créé le 13 avr. 1992
    Livré le 01 mai 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Part of elm court phase ii, arden street, stratfords-upon-avon, warwickshire.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 01 mai 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 sept. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0