WYNDHAM ESTATES INVESTMENTS LIMITED

WYNDHAM ESTATES INVESTMENTS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéWYNDHAM ESTATES INVESTMENTS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02597102
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de WYNDHAM ESTATES INVESTMENTS LIMITED ?

    • Autre location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués (68209) / Activités immobilières

    Où se situe WYNDHAM ESTATES INVESTMENTS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    c/o JEFFREYS HENRY LLP
    Finsgate
    5-7 Cranwood Street
    EC1V 9EE London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de WYNDHAM ESTATES INVESTMENTS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    CLIPSTREAM LIMITED02 avr. 199102 avr. 1991

    Quels sont les derniers comptes de WYNDHAM ESTATES INVESTMENTS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2014

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour WYNDHAM ESTATES INVESTMENTS LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour WYNDHAM ESTATES INVESTMENTS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Déclaration annuelle jusqu'au 02 avr. 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital25 avr. 2015

    État du capital au 25 avr. 2015

    • Capital: GBP 1,000
    SH01

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mars 2014

    4 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 02 avr. 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital08 mai 2014

    État du capital au 08 mai 2014

    • Capital: GBP 1,000
    SH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mars 2013

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 02 avr. 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mars 2012

    6 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de * 5Th Floor 7-10 Chandos Street London W1G 9DQ* le 06 août 2012

    1 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 02 avr. 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mars 2011

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 02 avr. 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Paula Marber le 30 juin 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Paul Brian Marber le 30 juin 2010

    2 pagesCH01

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 mars 2010

    6 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 02 avr. 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Nomination de Mr Selwyn Jacoby Foreman en tant que secrétaire

    2 pagesAP03

    Modification des coordonnées de l'administrateur Paula Marber le 07 janv. 2010

    2 pagesCH01

    Cessation de la nomination de Barry Foreman en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 mars 2009

    6 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de WYNDHAM ESTATES INVESTMENTS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    FOREMAN, Selwyn Jacoby
    Vernon Drive
    HA7 2BT Stanmore
    22
    Middlesex
    England
    Secrétaire
    Vernon Drive
    HA7 2BT Stanmore
    22
    Middlesex
    England
    150478240001
    MARBER, Paul Brian
    Willowdene, View Road
    Highgate
    N6 4DE London
    2
    United Kingdom
    Administrateur
    Willowdene, View Road
    Highgate
    N6 4DE London
    2
    United Kingdom
    EnglandBritishChartered Surveyor720480004
    MARBER, Paula
    Willowdene, View Road
    Highgate
    N6 4DE London
    2
    United Kingdom
    Administrateur
    Willowdene, View Road
    Highgate
    N6 4DE London
    2
    United Kingdom
    EnglandBritishResearcher54046860002
    FOREMAN, Barry Anthony
    106 Chalkwell Avenue
    SS0 8NN Westcliff On Sea
    Essex
    Secrétaire
    106 Chalkwell Avenue
    SS0 8NN Westcliff On Sea
    Essex
    British720470002
    MARBER, Ian
    78 Cadogan Square
    SW1X 0EA London
    Secrétaire
    78 Cadogan Square
    SW1X 0EA London
    BritishEstate Agent68092180001
    CCS SECRETARIES LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Secrétaire désigné
    120 East Road
    N1 6AA London
    900001720001
    MARBER, Ian
    78 Cadogan Square
    SW1X 0EA London
    Administrateur
    78 Cadogan Square
    SW1X 0EA London
    BritishEstate Agent68092180001
    CCS DIRECTORS LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Administrateur désigné
    120 East Road
    N1 6AA London
    900001710001

    WYNDHAM ESTATES INVESTMENTS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Mortgage deed
    Créé le 13 déc. 2001
    Livré le 21 déc. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The property k/a land on the south west side of lottbridge drove eastbourne east sussex (unit 1 lottbridge drove) t/no: ESX137059. And all buildings fixtures and fixed plant and machinery from time to time on such property together with all estates rights title options and privileges appurtenant to or benefitting the same including all beneficial interests in the property. By way of fixed charge the benefit of all guarantees indemnities rent deposits agreements contracts undertakings and warranties relating to the property. By way of floating charge the undertaking property and assets and by way of assignment the goodwill of the business and all monies from time to time payable in relation to contracts or policies of insurance.
    Personnes ayant droit
    • Bristol & West PLC
    Transactions
    • 21 déc. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 févr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Deed of rental assignment
    Créé le 13 déc. 2001
    Livré le 21 déc. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All rent licence fees or other sums of money now or at any time received or recoverable by the company from any tenant or licencee of the property k/a land on the south west side of lottbridge drove eastbourne east sussex (unit 1 lottbridge drove) t/no: ESX137059.
    Personnes ayant droit
    • Bristol & West PLC
    Transactions
    • 21 déc. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 févr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Mortgage deed
    Créé le 26 janv. 1994
    Livré le 28 janv. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The sanctuary denbigh leisure centre denbigh milton keynes buckinghamshire together with all buildings structures and fixtures (including tade fixtures) and fixed plant and machinery from time to time, all moveable plant machinery implements utensils stock furniture equipment vehicles and other chattels owned hired leased or rented by the company. The benefit of the goodwill of the business and all present and future licences. Floating charge over all other undertakings and assets of the company whatsoever and wheresoever both present and future.
    Personnes ayant droit
    • Bristol & West Building Society
    Transactions
    • 28 janv. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 févr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Mortgage deed
    Créé le 04 juin 1993
    Livré le 10 juin 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Together with the old town hall guildhall street folkestone. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Bristol & West Building Society
    Transactions
    • 10 juin 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 févr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0