CAPITAL BANK PROPERTY INVESTMENTS (6) LIMITED

CAPITAL BANK PROPERTY INVESTMENTS (6) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCAPITAL BANK PROPERTY INVESTMENTS (6) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02599292
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CAPITAL BANK PROPERTY INVESTMENTS (6) LIMITED ?

    • Intermédiation financière n.c.a. (64999) / Activités financières et d'assurance

    Où se situe CAPITAL BANK PROPERTY INVESTMENTS (6) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de CAPITAL BANK PROPERTY INVESTMENTS (6) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    NWS PROPERTY INVESTMENTS (6) LIMITED10 mai 199110 mai 1991
    STRAYKAT LIMITED08 avr. 199108 avr. 1991

    Quels sont les derniers comptes de CAPITAL BANK PROPERTY INVESTMENTS (6) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 juin 2015

    Quels sont les derniers dépôts pour CAPITAL BANK PROPERTY INVESTMENTS (6) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    9 pagesLIQ13

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré Tower House Charterhall Drive Chester CH88 3AN

    2 pagesAD03

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de Tower House Charterhall Drive Chester CH88 3AN à Tower House Charterhall Drive Chester CH88 3AN

    2 pagesAD02

    Changement d'adresse du siège social de Charterhall House Charterhall Drive Chester Cheshire CH88 3AN à 1 More London Place London SE1 2AF le 28 oct. 2016

    2 pagesAD01

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée à Tower House Charterhall Drive Chester CH88 3AN

    2 pagesAD02

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    2 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 07 oct. 2016

    LRESSP

    Cessation de la nomination de Colin Graham Dowsett en tant que directeur le 09 sept. 2016

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Michelle Antoinette Angela Johnson en tant que secrétaire le 23 mars 2016

    1 pagesTM02

    Nomination de Lloyds Secretaries Limited en tant que secrétaire le 23 mars 2016

    2 pagesAP04

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 févr. 2016 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital01 févr. 2016

    État du capital au 01 févr. 2016

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Comptes annuels établis au 30 juin 2015

    17 pagesAA

    Cessation de la nomination de Kevin Charles Harris en tant que directeur le 30 sept. 2015

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr John Robert Turner en tant qu'administrateur le 23 sept. 2015

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Jonathan Scott Foster en tant que directeur le 05 mars 2015

    1 pagesTM01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Kevin Charles Harris le 06 mars 2015

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Gerard Ashley Fox le 06 mars 2015

    2 pagesCH01

    Comptes annuels établis au 30 juin 2014

    17 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 févr. 2015 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital03 févr. 2015

    État du capital au 03 févr. 2015

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Jonathan Scott Foster le 19 août 2014

    2 pagesCH01

    Comptes établis au 30 juin 2013

    18 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 févr. 2014 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital04 févr. 2014

    État du capital au 04 févr. 2014

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Cessation de la nomination de Paul Gittins en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Qui sont les dirigeants de CAPITAL BANK PROPERTY INVESTMENTS (6) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    LLOYDS SECRETARIES LIMITED
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    United Kingdom
    Secrétaire
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement02791894
    73512200003
    FOX, Gerard Ashley
    London Wall
    EC2Y 5AJ London
    125
    United Kingdom
    Administrateur
    London Wall
    EC2Y 5AJ London
    125
    United Kingdom
    EnglandBritish179100520001
    TURNER, John Robert
    London Wall
    EC2Y 5AJ London
    125
    United Kingdom
    Administrateur
    London Wall
    EC2Y 5AJ London
    125
    United Kingdom
    EnglandBritish76185650001
    GITTINS, Paul
    House
    Charterhall Drive
    CH88 3AN Chester
    Tower
    United Kingdom
    Secrétaire
    House
    Charterhall Drive
    CH88 3AN Chester
    Tower
    United Kingdom
    British45660860003
    JOHNSON, Michelle Antoinette Angela
    Floor East
    Tower House Charterhall Drive
    CH88 3AN Chester
    1st
    England
    England
    Secrétaire
    Floor East
    Tower House Charterhall Drive
    CH88 3AN Chester
    1st
    England
    England
    181101730001
    NIXON, Raymond
    Holly House The Steadings
    Wicker Lane, Guilden Sutton
    CH3 7EL Chester
    Cheshire
    Secrétaire
    Holly House The Steadings
    Wicker Lane, Guilden Sutton
    CH3 7EL Chester
    Cheshire
    British36433110016
    BALLINGALL, Stuart James
    39 Craigleith Drive
    EH4 3JU Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    39 Craigleith Drive
    EH4 3JU Edinburgh
    Midlothian
    British118506820001
    BARCLAY, William Gordon
    The Coulin
    122 Stanstead Road
    CR3 6AE Caterham
    Surrey
    Administrateur
    The Coulin
    122 Stanstead Road
    CR3 6AE Caterham
    Surrey
    British33196560002
    BOCHENSKI, Anthony Joseph John
    Greenacres
    Bryn Offa Lane
    CH7 6RQ Mold
    Flintshire
    Administrateur
    Greenacres
    Bryn Offa Lane
    CH7 6RQ Mold
    Flintshire
    United KingdomBritish145644720001
    BROWN, John Sydney
    15 Newick Avenue
    Little Aston
    B74 3DA Sutton Coldfield
    West Midlands
    Administrateur
    15 Newick Avenue
    Little Aston
    B74 3DA Sutton Coldfield
    West Midlands
    United KingdomBritish58961420001
    BUSH, Claude Harry
    51 Church Croft
    Dodleston
    CH4 9NT Chester
    Cheshire
    Administrateur
    51 Church Croft
    Dodleston
    CH4 9NT Chester
    Cheshire
    British427540002
    CHESSMAN, Steven David Russell
    Charterhall Drive
    CH88 3AN Chester
    Tower House
    United Kingdom
    Administrateur
    Charterhall Drive
    CH88 3AN Chester
    Tower House
    United Kingdom
    EnglandBritish135147710001
    DOWSETT, Colin Graham
    Old Broad Street
    EC2N 1HZ London
    33
    United Kingdom
    Administrateur
    Old Broad Street
    EC2N 1HZ London
    33
    United Kingdom
    EnglandBritish152332230001
    EDWARDS, Jayson
    Tresillian Terrace
    CF10 5BH Cardiff
    St William House
    United Kingdom
    Administrateur
    Tresillian Terrace
    CF10 5BH Cardiff
    St William House
    United Kingdom
    WalesBritish165227870001
    FOSTER, Jonathan Scott
    Gresham Street
    EC2V 7AE London
    10
    United Kingdom
    Administrateur
    Gresham Street
    EC2V 7AE London
    10
    United Kingdom
    EnglandBritish59795070002
    GRACE, Adrian Thomas
    Charterhall Drive
    CH88 3AN Chester
    Charterhall House
    Cheshire
    Administrateur
    Charterhall Drive
    CH88 3AN Chester
    Charterhall House
    Cheshire
    British128752720001
    GRIFFITHS, Michael John David, Mr.
    House
    Charterhall Drive
    CH88 3AN Chester
    Tower
    United Kingdom
    Administrateur
    House
    Charterhall Drive
    CH88 3AN Chester
    Tower
    United Kingdom
    United KingdomBritish95344900001
    HAN, Philip James
    124 Mather Avenue
    L18 7HB Liverpool
    Merseyside
    Administrateur
    124 Mather Avenue
    L18 7HB Liverpool
    Merseyside
    EnglandBritish74160910001
    HARE, Robert Brown
    13 Balgreen Avenue
    EH12 5SX Edinburgh
    Lothian
    Administrateur
    13 Balgreen Avenue
    EH12 5SX Edinburgh
    Lothian
    British64474720003
    HARRIS, Kevin Charles
    London Wall
    EC2Y 5AJ London
    125
    United Kingdom
    Administrateur
    London Wall
    EC2Y 5AJ London
    125
    United Kingdom
    United KingdomBritish170091040001
    HOLME, Judith Angela
    House
    Charterhall Drive
    CH88 3AN Chester
    Tower
    United Kingdom
    Administrateur
    House
    Charterhall Drive
    CH88 3AN Chester
    Tower
    United Kingdom
    United KingdomBritish139386690001
    LITTLER, Roy
    3 The Paddock
    Curzon Park
    CH4 8AE Chester
    Cheshire
    Administrateur
    3 The Paddock
    Curzon Park
    CH4 8AE Chester
    Cheshire
    British2211250001
    MERCER, John Alexander
    Llwyn-Y-Cyll
    Lixwm
    CH8 8LY Holywell
    Clwyd
    Administrateur
    Llwyn-Y-Cyll
    Lixwm
    CH8 8LY Holywell
    Clwyd
    British4672880001
    MORRISON, Edward James
    50 Foresters Lea Crescent
    KY12 7TF Dunfermline
    Fife
    Administrateur
    50 Foresters Lea Crescent
    KY12 7TF Dunfermline
    Fife
    British79242190001
    MORRISSEY, John Michael
    House
    Charterhall Drive
    CH88 3AN Chester
    Tower
    United Kingdom
    Administrateur
    House
    Charterhall Drive
    CH88 3AN Chester
    Tower
    United Kingdom
    EnglandBritish94094650001
    REID, George Gibson
    46/1 Morningside Park
    EH10 5HA Edinburgh
    Lothian
    Administrateur
    46/1 Morningside Park
    EH10 5HA Edinburgh
    Lothian
    British95498730001
    RITCHIE, Carol Ann
    34 Hob Hey Lane
    Culcheth
    WA3 4NW Warrington
    Cheshire
    Administrateur
    34 Hob Hey Lane
    Culcheth
    WA3 4NW Warrington
    Cheshire
    EnglandBritish46402710001
    STAPLES, Martin Kenneth
    1 Douglas Drive
    Crossford
    KY12 8PB Dunfermline
    Fife
    Administrateur
    1 Douglas Drive
    Crossford
    KY12 8PB Dunfermline
    Fife
    ScotlandBritish110383950001
    TRACE, James Owen
    House
    Charterhall Drive
    CH88 3AN Chester
    Tower
    United Kingdom
    Administrateur
    House
    Charterhall Drive
    CH88 3AN Chester
    Tower
    United Kingdom
    EnglandBritish159477760001
    WEBSTER, Alistair Linn
    7 Ettrick Road
    EH10 5BJ Edinburgh
    Administrateur
    7 Ettrick Road
    EH10 5BJ Edinburgh
    ScotlandBritish60101190002

    CAPITAL BANK PROPERTY INVESTMENTS (6) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Letter of charge
    Créé le 19 juin 1996
    Livré le 10 juil. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All monies standing to the credit of any account or accounts in the banks books.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 10 juil. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 mai 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Letter of charge
    Créé le 20 févr. 1995
    Livré le 22 févr. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the principal debtors (as defined) to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All monies standing to the credit of any account or accounts of the company in the banks books.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 22 févr. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 août 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Letter of charge
    Créé le 13 déc. 1994
    Livré le 23 déc. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due owing from "the principal debtors" (as defined in the schedule) or any of them to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All monies standing to the credit of any account of the company in the bank`s books. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 23 déc. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 févr. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Letter of charge
    Créé le 12 août 1993
    Livré le 20 août 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All monies standing to the credit of any account of the company in the banks books.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 20 août 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 janv. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    CAPITAL BANK PROPERTY INVESTMENTS (6) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    07 oct. 2016Commencement of winding up
    26 déc. 2017Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Richard Barker
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    practitioner
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Samantha Keen
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    practitioner
    1 More London Place
    SE1 2AF London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0