CARWARDINE LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCARWARDINE LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02600029
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CARWARDINE LIMITED ?

    • (5139) /
    • (5211) /
    • (5530) /

    Où se situe CARWARDINE LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Rsm Robson Rhodes Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de CARWARDINE LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    REWARDFUTURE LIMITED10 avr. 199110 avr. 1991

    Quels sont les derniers comptes de CARWARDINE LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au27 mars 2005

    Quels sont les derniers dépôts pour CARWARDINE LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Avis de transition de l'administration à la dissolution le 18 mai 2010

    12 pages2.35B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 23 oct. 2009

    10 pages2.24B

    Avis de prolongation de la période de l'administration

    1 pages2.31B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 23 avr. 2009

    10 pages2.24B

    Avis de prolongation de la période de l'administration

    1 pages2.31B

    Avis de prolongation de la période de l'administration

    1 pages2.31B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 23 oct. 2008

    8 pages2.24B

    Avis de prolongation de la période de l'administration

    1 pages2.31B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 23 avr. 2008

    7 pages2.24B

    Avis de nomination d'un administrateur de remplacement/supplémentaire

    1 pages2.40B

    Avis de prolongation de la période de l'administration

    1 pages2.31B

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    9 pages2.24B

    Déclaration des affaires

    9 pages2.16B

    Déclaration de la proposition de l'administrateur

    21 pages2.17B

    Nomination d'un administrateur

    1 pages2.12B

    legacy

    1 pages287

    legacy

    3 pages363a

    Comptes annuels établis au 27 mars 2005

    16 pagesAA

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    7 pages363s

    legacy

    1 pages288b

    Comptes annuels établis au 28 mars 2004

    16 pagesAA

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    3 pages288a

    Qui sont les dirigeants de CARWARDINE LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    HUNTER, Graham George
    Karri House
    Hill Top Close, Stutton
    LS24 9TN Tadcaster
    North Yorkshire
    Secrétaire
    Karri House
    Hill Top Close, Stutton
    LS24 9TN Tadcaster
    North Yorkshire
    BritishDirector78700930001
    GRIMBLEBY, Frazer
    Joy Cottage Gilthwaites Lane
    Denby Dale
    HD8 8SE Huddersfield
    Yorkshire
    Administrateur
    Joy Cottage Gilthwaites Lane
    Denby Dale
    HD8 8SE Huddersfield
    Yorkshire
    BritishDirector98505100001
    HUNTER, Graham George
    Karri House
    Hill Top Close, Stutton
    LS24 9TN Tadcaster
    North Yorkshire
    Administrateur
    Karri House
    Hill Top Close, Stutton
    LS24 9TN Tadcaster
    North Yorkshire
    United KingdomBritishDirector78700930001
    BROWN, Anthony Roger Ernest
    19 Camp Road
    Clifton
    BS8 3LW Bristol
    Secrétaire
    19 Camp Road
    Clifton
    BS8 3LW Bristol
    British944930002
    HEATH, Simon Barrie
    Dog Kennel Farm
    Grove Road
    DN22 0RN Retford
    Nottinghamshire
    Secrétaire
    Dog Kennel Farm
    Grove Road
    DN22 0RN Retford
    Nottinghamshire
    BritishChartered Accountant23290420004
    LUDLEY, Susan Jane
    Flat 6 54 Compayne Gardens
    NW6 3RY London
    Secrétaire
    Flat 6 54 Compayne Gardens
    NW6 3RY London
    BritishAccountant58112210001
    MARTIN, John Hampden
    16 Stony Street
    BA11 1BU Frome
    Somerset
    Secrétaire
    16 Stony Street
    BA11 1BU Frome
    Somerset
    British75670830003
    MORELLO, Robin Clive
    30 Upper Belgrave Road
    Clifton
    BS8 2XL Bristol
    Secrétaire
    30 Upper Belgrave Road
    Clifton
    BS8 2XL Bristol
    British20082640002
    ORAM, Lianne Tracy
    Hall Floor Flat 76 Cotham Road
    Cotham
    BS6 6DW Bristol
    Avon
    Secrétaire
    Hall Floor Flat 76 Cotham Road
    Cotham
    BS6 6DW Bristol
    Avon
    BritishTrainee Solicitor12261420001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secrétaire désigné
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BOYCE, Crispin John
    125 Pembroke Road
    Clifton
    BS8 3ES Bristol
    Avon
    Administrateur
    125 Pembroke Road
    Clifton
    BS8 3ES Bristol
    Avon
    BritishSolicitor5620950001
    BROACKES, Simon Nigel
    Flat 61 The Piper Building
    Peterborough Road
    SW6 3EF London
    Administrateur
    Flat 61 The Piper Building
    Peterborough Road
    SW6 3EF London
    BritishManager62000870001
    BROWN, Anthony Roger Ernest
    19 Camp Road
    Clifton
    BS8 3LW Bristol
    Administrateur
    19 Camp Road
    Clifton
    BS8 3LW Bristol
    EnglandBritishCompany Secretary944930002
    HEATH, Simon Barrie
    Dog Kennel Farm
    Grove Road
    DN22 0RN Retford
    Nottinghamshire
    Administrateur
    Dog Kennel Farm
    Grove Road
    DN22 0RN Retford
    Nottinghamshire
    EnglandBritishChartered Accountant23290420004
    LANG, Stewart Reid
    17 Latham Road
    CB2 2EG Cambridge
    Cambridgeshire
    Administrateur
    17 Latham Road
    CB2 2EG Cambridge
    Cambridgeshire
    BritishEngineer37105830002
    LLOYD JONES, Gareth Victor
    50 Epirus Road
    Fulham
    SW6 7UH London
    Administrateur
    50 Epirus Road
    Fulham
    SW6 7UH London
    BritishRetailer45941250001
    MARTIN, John Hampden
    16 Stony Street
    BA11 1BU Frome
    Somerset
    Administrateur
    16 Stony Street
    BA11 1BU Frome
    Somerset
    BritishAccountant75670830003
    MAYES, Colin Michael
    23 Highfields
    MK45 5EN Westoning
    Bedfordshire
    Administrateur
    23 Highfields
    MK45 5EN Westoning
    Bedfordshire
    United KingdomBritishCompany Director114290120001
    MORELLO, Robin Clive
    30 Upper Belgrave Road
    Clifton
    BS8 2XL Bristol
    Administrateur
    30 Upper Belgrave Road
    Clifton
    BS8 2XL Bristol
    BritishCoffee Merchant20082640002
    ORAM, Lianne Tracy
    Hall Floor Flat 76 Cotham Road
    Cotham
    BS6 6DW Bristol
    Avon
    Administrateur
    Hall Floor Flat 76 Cotham Road
    Cotham
    BS6 6DW Bristol
    Avon
    BritishTrainee Solicitor12261420001
    SCOTT, Richard John
    Mill Road
    SL7 1QB Marlow
    Fulshaw Court
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Mill Road
    SL7 1QB Marlow
    Fulshaw Court
    Buckinghamshire
    EnglandBritishChartered Accountant139713290001
    WEST, Colin Roy
    15 Sherford Road
    Haydon Wick
    SN25 3PR Swindon
    Administrateur
    15 Sherford Road
    Haydon Wick
    SN25 3PR Swindon
    BritishBusiness Consultant34775170001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Administrateur désigné
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    CARWARDINE LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Guarantee & debenture
    Créé le 25 nov. 2003
    Livré le 02 déc. 2003
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 02 déc. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 22 oct. 2002
    Livré le 08 nov. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 08 nov. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 nov. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 04 août 1994
    Livré le 09 août 1994
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 09 août 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 sept. 1997Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    Fixed charge
    Créé le 31 mai 1993
    Livré le 18 juin 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £100,000 and all monies due or to become due under the terms of secured loan stock
    Brèves mentions
    Fixed charge on all goodwill and uncalled capital for the time being of the company; and all patents patent applications inventions trade marks trade names etc. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Monument Trust Company Limited and Colin Roy West
    Transactions
    • 18 juin 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 sept. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 22 avr. 1992
    Livré le 01 mai 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys due or to become due from the company to meacham douglas and co limited pursuant to the terms of a loan agreement dated 14-11-1991.
    Brèves mentions
    By way of first legal charge all estates rights title and other interest in all that freehold property known as 56 corn street, bristol.
    Personnes ayant droit
    • Meacham Douglas and Co Limited
    Transactions
    • 01 mai 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 avr. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 22 avr. 1992
    Livré le 01 mai 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys due or to become due from the company to meacham douglas and co limited pursuant to the terms of a loan agreement dated 14-11-1991.
    Brèves mentions
    By way of first legal charge all estates rights ,title and other interest in all that leasehold property known as 60 cornwall stret ,plymouth.
    Personnes ayant droit
    • Mecham Douglas and Co Limited
    Transactions
    • 01 mai 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 avr. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 22 avr. 1992
    Livré le 01 mai 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys due ro to become due from the company to meacham douglas and co limited pursuant to the terms of a loan agreement dated 14-11-1991.
    Brèves mentions
    By way of first legal charge all estates rigths ,title and other interest in all that leasehold property known as 10 holland walk ,barnstaple, devon title no dn 215978 .
    Personnes ayant droit
    • Meacham Douglas and Co Limited
    Transactions
    • 01 mai 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 avr. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 22 avr. 1992
    Livré le 01 mai 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys due or to become due from the company to meacham douglas and co limited pursuant to the terms of a loan agreement dated 14-11-1991.
    Brèves mentions
    By way of first legal charge all estates ,rights title and other interest in all that leasehold property known as unit 0 merchants quay ,gloucester docks, gloucester.
    Personnes ayant droit
    • Meacham Douglas and Co Limited
    Transactions
    • 01 mai 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 avr. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 22 avr. 1992
    Livré le 01 mai 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys due or to become due from the company to douglas meacham and co limited under the terms of a loan agreement dated 14-11-1991.
    Brèves mentions
    By way of first legal charge all estate rights title and other interest in all taht leasehold property known as 32 princesshay ,exeter.
    Personnes ayant droit
    • Meacham Douglas and Co Limited
    Transactions
    • 01 mai 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 avr. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 22 avr. 1992
    Livré le 01 mai 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to douglas meacham and co limited pursuant to the terms of a loan agreement dated 14TH nov 1991.
    Brèves mentions
    By way of first legal charge all estates rights title and interest in all that leasehold property known as 1 princess victoria street ,clifton, bristol.
    Personnes ayant droit
    • Meacham Douglas and Co Limited.
    Transactions
    • 01 mai 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 avr. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Rent deposit deed
    Créé le 12 févr. 1992
    Livré le 14 févr. 1992
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brèves mentions
    £2,412.50 and any additional amounts paid in an account with national westminster bank PLC.
    Personnes ayant droit
    • The Trustees of All Saints Church Lands
    Transactions
    • 14 févr. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    Rent deposit account agreement
    Créé le 04 déc. 1991
    Livré le 06 déc. 1991
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a lease dated 3 june 1987
    Brèves mentions
    £2875 held in a deposit account in the name of the assignee at the royal bank of scotland 67 lombard street london EC3.
    Personnes ayant droit
    • B S Pension Fund Trustee Limited
    Transactions
    • 06 déc. 1991Enregistrement d'une charge (395)
    Mortgage debenture
    Créé le 08 juil. 1991
    Livré le 11 juil. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 11 juil. 1991Enregistrement d'une charge
    • 01 mai 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    CARWARDINE LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    18 mai 2010Administration ended
    24 avr. 2007Administration started
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Simon Peter Bower
    Rsm Robson Rhodes Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    practitioner
    Rsm Robson Rhodes Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    David Michael Riley
    Rsm Robson Rhodes Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    practitioner
    Rsm Robson Rhodes Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Martin Gilbert Ellis
    30 Finsbury Square
    London
    EC2P 2YU
    practitioner
    30 Finsbury Square
    London
    EC2P 2YU

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0