SUNSHARE VACATIONS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSUNSHARE VACATIONS LIMITED
    Statut de la sociétéConverti / Fermé
    Forme juridiqueConverti ou fermé
    Numéro de société 02601069
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de SUNSHARE VACATIONS LIMITED ?

    • Activités des agences de voyages (79110) / Activités administratives et de soutien

    Où se situe SUNSHARE VACATIONS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    1 Angel Square
    M60 0AG Manchester
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de SUNSHARE VACATIONS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    TIMESHARE TRAVEL INTERNATIONAL LIMITED21 mai 199121 mai 1991
    CONNCO 6 LIMITED12 avr. 199112 avr. 1991

    Quels sont les derniers comptes de SUNSHARE VACATIONS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au11 janv. 2015

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour SUNSHARE VACATIONS LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour SUNSHARE VACATIONS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Divers

    Forms b & z convert to rs
    2 pagesMISC

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Convert to rs 06/07/2016
    RES13

    État du capital après une attribution d'actions au 06 juil. 2016

    • Capital: GBP 100,002
    3 pagesSH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 sept. 2015 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital02 sept. 2015

    État du capital au 02 sept. 2015

    • Capital: GBP 100,000
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 11 janv. 2015

    3 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 sept. 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital01 sept. 2014

    État du capital au 01 sept. 2014

    • Capital: GBP 100,000
    SH01

    Cessation de la nomination de Patrick Moynihan en tant que directeur le 30 juin 2014

    1 pagesTM01

    Nomination de Andrew Paul Lang en tant qu'administrateur le 30 juin 2014

    2 pagesAP01

    Comptes pour une société dormante établis au 11 janv. 2014

    3 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 sept. 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital04 sept. 2013

    État du capital au 04 sept. 2013

    • Capital: GBP 100,000
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Patrick Moynihan le 01 sept. 2013

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Cws (No.1) Limited le 01 sept. 2013

    2 pagesCH02

    Comptes pour une société dormante établis au 11 janv. 2013

    3 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de * 1 Angel Square Manchester M60 0AG United Kingdom* le 03 déc. 2012

    1 pagesAD01

    Changement d'adresse du siège social de * New Century House Corporation Street Manchester M60 4ES* le 03 déc. 2012

    1 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 sept. 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 11 janv. 2012

    3 pagesAA

    Cessation de la nomination de Paul Hemingway en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Cws (No.1) Limited en tant qu'administrateur

    2 pagesAP02

    Nomination de Mr Patrick Moynihan en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Michael Greenacre en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 sept. 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 11 janv. 2011

    3 pagesAA

    Cessation de la nomination de Neil Braithwaite en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 11 janv. 2010

    3 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de SUNSHARE VACATIONS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    SELLERS, Caroline Jane
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    United Kingdom
    Secrétaire
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    United Kingdom
    British45801060004
    LANG, Andrew Paul
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    United Kingdom
    Administrateur
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    United Kingdom
    United KingdomBritish170146830001
    CWS (NO.1) LIMITED
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    England
    Administrateur
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    England
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement1925625
    130695310001
    CROCKER, John
    16 Hartington Road
    High Lane
    SK6 8BY Stockport
    Cheshire
    Secrétaire
    16 Hartington Road
    High Lane
    SK6 8BY Stockport
    Cheshire
    British9467540001
    FITZSIMONS, Elizabeth
    24 Everett Road
    Withington
    M20 3DZ Manchester
    Lancashire
    Secrétaire
    24 Everett Road
    Withington
    M20 3DZ Manchester
    Lancashire
    British11723940001
    TAYLOR, Karen Ann
    18 Covent Garden
    Hillgate
    SK1 3AX Stockport
    Cheshire
    Secrétaire
    18 Covent Garden
    Hillgate
    SK1 3AX Stockport
    Cheshire
    British82241590001
    WHITTAKER, Katherine Alison
    22 Westfield Drive
    Woodley
    SK6 1LD Stockport
    Cheshire
    Secrétaire
    22 Westfield Drive
    Woodley
    SK6 1LD Stockport
    Cheshire
    British29899300002
    BRAITHWAITE, Neil
    74 Stockton Lane
    YO31 1BN York
    Administrateur
    74 Stockton Lane
    YO31 1BN York
    EnglandBritish87486660004
    BRAITHWAITE, Neil
    74 Stockton Lane
    YO31 1BN York
    Administrateur
    74 Stockton Lane
    YO31 1BN York
    EnglandBritish87486660004
    BRIERLEY, Lee David
    6 Tower View
    Belthorn
    BB1 2PD Blackburn
    Lancashire
    Administrateur
    6 Tower View
    Belthorn
    BB1 2PD Blackburn
    Lancashire
    British15056200001
    CROCKER, John
    16 Hartington Road
    High Lane
    SK6 8BY Stockport
    Cheshire
    Administrateur
    16 Hartington Road
    High Lane
    SK6 8BY Stockport
    Cheshire
    British9467540001
    DAWSON, Peter
    8 Culcheth Hall Farm Barns
    Withington Avenue
    WA3 4AJ Culcheth
    Cheshire
    Administrateur
    8 Culcheth Hall Farm Barns
    Withington Avenue
    WA3 4AJ Culcheth
    Cheshire
    British94606430002
    FITZSIMONS, Elizabeth
    259 Bunch Road
    West Dodsbury
    N20 8WA Manchester
    Administrateur
    259 Bunch Road
    West Dodsbury
    N20 8WA Manchester
    British35525890001
    GREENACRE, Michael David
    57 Springfield Lane
    Eccleston
    WA10 5HB St Helens
    Merseyside
    Administrateur
    57 Springfield Lane
    Eccleston
    WA10 5HB St Helens
    Merseyside
    EnglandBritish74808750001
    HEMINGWAY, Paul Andrew
    71 Southworth Road
    WA12 0BL Newton Le Willows
    St Helens
    Administrateur
    71 Southworth Road
    WA12 0BL Newton Le Willows
    St Helens
    United KingdomBritish188221460001
    LOCKLEY, Kenneth Morton
    59 Prestwich Hills
    Prestwich
    M25 9PY Manchester
    Administrateur
    59 Prestwich Hills
    Prestwich
    M25 9PY Manchester
    British47510860001
    MCPHERSON, Kenneth
    Oaklands Drive
    WA13 0NF Lymm
    1
    Cheshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Oaklands Drive
    WA13 0NF Lymm
    1
    Cheshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish224051820001
    MELLING, Christopher Eric
    21 Avonhead Close
    Horwich
    BL6 5QD Bolton
    Lancashire
    Administrateur
    21 Avonhead Close
    Horwich
    BL6 5QD Bolton
    Lancashire
    EnglandBritish58695390001
    MOYNIHAN, Patrick
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    England
    Administrateur
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    England
    United KingdomBritish87719730001
    NEILD, Peter David
    27 Longwood Close
    Romiley
    SK6 4LR Stockport
    Cheshire
    Administrateur
    27 Longwood Close
    Romiley
    SK6 4LR Stockport
    Cheshire
    British5032890001
    O'MALLEY, Patrick Joseph
    Flat 6 25 Old Lansdowne Road
    West Didsbury
    M20 8BP Manchester
    Administrateur
    Flat 6 25 Old Lansdowne Road
    West Didsbury
    M20 8BP Manchester
    British19526740001
    PENNINGTON, Kenneth
    198 Buxton Road
    Davenport
    SK2 7AE Stockport
    Cheshire
    Administrateur
    198 Buxton Road
    Davenport
    SK2 7AE Stockport
    Cheshire
    British18956410001
    PERRIN, Nicholas John
    Westfield
    5 Hough Lane
    SK9 2LG Wilmslow
    Cheshire
    Administrateur
    Westfield
    5 Hough Lane
    SK9 2LG Wilmslow
    Cheshire
    British80173660001
    SEMP, Malcolm
    33 Park Lane
    Whitefield
    M45 7HL Manchester
    Administrateur
    33 Park Lane
    Whitefield
    M45 7HL Manchester
    EnglandBritish91218510001
    SMALL, Trevor
    8 Ringley Road West
    Radcliffe
    M26 1DJ Manchester
    Lancashire
    Administrateur
    8 Ringley Road West
    Radcliffe
    M26 1DJ Manchester
    Lancashire
    EnglandBritish65687500002
    SPEIGHT, Andrew Jonathan
    12 Arcadia Avenue
    BH8 9ER Bournemouth
    Dorset
    Administrateur
    12 Arcadia Avenue
    BH8 9ER Bournemouth
    Dorset
    EnglandBritish105606860001
    WILLIAMS, Amanda Jane
    Watersedge 1 High Grove Road
    Grasscroft
    OL4 4HG Saddleworth
    Administrateur
    Watersedge 1 High Grove Road
    Grasscroft
    OL4 4HG Saddleworth
    British87240350002

    SUNSHARE VACATIONS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Charge over credit balances
    Créé le 15 juin 1998
    Livré le 18 juin 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The sum of £20,000.00 together with interest accrued now or to be held by the bank on account numbered 43091636.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 18 juin 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 févr. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge over credit balances
    Créé le 15 août 1997
    Livré le 21 août 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee in relation to a bond dated 8TH august 1997 in favour of the association of british travel agents limited for £7,500
    Brèves mentions
    The sum of £7,5OO together interest accrued now or to be held by national westminster bank PLC on an account numbered 43091636 and earmarked or designated by reference to the company.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 21 août 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 mars 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of charge over credit balances
    Créé le 17 juin 1997
    Livré le 03 juil. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever in relation to a bond dated 2 september 1996 in favour of the association of british travel agents for £5,400
    Brèves mentions
    £5,400 together with interest accrued now or to be held by the bank on account number 43091636.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 03 juil. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 mars 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge over credit balances
    Créé le 27 août 1996
    Livré le 03 sept. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever in relation to three bonds in favour of the association of british travel agents limited for £191,935.00, £5,400.00 and £65,004.00 respectively
    Brèves mentions
    The sum of £262,339 together with interest held by the bank on an account numbered 43091636 and designated by reference to the company.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 03 sept. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 mars 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge over credit balances
    Créé le 19 juil. 1996
    Livré le 30 juil. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee in relation to 3 bonds in favour of the association of british travel agents for £191,135 £5,000 and £65004
    Brèves mentions
    The sum of £261,939 together with interest accrued now or to be held by the bank on account no:-43091636 and earmarked or designated by reference to the company.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 30 juil. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 mars 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge over credit balances
    Créé le 29 nov. 1995
    Livré le 06 déc. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever in relation to two bonds in favour of the association of british travel agents limited for £191,935 and £5,000
    Brèves mentions
    The sum of £196,935 together with interest accrued now or to be held by national westminster bank PLC on an account numbered 43091636 and earmarked or designated by reference to the company.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 06 déc. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 mars 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge over credit balances
    Créé le 04 août 1995
    Livré le 10 août 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee in relation to three bonds in favour of the association of british travel agents for £20,000 £156,600 and £10,000 respectively
    Brèves mentions
    The sum of £186,000 together with interest accrued now or to be held by the bank on an account numbered 43091636.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 10 août 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 mars 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge over credit balances
    Créé le 09 janv. 1995
    Livré le 13 janv. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee in relation to two bonds in favour of the association of british travel agents limited for £20,000 and £156,600
    Brèves mentions
    The sum of £176,600 together with the interest accrued now or to be held by national westminster bank PLC on an account numbered 43091636 and earmarked or designated by reference to the company.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 13 janv. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 mars 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge over credit balances
    Créé le 30 août 1994
    Livré le 14 sept. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee in relation to two bonds in favour of the association of british travel agents limited for £20,000 and £70,239
    Brèves mentions
    The sum of £90,239 together with interest accrued now or to be held by nationalwestminster bank PLC on account numbered 43091636 and earmarked or designated by reference to the company.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 14 sept. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 juil. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge over credit balances
    Créé le 29 avr. 1994
    Livré le 13 mai 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee in relation to a bond in favour of the association of british travel agents limited for £10,000
    Brèves mentions
    The sum of £10,000 together with interest accrued now or to be held by national westminster bank PLC on an acount numbered 43091636 and earmarked or designated by reference to the company.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 13 mai 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 juil. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Memorandum of cash deposit
    Créé le 13 janv. 1994
    Livré le 15 janv. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The sum of £40,239 credited to account number/designation 13128663 with the bank together with all sums in the future credited to that account and including all interest accrued or accruing in the future on the account.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 15 janv. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 févr. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0