TEREX LIFTING U.K. LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | TEREX LIFTING U.K. LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 02602451 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe TEREX LIFTING U.K. LIMITED ?
| Adresse du siège social | The Pinnacle 170 Midsummer Boulevard MK9 1FE Milton Keynes |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de TEREX LIFTING U.K. LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2015 |
Quels sont les derniers dépôts pour TEREX LIFTING U.K. LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||
État du capital au 29 juin 2017
| 5 pages | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
État du capital après une attribution d'actions au 23 juin 2017
| 3 pages | SH01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 17 avr. 2017 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Nomination de John Daniel Sheehan en tant qu'administrateur le 27 févr. 2017 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Kevin Patrick Bradley en tant que directeur le 27 févr. 2017 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2015 | 7 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 17 avr. 2016 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessation de la nomination de Ronald Matthew Defeo en tant que directeur le 11 déc. 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2014 | 7 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 17 avr. 2015 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2013 | 7 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 17 avr. 2014 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2012 | 7 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 17 avr. 2013 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
Nomination de Mr Kevin Patrick Bradley en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Phillip Widman en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2011 | 7 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 17 avr. 2012 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Ronald Matthew Defeo le 17 avr. 2012 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de TEREX LIFTING U.K. LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COHEN, Eric I | Secrétaire | Burnham Hill Road Westport Connecticut, 06880 32 Fairfield Usa | American | 65582430009 | ||||||
| COHEN, Eric I | Administrateur | Burnham Hill Road Westport Connecticut, 06880 32 Fairfield Usa | United States | American | 65582430009 | |||||
| SHEEHAN, John Daniel | Administrateur | 200 Nyala Farm Road 06880 Westport C/O Terex Corporation Usa | United States | American | 226001330001 | |||||
| BROOKES, Howard Maurice | Secrétaire | 14 Ryknild Close Four Oaks B74 4UP Sutton Coldfield West Midlands | British | 662930001 | ||||||
| HARRIS, Andrew David | Secrétaire | Forest Cottage 20 High St Henley In Arden B95 5AG Solihull West Midlands | British | 47665710002 | ||||||
| MANDERS, Douglas Nigel | Secrétaire désigné | 44 Beebee Road WS10 9RX Wednesbury West Midlands | British | 900003700001 | ||||||
| APUZZO, Joseph | Administrateur | 190 Sturges Ridge Road Wilton Fairfield 06897 Usa | American | 66269020001 | ||||||
| BAILLIE, Fergus Cumming | Administrateur | 4 Abinger Gardens Murrayfield EH12 6DE Edinburgh Scotland | British | 924340002 | ||||||
| BRADLEY, Kevin Patrick | Administrateur | 170 Midsummer Boulevard MK9 1FE Milton Keynes The Pinnacle United Kingdom | Untied States Of America | American | 176590390001 | |||||
| COSGROVE, Barry | Administrateur | 11 Adair Avenue BT80 8PU Cookstown County Tyrone Northern Ireland | British | 13991920001 | ||||||
| CRAIG, John Egwin | Administrateur | Saxonbury House Frant TN3 9HJ Tunbridge Wells Kent | British | 15697900001 | ||||||
| DEFEO, Ronald Matthew | Administrateur | Beachside Avenue Westport 45 Connecticut 06880 Usa | United States | American | 94656950001 | |||||
| DOOEY, Hugh Pat | Administrateur | 14 Usnastraine Road BT71 5DE Coalisland Tyrone N Ireland | Northern Ireland | Irish | 115095900001 | |||||
| HARRIS, Andrew David | Administrateur | Forest Cottage 20 High St Henley In Arden B95 5AG Solihull West Midlands | British | 47665710002 | ||||||
| HARRIS, Andrew David | Administrateur | Forest Cottage 20 High St Henley In Arden B95 5AG Solihull West Midlands | British | 47665710002 | ||||||
| HOLMES, Edward | Administrateur | Rushford House Rushford Bridge GL12 8JW Wotton Under Edge Gloucestershire | British | 55964730001 | ||||||
| KENNERLEY, John Frank William | Administrateur | Old Westwick Chantry View Road GU1 3XW Guildford Surrey | United Kingdom | British | 69793560001 | |||||
| MANDERS, Douglas Nigel | Administrateur désigné | 44 Beebee Road WS10 9RX Wednesbury West Midlands | British | 900003700001 | ||||||
| MCGRATH, Brendan | Administrateur | 13 Newent Close Winyates Green B98 0QW Redditch Worcestershire | Irish | 38927470001 | ||||||
| MCKEOWN, Shay | Administrateur | 41 Tullycullion Road Dungannon County Tyrone Northern Ireland | Irish | 40247040001 | ||||||
| MURCHAN, Seamus Michael | Administrateur | 2 Ferndale Clonallon Road BT34 3FE Warrenpoint County Down | Northern Ireland | Northern Irish | 182530670001 | |||||
| NICHOLSON SMITH, James Timothy | Administrateur | Kings Farm Stockwell Lane, Woodmancote GL52 4QB Cheltenham Gloucestershire | British | 70851540001 | ||||||
| NOONE, Liam | Administrateur | 121 Malmesbury Road SN15 1PZ Chippenham Wiltshire | Irish | 47114340001 | ||||||
| REES, Andrew Merfyn | Administrateur | 114 Vivian Road Harborne B17 0DJ Birmingham West Midlands | British | 3425330001 | ||||||
| RICE, Michael Joseph | Administrateur | The Street GL9 1HH Acton Turville Greenfields Gloucestershire | United Kingdom | British | 140087640001 | |||||
| ROBERTSON, Colin | Administrateur | 4 Leemuir View ML8 4AN Carluke South Lanarkshire | British | 77076440001 | ||||||
| WATSON, Hubert John | Administrateur | 20 Victoria Grove Dollingstown Lurgan BT66 7JJ Craigavon County Armagh | British | 56996050003 | ||||||
| WIDMAN, Phillip Charles | Administrateur | 25 Old Stone Crossing West Simsbury Connecticut 06092 Usa | Usa | American | 144249950001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur TEREX LIFTING U.K. LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Powerscreen International (Uk) Limited | 06 avr. 2016 | 170 Midsummer Boulevard MK9 1FE Milton Keynes The Pinnacle England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
TEREX LIFTING U.K. LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Fixed charge on book and other debts | Créé le 16 mai 2002 Livré le 23 mai 2002 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed charge on all book debts and other debts. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Composite debenture | Créé le 04 mars 1999 Livré le 25 mars 1999 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the composite guarantee and indemnity and/or the master agreement (both as defined) | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Composite debenture | Créé le 04 mars 1999 Livré le 25 mars 1999 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the composite guarantee and indemnity and/or the master agreement (both as defined) | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Composite debenture | Créé le 04 mars 1999 Livré le 25 mars 1999 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the composite guarantee and indemnity and/or the master agreement (both as defined) | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Composite debenture | Créé le 04 mars 1999 Livré le 25 mars 1999 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the composite guarantee and indemnity and/or the master agreement (both as defined) | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Composite debenture | Créé le 04 mars 1999 Livré le 25 mars 1999 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Composite debenture | Créé le 26 mars 1998 Livré le 16 avr. 1998 | Totalement satisfaite | Montant garanti In favour of the governor and company of the bank of ireland as security trustee for the banks ("the secured parties") all monies due or to become due from the company to the secured parties or any of them whether collectively or individually by the company either alone or jointly with any person or company on any account under the terms and conditions as defined in the composite debenture | |
Brèves mentions A fixed charge over all the companys f/h and l/h lands hereditaments, premises, property and chattels both present and future including the property particulars of which are specified under the company's name in the second schedule hereto and all the company's interests in all buildings, fixtures (including, without limitation, trade fixtures) and the fixed plant and machinery from time to time thereon; all present and future plant machinery vehicles fixtures implements utensils and equipment, all goodwill and uncalled capital and all debts; floating charge over the book debts undertaking and all other property assets and rights whatsoever both present and future.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0