TEREX LIFTING U.K. LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéTEREX LIFTING U.K. LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02602451
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de TEREX LIFTING U.K. LIMITED ?

    • fabrication d'équipements de levage et de manutention (28220) / Industries manufacturières

    Où se situe TEREX LIFTING U.K. LIMITED ?

    Adresse du siège social
    The Pinnacle
    170 Midsummer Boulevard
    MK9 1FE Milton Keynes
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de TEREX LIFTING U.K. LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    MATBRO LIMITED16 août 199116 août 1991
    FORAY 292 LIMITED17 avr. 199117 avr. 1991

    Quels sont les derniers comptes de TEREX LIFTING U.K. LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2015

    Quels sont les derniers dépôts pour TEREX LIFTING U.K. LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 29 juin 2017

    • Capital: GBP 1
    5 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    État du capital après une attribution d'actions au 23 juin 2017

    • Capital: GBP 2,500,003
    3 pagesSH01

    Déclaration de confirmation établie le 17 avr. 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Nomination de John Daniel Sheehan en tant qu'administrateur le 27 févr. 2017

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Kevin Patrick Bradley en tant que directeur le 27 févr. 2017

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2015

    7 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 17 avr. 2016 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital25 avr. 2016

    État du capital au 25 avr. 2016

    • Capital: GBP 2,500,002
    SH01

    Cessation de la nomination de Ronald Matthew Defeo en tant que directeur le 11 déc. 2015

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2014

    7 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 17 avr. 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital17 avr. 2015

    État du capital au 17 avr. 2015

    • Capital: GBP 2,500,002
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2013

    7 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 17 avr. 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital28 avr. 2014

    État du capital au 28 avr. 2014

    • Capital: GBP 2,500,002
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2012

    7 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 17 avr. 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Nomination de Mr Kevin Patrick Bradley en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Phillip Widman en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2011

    7 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 17 avr. 2012 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Ronald Matthew Defeo le 17 avr. 2012

    2 pagesCH01

    Qui sont les dirigeants de TEREX LIFTING U.K. LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    COHEN, Eric I
    Burnham Hill Road
    Westport
    Connecticut, 06880
    32
    Fairfield
    Usa
    Secrétaire
    Burnham Hill Road
    Westport
    Connecticut, 06880
    32
    Fairfield
    Usa
    American65582430009
    COHEN, Eric I
    Burnham Hill Road
    Westport
    Connecticut, 06880
    32
    Fairfield
    Usa
    Administrateur
    Burnham Hill Road
    Westport
    Connecticut, 06880
    32
    Fairfield
    Usa
    United StatesAmerican65582430009
    SHEEHAN, John Daniel
    200 Nyala Farm Road
    06880 Westport
    C/O Terex Corporation
    Usa
    Administrateur
    200 Nyala Farm Road
    06880 Westport
    C/O Terex Corporation
    Usa
    United StatesAmerican226001330001
    BROOKES, Howard Maurice
    14 Ryknild Close
    Four Oaks
    B74 4UP Sutton Coldfield
    West Midlands
    Secrétaire
    14 Ryknild Close
    Four Oaks
    B74 4UP Sutton Coldfield
    West Midlands
    British662930001
    HARRIS, Andrew David
    Forest Cottage
    20 High St Henley In Arden
    B95 5AG Solihull
    West Midlands
    Secrétaire
    Forest Cottage
    20 High St Henley In Arden
    B95 5AG Solihull
    West Midlands
    British47665710002
    MANDERS, Douglas Nigel
    44 Beebee Road
    WS10 9RX Wednesbury
    West Midlands
    Secrétaire désigné
    44 Beebee Road
    WS10 9RX Wednesbury
    West Midlands
    British900003700001
    APUZZO, Joseph
    190 Sturges Ridge Road
    Wilton
    Fairfield
    06897
    Usa
    Administrateur
    190 Sturges Ridge Road
    Wilton
    Fairfield
    06897
    Usa
    American66269020001
    BAILLIE, Fergus Cumming
    4 Abinger Gardens
    Murrayfield
    EH12 6DE Edinburgh
    Scotland
    Administrateur
    4 Abinger Gardens
    Murrayfield
    EH12 6DE Edinburgh
    Scotland
    British924340002
    BRADLEY, Kevin Patrick
    170 Midsummer Boulevard
    MK9 1FE Milton Keynes
    The Pinnacle
    United Kingdom
    Administrateur
    170 Midsummer Boulevard
    MK9 1FE Milton Keynes
    The Pinnacle
    United Kingdom
    Untied States Of AmericaAmerican176590390001
    COSGROVE, Barry
    11 Adair Avenue
    BT80 8PU Cookstown
    County Tyrone
    Northern Ireland
    Administrateur
    11 Adair Avenue
    BT80 8PU Cookstown
    County Tyrone
    Northern Ireland
    British13991920001
    CRAIG, John Egwin
    Saxonbury House
    Frant
    TN3 9HJ Tunbridge Wells
    Kent
    Administrateur
    Saxonbury House
    Frant
    TN3 9HJ Tunbridge Wells
    Kent
    British15697900001
    DEFEO, Ronald Matthew
    Beachside Avenue
    Westport
    45
    Connecticut 06880
    Usa
    Administrateur
    Beachside Avenue
    Westport
    45
    Connecticut 06880
    Usa
    United StatesAmerican94656950001
    DOOEY, Hugh Pat
    14 Usnastraine Road
    BT71 5DE Coalisland
    Tyrone
    N Ireland
    Administrateur
    14 Usnastraine Road
    BT71 5DE Coalisland
    Tyrone
    N Ireland
    Northern IrelandIrish115095900001
    HARRIS, Andrew David
    Forest Cottage
    20 High St Henley In Arden
    B95 5AG Solihull
    West Midlands
    Administrateur
    Forest Cottage
    20 High St Henley In Arden
    B95 5AG Solihull
    West Midlands
    British47665710002
    HARRIS, Andrew David
    Forest Cottage
    20 High St Henley In Arden
    B95 5AG Solihull
    West Midlands
    Administrateur
    Forest Cottage
    20 High St Henley In Arden
    B95 5AG Solihull
    West Midlands
    British47665710002
    HOLMES, Edward
    Rushford House Rushford Bridge
    GL12 8JW Wotton Under Edge
    Gloucestershire
    Administrateur
    Rushford House Rushford Bridge
    GL12 8JW Wotton Under Edge
    Gloucestershire
    British55964730001
    KENNERLEY, John Frank William
    Old Westwick
    Chantry View Road
    GU1 3XW Guildford
    Surrey
    Administrateur
    Old Westwick
    Chantry View Road
    GU1 3XW Guildford
    Surrey
    United KingdomBritish69793560001
    MANDERS, Douglas Nigel
    44 Beebee Road
    WS10 9RX Wednesbury
    West Midlands
    Administrateur désigné
    44 Beebee Road
    WS10 9RX Wednesbury
    West Midlands
    British900003700001
    MCGRATH, Brendan
    13 Newent Close
    Winyates Green
    B98 0QW Redditch
    Worcestershire
    Administrateur
    13 Newent Close
    Winyates Green
    B98 0QW Redditch
    Worcestershire
    Irish38927470001
    MCKEOWN, Shay
    41 Tullycullion Road
    Dungannon
    County Tyrone
    Northern Ireland
    Administrateur
    41 Tullycullion Road
    Dungannon
    County Tyrone
    Northern Ireland
    Irish40247040001
    MURCHAN, Seamus Michael
    2 Ferndale
    Clonallon Road
    BT34 3FE Warrenpoint
    County Down
    Administrateur
    2 Ferndale
    Clonallon Road
    BT34 3FE Warrenpoint
    County Down
    Northern IrelandNorthern Irish182530670001
    NICHOLSON SMITH, James Timothy
    Kings Farm
    Stockwell Lane, Woodmancote
    GL52 4QB Cheltenham
    Gloucestershire
    Administrateur
    Kings Farm
    Stockwell Lane, Woodmancote
    GL52 4QB Cheltenham
    Gloucestershire
    British70851540001
    NOONE, Liam
    121 Malmesbury Road
    SN15 1PZ Chippenham
    Wiltshire
    Administrateur
    121 Malmesbury Road
    SN15 1PZ Chippenham
    Wiltshire
    Irish47114340001
    REES, Andrew Merfyn
    114 Vivian Road
    Harborne
    B17 0DJ Birmingham
    West Midlands
    Administrateur
    114 Vivian Road
    Harborne
    B17 0DJ Birmingham
    West Midlands
    British3425330001
    RICE, Michael Joseph
    The Street
    GL9 1HH Acton Turville
    Greenfields
    Gloucestershire
    Administrateur
    The Street
    GL9 1HH Acton Turville
    Greenfields
    Gloucestershire
    United KingdomBritish140087640001
    ROBERTSON, Colin
    4 Leemuir View
    ML8 4AN Carluke
    South Lanarkshire
    Administrateur
    4 Leemuir View
    ML8 4AN Carluke
    South Lanarkshire
    British77076440001
    WATSON, Hubert John
    20 Victoria Grove
    Dollingstown Lurgan
    BT66 7JJ Craigavon
    County Armagh
    Administrateur
    20 Victoria Grove
    Dollingstown Lurgan
    BT66 7JJ Craigavon
    County Armagh
    British56996050003
    WIDMAN, Phillip Charles
    25 Old Stone Crossing
    West Simsbury
    Connecticut 06092
    Usa
    Administrateur
    25 Old Stone Crossing
    West Simsbury
    Connecticut 06092
    Usa
    UsaAmerican144249950001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur TEREX LIFTING U.K. LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    170 Midsummer Boulevard
    MK9 1FE Milton Keynes
    The Pinnacle
    England
    06 avr. 2016
    170 Midsummer Boulevard
    MK9 1FE Milton Keynes
    The Pinnacle
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Limited Company
    Pays d'enregistrementEngland And Wales
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement03720364
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    TEREX LIFTING U.K. LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Fixed charge on book and other debts
    Créé le 16 mai 2002
    Livré le 23 mai 2002
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed charge on all book debts and other debts.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 23 mai 2002Enregistrement d'une charge (395)
    Composite debenture
    Créé le 04 mars 1999
    Livré le 25 mars 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the composite guarantee and indemnity and/or the master agreement (both as defined)
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transactions
    • 25 mars 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 sept. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Composite debenture
    Créé le 04 mars 1999
    Livré le 25 mars 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the composite guarantee and indemnity and/or the master agreement (both as defined)
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transactions
    • 25 mars 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 sept. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Composite debenture
    Créé le 04 mars 1999
    Livré le 25 mars 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the composite guarantee and indemnity and/or the master agreement (both as defined)
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Allied Irish Banks PLC
    Transactions
    • 25 mars 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 sept. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Composite debenture
    Créé le 04 mars 1999
    Livré le 25 mars 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the composite guarantee and indemnity and/or the master agreement (both as defined)
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Smurfit Paribas Bank Limited
    Transactions
    • 25 mars 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 sept. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Composite debenture
    Créé le 04 mars 1999
    Livré le 25 mars 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland,as Security Trustee for the Secured Parties(As Defined)
    Transactions
    • 25 mars 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 sept. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Composite debenture
    Créé le 26 mars 1998
    Livré le 16 avr. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    In favour of the governor and company of the bank of ireland as security trustee for the banks ("the secured parties") all monies due or to become due from the company to the secured parties or any of them whether collectively or individually by the company either alone or jointly with any person or company on any account under the terms and conditions as defined in the composite debenture
    Brèves mentions
    A fixed charge over all the companys f/h and l/h lands hereditaments, premises, property and chattels both present and future including the property particulars of which are specified under the company's name in the second schedule hereto and all the company's interests in all buildings, fixtures (including, without limitation, trade fixtures) and the fixed plant and machinery from time to time thereon; all present and future plant machinery vehicles fixtures implements utensils and equipment, all goodwill and uncalled capital and all debts; floating charge over the book debts undertaking and all other property assets and rights whatsoever both present and future.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Irelandas Security Trustee for the Banks ("the Securedparties")
    Transactions
    • 16 avr. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 sept. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0