JOHN BROWN DIGITAL LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéJOHN BROWN DIGITAL LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02603954
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de JOHN BROWN DIGITAL LIMITED ?

    • Autres activités d'édition (58190) / Information et communication

    Où se situe JOHN BROWN DIGITAL LIMITED ?

    Adresse du siège social
    10 Triton Street
    Regent's Place
    NW1 3BF London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de JOHN BROWN DIGITAL LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    JOHN BROWN COMMUNICATIONS LIMITED04 nov. 200804 nov. 2008
    FINGAL LIMITED12 août 200512 août 2005
    MPA FINGAL LIMITED03 déc. 199103 déc. 1991
    LAW 377 LIMITED23 avr. 199123 avr. 1991

    Quels sont les derniers comptes de JOHN BROWN DIGITAL LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2019

    Quels sont les derniers dépôts pour JOHN BROWN DIGITAL LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    État du capital après une attribution d'actions au 21 mai 2021

    • Capital: GBP 443,868.848
    3 pagesSH01

    Satisfaction de la charge 026039540007 en totalité

    4 pagesMR04

    Déclaration de confirmation établie le 31 oct. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2019

    19 pagesAA

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01

    Statuts

    35 pagesMA

    Nomination de Mr Dennis Romijn en tant qu'administrateur le 22 juil. 2020

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr James Scott Morris en tant qu'administrateur le 22 juil. 2020

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Nicholas Paul Waters en tant que directeur le 22 juil. 2020

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Andrew Mark Hirsch en tant que directeur le 22 juil. 2020

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Andrew John Moberly en tant que secrétaire le 29 févr. 2020

    1 pagesTM02

    Déclaration de confirmation établie le 31 oct. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2018

    18 pagesAA

    Nomination de Mr Nicholas Paul Waters en tant qu'administrateur le 26 juin 2019

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de James Alexander Robert Connelly en tant que directeur le 04 mars 2019

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 31 oct. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2017

    19 pagesAA

    Nomination de Mr James Alexander Robert Connelly en tant qu'administrateur le 06 juil. 2018

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Mark Gordon Creighton en tant que directeur le 10 juil. 2018

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Mary Margaret Basterfield en tant que directeur le 09 févr. 2018

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Mark Gordon Creighton en tant qu'administrateur le 04 déc. 2017

    2 pagesAP01

    Déclaration de confirmation établie le 31 oct. 2017 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Qui sont les dirigeants de JOHN BROWN DIGITAL LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MORRIS, James Scott
    Triton Street
    Regent's Place
    NW1 3BF London
    10
    Administrateur
    Triton Street
    Regent's Place
    NW1 3BF London
    10
    EnglandBritish212771730001
    ROMIJN, Dennis
    Triton Street
    Regent's Place
    NW1 3BF London
    10
    Administrateur
    Triton Street
    Regent's Place
    NW1 3BF London
    10
    NetherlandsDutch272475570001
    CAMPKIN, Christopher John
    86 Elthorne Park Road
    W7 2JD London
    Secrétaire
    86 Elthorne Park Road
    W7 2JD London
    British78308230002
    CARTER, Matthew Robert
    30 Carminia Road
    Tooting
    SW17 8AH London
    Secrétaire
    30 Carminia Road
    Tooting
    SW17 8AH London
    British20035200001
    FITZPATRICK, Dean Marvin
    26 Cranbourne Road
    N10 2BT London
    Secrétaire
    26 Cranbourne Road
    N10 2BT London
    British81553650001
    MOBERLY, Andrew John
    Triton Street
    Regent's Place
    NW1 3BF London
    10
    Secrétaire
    Triton Street
    Regent's Place
    NW1 3BF London
    10
    205299850001
    SILCOX, Alex David
    136-142 Bramley Road
    London
    W10 6SR
    Secrétaire
    136-142 Bramley Road
    London
    W10 6SR
    175851560001
    CLP COMPANY SECRETARIAL LIMITED
    Fifth Floor
    99 Charterhouse Street
    EC1M 6NQ London
    Secrétaire
    Fifth Floor
    99 Charterhouse Street
    EC1M 6NQ London
    75589480001
    HUNTSMOOR NOMINEES LIMITED
    Carmelite
    50 Victoria Embankment
    EC4Y 0DX Blackfriars
    London
    Secrétaire
    Carmelite
    50 Victoria Embankment
    EC4Y 0DX Blackfriars
    London
    41864110001
    HUNTSMOOR NOMINEES LIMITED
    Carmelite
    50 Victoria Embankment Blackfriars
    EC4Y 0DX London
    Secrétaire désigné
    Carmelite
    50 Victoria Embankment Blackfriars
    EC4Y 0DX London
    900008160001
    SECRETARIAL SOLUTIONS LIMITED
    5 Old Bailey
    EC4M 7JX London
    Secrétaire
    5 Old Bailey
    EC4M 7JX London
    81435090006
    BASTERFIELD, Mary Margaret
    Triton Street
    Regent's Place
    NW1 3BF London
    10
    Administrateur
    Triton Street
    Regent's Place
    NW1 3BF London
    10
    United KingdomBritish295094520001
    BROWN, John Dominic Weare
    120 Elgin Crescent
    W11 2JL London
    Administrateur
    120 Elgin Crescent
    W11 2JL London
    United KingdomBritish35549390002
    CAMPKIN, Christopher John
    86 Elthorne Park Road
    W7 2JD London
    Administrateur
    86 Elthorne Park Road
    W7 2JD London
    Great BritainBritish78308230002
    CARTER, Matthew Robert
    30 Carminia Road
    Tooting
    SW17 8AH London
    Administrateur
    30 Carminia Road
    Tooting
    SW17 8AH London
    United KingdomBritish20035200001
    CLARK, Gavin Nicholas
    6 Gilstead Road
    SW6 2LG London
    Administrateur
    6 Gilstead Road
    SW6 2LG London
    British102237050001
    CLARKSON, Jeremy Charles Robert
    31 Forth Bridge Road
    Wandsworth
    SW11 London
    Administrateur
    31 Forth Bridge Road
    Wandsworth
    SW11 London
    British30274050002
    CONNELLY, James Alexander Robert
    Triton Street
    Regent's Place
    NW1 3BF London
    10
    Administrateur
    Triton Street
    Regent's Place
    NW1 3BF London
    10
    EnglandBritish202477130001
    CREIGHTON, Mark Gordon
    Triton Street
    Regent's Place
    NW1 3BF London
    10
    Administrateur
    Triton Street
    Regent's Place
    NW1 3BF London
    10
    United KingdomBritish257075000001
    DE GROOSE, Tracy Anne
    Triton Street
    Regent's Place
    NW1 3BF London
    10
    England
    Administrateur
    Triton Street
    Regent's Place
    NW1 3BF London
    10
    England
    EnglandBritish171412510001
    FITZPATRICK, Dean Marvin
    26 Cranbourne Road
    N10 2BT London
    Administrateur
    26 Cranbourne Road
    N10 2BT London
    EnglandBritish81553650001
    GILL, Jonathan Arthur Compton
    3 Bowerdean Street
    Fulham
    SW6 3TN London
    Administrateur
    3 Bowerdean Street
    Fulham
    SW6 3TN London
    EnglandBritish35120590002
    HIRSCH, Andrew Mark
    64 Parliament Hill
    NW3 2TL London
    Administrateur
    64 Parliament Hill
    NW3 2TL London
    EnglandBritish107066560001
    JAGO, Francis Hilary
    58 Thurleigh Road
    SW12 8UD London
    Administrateur
    58 Thurleigh Road
    SW12 8UD London
    British62496130002
    JAGO, Francis Hilary
    31 Osward Road
    SW17 7SS London
    Administrateur
    31 Osward Road
    SW17 7SS London
    British62496130001
    KAY, Elizabeth
    Triton Street
    Regent's Place
    NW1 3BF London
    10
    England
    Administrateur
    Triton Street
    Regent's Place
    NW1 3BF London
    10
    England
    EnglandBritish176507210001
    PRICE, Claire Margaret
    Triton Street
    Regent's Place
    NW1 3BF London
    10
    England
    Administrateur
    Triton Street
    Regent's Place
    NW1 3BF London
    10
    England
    EnglandBritish181956820001
    SILCOX, Alexander David
    136-142 Bramley Road
    London
    W10 6SR
    Administrateur
    136-142 Bramley Road
    London
    W10 6SR
    EnglandBritish186834220001
    SOHI, Kashmir Singh
    Bramley Road
    W10 6SR London
    136-142
    England
    Administrateur
    Bramley Road
    W10 6SR London
    136-142
    England
    EnglandBritish45116130003
    STEVENS, Geoffrey Robert
    Beech House
    3 Millhouses Court
    S11 9HZ Sheffield
    South Yorkshire
    Administrateur
    Beech House
    3 Millhouses Court
    S11 9HZ Sheffield
    South Yorkshire
    United KingdomBritish57380020001
    TEE, Deborah Jane
    High Barn
    High Barn Road
    KT24 5PR Effingham
    Surrey
    Administrateur
    High Barn
    High Barn Road
    KT24 5PR Effingham
    Surrey
    United KingdomBritish80612160001
    WATERS, Nick Paul
    Triton Street
    Regent's Place
    NW1 3BF London
    10
    Administrateur
    Triton Street
    Regent's Place
    NW1 3BF London
    10
    EnglandBritish279380860001
    HUNTSMOOR NOMINEES LIMITED
    Carmelite
    50 Victoria Embankment Blackfriars
    EC4Y 0DX London
    Administrateur désigné
    Carmelite
    50 Victoria Embankment Blackfriars
    EC4Y 0DX London
    900008160001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur JOHN BROWN DIGITAL LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    John Brown Magazines Limited
    Triton Street
    Regent's Place
    NW1 3BF London
    10
    England
    06 avr. 2016
    Triton Street
    Regent's Place
    NW1 3BF London
    10
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Company Limited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementEngland & Wales
    Numéro d'enregistrement2680403
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    JOHN BROWN DIGITAL LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 14 mai 2015
    Livré le 19 mai 2015
    Totalement satisfaite
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 19 mai 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 13 mai 2021Satisfaction d'une charge (MR04)
    Deed of accession to guarantee and debenture
    Créé le 27 avr. 2007
    Livré le 16 mai 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any group company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 16 mai 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 juin 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 18 nov. 2004
    Livré le 20 nov. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 20 nov. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 avr. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Rent deposit deed
    Créé le 25 janv. 2002
    Livré le 05 févr. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £68,297.00 due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    Monies held pursuant to the rent deposit deed.
    Personnes ayant droit
    • Audiocall Limited
    Transactions
    • 05 févr. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 avr. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 15 avr. 1996
    Livré le 04 mai 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Coutts & Co.
    Transactions
    • 04 mai 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 mai 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 18 déc. 1991
    Livré le 24 déc. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    See doc M167C for details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 24 déc. 1991Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 août 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 17 déc. 1991
    Livré le 02 janv. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Heathmans house,19 heathmans road,london.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 02 janv. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 mars 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0