JOHN BROWN DIGITAL LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | JOHN BROWN DIGITAL LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 02603954 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe JOHN BROWN DIGITAL LIMITED ?
| Adresse du siège social | 10 Triton Street Regent's Place NW1 3BF London |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de JOHN BROWN DIGITAL LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2019 |
Quels sont les derniers dépôts pour JOHN BROWN DIGITAL LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
État du capital après une attribution d'actions au 21 mai 2021
| 3 pages | SH01 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 026039540007 en totalité | 4 pages | MR04 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 31 oct. 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2019 | 19 pages | AA | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Statuts | 35 pages | MA | ||||||||||
Nomination de Mr Dennis Romijn en tant qu'administrateur le 22 juil. 2020 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mr James Scott Morris en tant qu'administrateur le 22 juil. 2020 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Nicholas Paul Waters en tant que directeur le 22 juil. 2020 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Andrew Mark Hirsch en tant que directeur le 22 juil. 2020 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Andrew John Moberly en tant que secrétaire le 29 févr. 2020 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 31 oct. 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2018 | 18 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Mr Nicholas Paul Waters en tant qu'administrateur le 26 juin 2019 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de James Alexander Robert Connelly en tant que directeur le 04 mars 2019 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 31 oct. 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2017 | 19 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Mr James Alexander Robert Connelly en tant qu'administrateur le 06 juil. 2018 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Mark Gordon Creighton en tant que directeur le 10 juil. 2018 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Mary Margaret Basterfield en tant que directeur le 09 févr. 2018 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Mark Gordon Creighton en tant qu'administrateur le 04 déc. 2017 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 31 oct. 2017 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de JOHN BROWN DIGITAL LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MORRIS, James Scott | Administrateur | Triton Street Regent's Place NW1 3BF London 10 | England | British | 212771730001 | |||||
| ROMIJN, Dennis | Administrateur | Triton Street Regent's Place NW1 3BF London 10 | Netherlands | Dutch | 272475570001 | |||||
| CAMPKIN, Christopher John | Secrétaire | 86 Elthorne Park Road W7 2JD London | British | 78308230002 | ||||||
| CARTER, Matthew Robert | Secrétaire | 30 Carminia Road Tooting SW17 8AH London | British | 20035200001 | ||||||
| FITZPATRICK, Dean Marvin | Secrétaire | 26 Cranbourne Road N10 2BT London | British | 81553650001 | ||||||
| MOBERLY, Andrew John | Secrétaire | Triton Street Regent's Place NW1 3BF London 10 | 205299850001 | |||||||
| SILCOX, Alex David | Secrétaire | 136-142 Bramley Road London W10 6SR | 175851560001 | |||||||
| CLP COMPANY SECRETARIAL LIMITED | Secrétaire | Fifth Floor 99 Charterhouse Street EC1M 6NQ London | 75589480001 | |||||||
| HUNTSMOOR NOMINEES LIMITED | Secrétaire | Carmelite 50 Victoria Embankment EC4Y 0DX Blackfriars London | 41864110001 | |||||||
| HUNTSMOOR NOMINEES LIMITED | Secrétaire désigné | Carmelite 50 Victoria Embankment Blackfriars EC4Y 0DX London | 900008160001 | |||||||
| SECRETARIAL SOLUTIONS LIMITED | Secrétaire | 5 Old Bailey EC4M 7JX London | 81435090006 | |||||||
| BASTERFIELD, Mary Margaret | Administrateur | Triton Street Regent's Place NW1 3BF London 10 | United Kingdom | British | 295094520001 | |||||
| BROWN, John Dominic Weare | Administrateur | 120 Elgin Crescent W11 2JL London | United Kingdom | British | 35549390002 | |||||
| CAMPKIN, Christopher John | Administrateur | 86 Elthorne Park Road W7 2JD London | Great Britain | British | 78308230002 | |||||
| CARTER, Matthew Robert | Administrateur | 30 Carminia Road Tooting SW17 8AH London | United Kingdom | British | 20035200001 | |||||
| CLARK, Gavin Nicholas | Administrateur | 6 Gilstead Road SW6 2LG London | British | 102237050001 | ||||||
| CLARKSON, Jeremy Charles Robert | Administrateur | 31 Forth Bridge Road Wandsworth SW11 London | British | 30274050002 | ||||||
| CONNELLY, James Alexander Robert | Administrateur | Triton Street Regent's Place NW1 3BF London 10 | England | British | 202477130001 | |||||
| CREIGHTON, Mark Gordon | Administrateur | Triton Street Regent's Place NW1 3BF London 10 | United Kingdom | British | 257075000001 | |||||
| DE GROOSE, Tracy Anne | Administrateur | Triton Street Regent's Place NW1 3BF London 10 England | England | British | 171412510001 | |||||
| FITZPATRICK, Dean Marvin | Administrateur | 26 Cranbourne Road N10 2BT London | England | British | 81553650001 | |||||
| GILL, Jonathan Arthur Compton | Administrateur | 3 Bowerdean Street Fulham SW6 3TN London | England | British | 35120590002 | |||||
| HIRSCH, Andrew Mark | Administrateur | 64 Parliament Hill NW3 2TL London | England | British | 107066560001 | |||||
| JAGO, Francis Hilary | Administrateur | 58 Thurleigh Road SW12 8UD London | British | 62496130002 | ||||||
| JAGO, Francis Hilary | Administrateur | 31 Osward Road SW17 7SS London | British | 62496130001 | ||||||
| KAY, Elizabeth | Administrateur | Triton Street Regent's Place NW1 3BF London 10 England | England | British | 176507210001 | |||||
| PRICE, Claire Margaret | Administrateur | Triton Street Regent's Place NW1 3BF London 10 England | England | British | 181956820001 | |||||
| SILCOX, Alexander David | Administrateur | 136-142 Bramley Road London W10 6SR | England | British | 186834220001 | |||||
| SOHI, Kashmir Singh | Administrateur | Bramley Road W10 6SR London 136-142 England | England | British | 45116130003 | |||||
| STEVENS, Geoffrey Robert | Administrateur | Beech House 3 Millhouses Court S11 9HZ Sheffield South Yorkshire | United Kingdom | British | 57380020001 | |||||
| TEE, Deborah Jane | Administrateur | High Barn High Barn Road KT24 5PR Effingham Surrey | United Kingdom | British | 80612160001 | |||||
| WATERS, Nick Paul | Administrateur | Triton Street Regent's Place NW1 3BF London 10 | England | British | 279380860001 | |||||
| HUNTSMOOR NOMINEES LIMITED | Administrateur désigné | Carmelite 50 Victoria Embankment Blackfriars EC4Y 0DX London | 900008160001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur JOHN BROWN DIGITAL LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Brown Magazines Limited | 06 avr. 2016 | Triton Street Regent's Place NW1 3BF London 10 England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
JOHN BROWN DIGITAL LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Créé le 14 mai 2015 Livré le 19 mai 2015 | Totalement satisfaite | ||
La charge flottante couvre tout: Oui Contient une promesse négative: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Deed of accession to guarantee and debenture | Créé le 27 avr. 2007 Livré le 16 mai 2007 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from any group company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 18 nov. 2004 Livré le 20 nov. 2004 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Rent deposit deed | Créé le 25 janv. 2002 Livré le 05 févr. 2002 | Totalement satisfaite | Montant garanti £68,297.00 due from the company to the chargee | |
Brèves mentions Monies held pursuant to the rent deposit deed. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Mortgage debenture | Créé le 15 avr. 1996 Livré le 04 mai 1996 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 18 déc. 1991 Livré le 24 déc. 1991 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions See doc M167C for details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 17 déc. 1991 Livré le 02 janv. 1992 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Br èves mentions Heathmans house,19 heathmans road,london. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0