NEXVALE LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéNEXVALE LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02604384
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de NEXVALE LIMITED ?

    • Autres activités liées à la santé humaine (86900) / Activités de santé humaine et d'action sociale

    Où se situe NEXVALE LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Connaught House 850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Essex
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de NEXVALE LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2011

    Quels sont les derniers dépôts pour NEXVALE LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2011

    17 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 mars 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital19 avr. 2012

    État du capital au 19 avr. 2012

    • Capital: GBP 115,600
    SH01

    Nomination de Jonathan David Calow en tant que secrétaire le 08 déc. 2011

    1 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Care Uk Services Limited en tant que secrétaire le 08 déc. 2011

    1 pagesTM02

    Deuxième dépôt de AP01 précédemment soumis à Companies House

    9 pagesRP04
    Annotations
    DateAnnotation
    27 oct. 2011Clarification A second filed AP01 for Dr Alison Rose-Quirie was registered on 27/10/2011.

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 mars 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Résolutions

    Resolutions
    9 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01

    Nomination de Care Uk Services Limited en tant que secrétaire

    2 pagesAP04

    Nomination de Dr Alison Jane Rose-Quirie en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01
    Annotations
    DateAnnotation
    27 oct. 2011Clarification A second filed AP01 for Dr Alison Rose-Quirie was registered on 27/10/2011.

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    Changement d'adresse du siège social de 2 a C Court High Street Thames Ditton Surrey KT7 0SR le 08 févr. 2011

    1 pagesAD01

    Nomination de Michael Robert Parish en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Nomination de Paul Justin Humphreys en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Joan Dawson en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Eberhard Vonwick en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Nomination de Christopher Robert Brown en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Période comptable actuelle prolongée du 30 avr. 2011 au 30 sept. 2011

    1 pagesAA01

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 avr. 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 avr. 2010

    6 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 mars 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 avr. 2009

    6 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de NEXVALE LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    CALOW, Jonathan David
    850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    United Kingdom
    Secrétaire
    850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    United Kingdom
    165501240001
    BROWN, Christopher Robert
    850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    United Kingdom
    Administrateur
    850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    United Kingdom
    EnglandBritish138821850001
    HUMPHREYS, Paul Justin
    850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    United Kingdom
    Administrateur
    850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    United Kingdom
    United KingdomBritish33223550003
    PARISH, Michael Robert
    850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    United Kingdom
    Administrateur
    850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    United Kingdom
    EnglandBritish78828750003
    ROSE-QUIRIE, Alison Jane, Dr
    850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    United Kingdom
    Administrateur
    850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    United Kingdom
    EnglandBritish190407640001
    HARRISON, Elizabeth
    18 Cranford Road
    DA1 1JP Dartford
    Kent
    Secrétaire
    18 Cranford Road
    DA1 1JP Dartford
    Kent
    British27588290001
    VONWICK, Eberhard
    Totteridge Green
    N20 8PA London
    The Old House
    Secrétaire
    Totteridge Green
    N20 8PA London
    The Old House
    Other134818370001
    CARE UK SERVICES LIMITED
    850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    United Kingdom
    Secrétaire
    850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement02482660
    157793350001
    SEMKEN LIMITED
    The Studio
    St Nicholas Close
    WD6 3EW Elstree Borehamwood
    Hertfordshire
    Secrétaire désigné
    The Studio
    St Nicholas Close
    WD6 3EW Elstree Borehamwood
    Hertfordshire
    900005970001
    DAWSON, Joan Denise
    Rhodes Farm The Ridgeway
    Mill Hill
    NW7 1RH London
    Administrateur
    Rhodes Farm The Ridgeway
    Mill Hill
    NW7 1RH London
    British29462760001
    LUFMER LIMITED
    The Studio
    St Nicholas Close
    WD6 3EW Elstree Borehamwood
    Hertfordshire
    Administrateur désigné
    The Studio
    St Nicholas Close
    WD6 3EW Elstree Borehamwood
    Hertfordshire
    900005960001

    NEXVALE LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 21 juil. 2005
    Livré le 22 juil. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 22 juil. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 févr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 21 juil. 2005
    Livré le 22 juil. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    Property k/a rhodes farm and the land at the back, the ridgeway, mill hill, london t/n ngl 320196 and ngl 709975. fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 22 juil. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 févr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 08 juil. 1991
    Livré le 19 juil. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    (See 395 for details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 19 juil. 1991Enregistrement d'une charge
    • 07 juil. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0