NEXVALE LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | NEXVALE LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 02604384 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe NEXVALE LIMITED ?
| Adresse du siège social | Connaught House 850 The Crescent Colchester Business Park CO4 9QB Colchester Essex United Kingdom |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de NEXVALE LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 30 sept. 2011 |
Quels sont les derniers dépôts pour NEXVALE LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 30 sept. 2011 | 17 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 31 mars 2012 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomination de Jonathan David Calow en tant que secrétaire le 08 déc. 2011 | 1 pages | AP03 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Care Uk Services Limited en tant que secrétaire le 08 déc. 2011 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Deuxième dépôt de AP01 précédemment soumis à Companies House | 9 pages | RP04 | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 31 mars 2011 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 9 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomination de Care Uk Services Limited en tant que secrétaire | 2 pages | AP04 | ||||||||||
Nomination de Dr Alison Jane Rose-Quirie en tant qu'administrateur | 3 pages | AP01 | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 3 pages | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 pages | MG02 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 2 a C Court High Street Thames Ditton Surrey KT7 0SR le 08 févr. 2011 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Nomination de Michael Robert Parish en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Paul Justin Humphreys en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Joan Dawson en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Eberhard Vonwick en tant que secrétaire | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Nomination de Christopher Robert Brown en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Période comptable actuelle prolongée du 30 avr. 2011 au 30 sept. 2011 | 1 pages | AA01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 01 avr. 2010 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 avr. 2010 | 6 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 31 mars 2010 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 avr. 2009 | 6 pages | AA | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de NEXVALE LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALOW, Jonathan David | Secrétaire | 850 The Crescent Colchester Business Park CO4 9QB Colchester Connaught House Essex United Kingdom | 165501240001 | |||||||||||
| BROWN, Christopher Robert | Administrateur | 850 The Crescent Colchester Business Park CO4 9QB Colchester Connaught House Essex United Kingdom | England | British | 138821850001 | |||||||||
| HUMPHREYS, Paul Justin | Administrateur | 850 The Crescent Colchester Business Park CO4 9QB Colchester Connaught House Essex United Kingdom | United Kingdom | British | 33223550003 | |||||||||
| PARISH, Michael Robert | Administrateur | 850 The Crescent Colchester Business Park CO4 9QB Colchester Connaught House Essex United Kingdom | England | British | 78828750003 | |||||||||
| ROSE-QUIRIE, Alison Jane, Dr | Administrateur | 850 The Crescent Colchester Business Park CO4 9QB Colchester Connaught House Essex United Kingdom | England | British | 190407640001 | |||||||||
| HARRISON, Elizabeth | Secrétaire | 18 Cranford Road DA1 1JP Dartford Kent | British | 27588290001 | ||||||||||
| VONWICK, Eberhard | Secrétaire | Totteridge Green N20 8PA London The Old House | Other | 134818370001 | ||||||||||
| CARE UK SERVICES LIMITED | Secrétaire | 850 The Crescent Colchester Business Park CO4 9QB Colchester Connaught House Essex United Kingdom |
| 157793350001 | ||||||||||
| SEMKEN LIMITED | Secrétaire désigné | The Studio St Nicholas Close WD6 3EW Elstree Borehamwood Hertfordshire | 900005970001 | |||||||||||
| DAWSON, Joan Denise | Administrateur | Rhodes Farm The Ridgeway Mill Hill NW7 1RH London | British | 29462760001 | ||||||||||
| LUFMER LIMITED | Administrateur désigné | The Studio St Nicholas Close WD6 3EW Elstree Borehamwood Hertfordshire | 900005960001 |
NEXVALE LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Créé le 21 juil. 2005 Livré le 22 juil. 2005 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 21 juil. 2005 Livré le 22 juil. 2005 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Brèves mentions Property k/a rhodes farm and the land at the back, the ridgeway, mill hill, london t/n ngl 320196 and ngl 709975. fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 08 juil. 1991 Livré le 19 juil. 1991 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions (See 395 for details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0