MEDLOCK PROPERTY COMPANY LIMITED

MEDLOCK PROPERTY COMPANY LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéMEDLOCK PROPERTY COMPANY LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02608552
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de MEDLOCK PROPERTY COMPANY LIMITED ?

    • (7011) /

    Où se situe MEDLOCK PROPERTY COMPANY LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Boardman Conway
    23a High Street
    CW8 3HA Weaverham Northwich
    Cheshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de MEDLOCK PROPERTY COMPANY LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2009

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour MEDLOCK PROPERTY COMPANY LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour MEDLOCK PROPERTY COMPANY LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Achèvement de la liquidation

    1 pagesL64.07

    Ordonnance du tribunal pour liquider

    1 pagesCOCOMP

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 sept. 2009

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 07 mai 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital07 mai 2010

    État du capital au 07 mai 2010

    • Capital: GBP 4
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Michael John Barltrop le 07 mai 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Jacqueline Therese Barltrop le 07 mai 2010

    2 pagesCH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 sept. 2008

    5 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    legacy

    4 pages363a

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 sept. 2007

    5 pagesAA

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 sept. 2006

    5 pagesAA

    legacy

    1 pages287

    legacy

    7 pages363s

    legacy

    2 pages403a

    legacy

    2 pages403a

    legacy

    2 pages403a

    legacy

    7 pages363s

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 sept. 2005

    5 pagesAA

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages225

    legacy

    7 pages363s

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    1 pages287

    Qui sont les dirigeants de MEDLOCK PROPERTY COMPANY LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BARLTROP, Jacqueline Therese
    Chimneys
    Weston Road
    SK9 2AN Wilmslow
    Cheshire
    Secrétaire
    Chimneys
    Weston Road
    SK9 2AN Wilmslow
    Cheshire
    BritishNursing Sister98710340002
    BARLTROP, Jacqueline Therese
    Chimneys
    Weston Road
    SK9 2AN Wilmslow
    Cheshire
    Administrateur
    Chimneys
    Weston Road
    SK9 2AN Wilmslow
    Cheshire
    EnglandBritishNursing Sister98710340002
    BARLTROP, Michael John
    Chimneys
    Weston Road
    SK9 2AN Wilmslow
    Cheshire
    Administrateur
    Chimneys
    Weston Road
    SK9 2AN Wilmslow
    Cheshire
    United KingdomBritishBuilder49219720002
    SHOESMITH, Roger Frederick
    Wood End Bramhall Park Road
    Bramhall
    SK7 4NA Stockport
    Cheshire
    Secrétaire
    Wood End Bramhall Park Road
    Bramhall
    SK7 4NA Stockport
    Cheshire
    BritishArchitect27553270001
    LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Secrétaire désigné
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001510001
    COHEN, Charles Peter Anthony
    76 Singleton Road
    Salford
    M7 4LU Manchester
    Lancashire
    Administrateur
    76 Singleton Road
    Salford
    M7 4LU Manchester
    Lancashire
    United KingdomBritishDirector60319920001
    LEE, Eric Bernard
    6 Cannock Drive
    Heaton Mersey
    SK4 3JB Stockport
    Cheshire
    Administrateur
    6 Cannock Drive
    Heaton Mersey
    SK4 3JB Stockport
    Cheshire
    BritishProperty Consultant13754860002
    SHOESMITH, Roger Frederick
    Wood End Bramhall Park Road
    Bramhall
    SK7 4NA Stockport
    Cheshire
    Administrateur
    Wood End Bramhall Park Road
    Bramhall
    SK7 4NA Stockport
    Cheshire
    EnglandBritishArchitect27553270001
    LONDON LAW SERVICES LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Administrateur désigné
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001500001

    MEDLOCK PROPERTY COMPANY LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal mortgage
    Créé le 12 mai 2005
    Livré le 18 mai 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from croft prestige homes limited and the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    55 and 57 ardwick green north ardwick manchester t/n's LA130034 and GM513233. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 18 mai 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 janv. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 12 mai 2005
    Livré le 17 mai 2005
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 17 mai 2005Enregistrement d'une charge (395)
    Legal mortgage
    Créé le 12 mai 2005
    Livré le 17 mai 2005
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and croft prestige homes limited
    Brèves mentions
    Bank vale road hayfield high peak derbyshire t/n DY339049. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 17 mai 2005Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 24 août 2001
    Livré le 11 sept. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 11 sept. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 janv. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 24 août 2001
    Livré le 11 sept. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    By way of legal mortgage land at bank vale road hayfield high peak derbyshire t/n DY199405 and dy 217644. by way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 11 sept. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 janv. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 16 août 1991
    Livré le 16 août 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    4 fairfield street, manchester title nos. Gm 161165 and gm 161166.
    Personnes ayant droit
    • Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 16 août 1991Enregistrement d'une charge
    • 30 juil. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 16 août 1991
    Livré le 16 août 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 16 août 1991Enregistrement d'une charge
    • 30 juil. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    MEDLOCK PROPERTY COMPANY LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    10 juin 2010Petition date
    31 mars 2015Conclusion of winding up
    28 juil. 2010Commencement of winding up
    28 juil. 2015Dissolved on
    Compulsory liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    The Official Receiver Or London
    21 Bloomsbury Street
    London
    WC1B 3SS
    practitioner
    21 Bloomsbury Street
    London
    WC1B 3SS

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0