THE HORNBEAM CENTRE C.I.C.
Vue d'ensemble
| Nom de la société | THE HORNBEAM CENTRE C.I.C. |
|---|---|
| Statut de la société | Active |
| Forme juridique | Société privée à responsabilité limitée par garantie sans capital social |
| Numéro de société | 02608803 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe THE HORNBEAM CENTRE C.I.C. ?
| Adresse du siège social | 458 Hoe Street London E17 9AH |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de THE HORNBEAM CENTRE C.I.C. ?
| En retard | Non |
|---|---|
| Prochains comptes | |
| Fin de la prochaine période comptable le | 31 mars 2026 |
| Date d'échéance des prochains comptes | 31 déc. 2026 |
| Derniers comptes | |
| Derniers comptes arrêtés au | 31 mars 2025 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour THE HORNBEAM CENTRE C.I.C. ?
| Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 08 mai 2026 |
|---|---|
| Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 22 mai 2026 |
| Dernière déclaration de confirmation | |
| Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 08 mai 2025 |
| En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour THE HORNBEAM CENTRE C.I.C. ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2025 | 4 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 08 mai 2025 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2024 | 11 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 08 mai 2024 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2023 | 8 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 08 mai 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2022 | 4 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de Stephen William Lambert en tant que secrétaire le 01 sept. 2022 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 08 mai 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2021 | 4 pages | AA | ||||||||||
Certificat de changement de nom Company name changed the hornbeam centre\certificate issued on 31/12/21 | 3 pages | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
Changement de nom" | pages | CICCON | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 24 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
La procédure de radiation d'office a été abandonnée | 1 pages | DISS40 | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office | 1 pages | GAZ1 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 08 mai 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2020 | 4 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 08 mai 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2019 | 4 pages | AA | ||||||||||
Statuts | 14 pages | MA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 08 mai 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2018 | 4 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 08 mai 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Nomination de Mr Diye Wariebi en tant qu'administrateur le 04 déc. 2017 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2017 | 4 pages | AA | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de THE HORNBEAM CENTRE C.I.C. ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARRETT, Marlene Stephanie Rachel | Administrateur | 458 Hoe Street London E17 9AH | England | British | 122165740001 | |||||
| KELLY, Brian | Administrateur | 458 Hoe Street London E17 9AH | United Kingdom | British | 96922540001 | |||||
| RUXTON, Tom | Administrateur | 458 Hoe Street London E17 9AH | England | British | 147446260001 | |||||
| WARIEBI, Diye | Administrateur | Seven Sisters Road N7 7PX London 176 England | United Kingdom | British | 102319190001 | |||||
| CRUTE JONES, Carmela Pauline Amirah | Secrétaire | 9 Forest Drive East Leytonstone E11 1JX London | British | 117273420001 | ||||||
| LAMBERT, Stephen William | Secrétaire | 458 Hoe Street London E17 9AH | 153268490001 | |||||||
| LEWIS, Jowanna Elizabeth | Secrétaire | 106 Devonshire Road Walthamstow E17 8QJ London | British | 29941410001 | ||||||
| SAVAGE, Steven | Secrétaire | 13 Merton Road E17 9DE London | British | 76035120004 | ||||||
| WILLIAMS, Alex | Secrétaire | 17 Haverfield Road E3 5BH London | British | 87789540001 | ||||||
| WILLIAMS, Alexis Delilah | Secrétaire | 9 Michael Road E11 3DY London | British | 80036670002 | ||||||
| BRAGA, Bundy Ruth | Administrateur | 12 Lonsdale Road Wanstead E11 2PH London | British | 43701460001 | ||||||
| BROADBENT, Lesley Jean | Administrateur | 48 Empress Avenue Chingford E4 8SR London | British | 30400580001 | ||||||
| CRUTE JONES, Carmela Pauline Amirah | Administrateur | 9 Forest Drive East Leytonstone E11 1JX London | United Kingdom | British | 117273420001 | |||||
| CULLEN, David Paul | Administrateur | 12 Lawrence Road Plaistow E13 0QD London | British | 29941420001 | ||||||
| DOWNING, David | Administrateur | Flat 6 55 Highbury Park W5 London | British | 29941430001 | ||||||
| ELKIN, Jeremy David | Administrateur | 70 Mersy Road Walthamstow E17 London | British | 43836230002 | ||||||
| ELLIS, David Roger Peter | Administrateur | 106 Devonshire Road Walthamstow E17 8QJ London | British | 43702770001 | ||||||
| GASSON, Paul Jonathan | Administrateur | Eden Grove E17 9JU London 13 England | United Kingdom | British | 182451420001 | |||||
| GATEHOUSE, Jane Emma | Administrateur | 1 Tulip Gardens Wittenham Way Chingford E5 London | British | 29941440001 | ||||||
| HILL, Christopher Lyndon | Administrateur | 458 Hoe Street London E17 9AH | England | British | 76035000002 | |||||
| JOY, Clare Elizabeth | Administrateur | 458 Hoe Street London E17 9AH | England | British | 122167050001 | |||||
| LESTER, Gillian Mary | Administrateur | 131 Clacton Road Walthamstow E17 8AP London | British | 29941450001 | ||||||
| LEWIS, Jowanna Elizabeth | Administrateur | 106 Devonshire Road Walthamstow E17 8QJ London | British | 29941410001 | ||||||
| MCINTOSH, Elizabeth Thomfon | Administrateur | 12 Browns Road Walthamstow E17 4RW London | Scottish | 29941460001 | ||||||
| MOUNTNEY, Christian Daniel, Director | Administrateur | 36 Hawarden Road Walthamstow E17 6NS London | British | 30400570001 | ||||||
| O'MALLEY, Michelle Joanne | Administrateur | 29 Bakers Avenue Walthamstow E17 9AN London | British | 76034850001 | ||||||
| SAVAGE, Steven | Administrateur | 13 Merton Road E17 9DE London | British | 76035120004 | ||||||
| SIZER, Diane | Administrateur | 49 Woodville Road Walthamstow E17 7ER London | British | 29941470003 | ||||||
| STEVENS, Bryony Edith | Administrateur | 77 Maynard Road Walthamstow E17 9JE London | British | 52896860001 |
Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour THE HORNBEAM CENTRE C.I.C. ?
| Notifié le | Cessé le | Déclaration |
|---|---|---|
| 08 mai 2017 | La société sait ou a des raisons de croire qu'aucune personne enregistrable ou entité juridique pertinente enregistrable n'est liée à la société. |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0