BDL (DESIGN) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéBDL (DESIGN) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02608880
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de BDL (DESIGN) LIMITED ?

    • (7499) /

    Où se situe BDL (DESIGN) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    65 Battersea Church Road
    SW11 3LY London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de BDL (DESIGN) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    MAWLAW 111 LIMITED09 mai 199109 mai 1991

    Quels sont les derniers comptes de BDL (DESIGN) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 oct. 2010

    Quels sont les derniers dépôts pour BDL (DESIGN) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration annuelle jusqu'au 19 sept. 2011 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital20 sept. 2011

    État du capital au 20 sept. 2011

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Ben De Lisi le 19 sept. 2011

    2 pagesCH01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 oct. 2010

    10 pagesAA

    Période comptable précédente raccourcie du 30 avr. 2011 au 31 oct. 2010

    3 pagesAA01

    Déclaration annuelle jusqu'au 19 sept. 2010 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01

    État du capital au 20 oct. 2010

    • Capital: GBP 2
    4 pagesSH19

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de diminution du capital social autorisé

    RES05
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06
    incorporation

    Résolution de modification des statuts

    RES01

    Comptes d'exonération totale établis au 30 avr. 2010

    10 pagesAA

    Cessation de la nomination de Rachel Brickley en tant que secrétaire

    2 pagesTM02

    Comptes d'exonération totale établis au 30 avr. 2009

    9 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 19 sept. 2009 avec liste complète des actionnaires

    10 pagesAR01

    Changement d'adresse du siège social de 40 Elizabeth Street London SW1W 9NZ le 19 nov. 2009

    1 pagesAD01

    legacy

    2 pages403a

    legacy

    2 pages403a

    legacy

    4 pages395

    legacy

    6 pages363a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 avr. 2008

    4 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de BDL (DESIGN) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    DE LISI, Ben
    Battersea Church Road
    SW11 3LY London
    65
    Administrateur
    Battersea Church Road
    SW11 3LY London
    65
    United KingdomAmericanFashion Designer45405420002
    BRICKLEY, Rachel
    27 Battersea Church Road
    SW11 3LY London
    Secrétaire
    27 Battersea Church Road
    SW11 3LY London
    BritishRetail Manager111481460001
    DE LISI, Ben
    65 Battersea Church Rd
    SW11 London
    Secrétaire
    65 Battersea Church Rd
    SW11 London
    AmericanFashion Designer45405420002
    MYLVAGAHAM, Sagitharan
    9 Ashwell Avenue
    GU15 2AR Camberley
    Surrey
    Secrétaire
    9 Ashwell Avenue
    GU15 2AR Camberley
    Surrey
    British17075960001
    RICHARDSON, Dawn
    8 Ladas Roadhouse
    West Norwood
    London
    Secrétaire
    8 Ladas Roadhouse
    West Norwood
    London
    BritishProduction Manager36564860002
    WILLIAMS, Denise
    38 Lynton Road South
    DA11 7NF Gravesend
    Kent
    Secrétaire
    38 Lynton Road South
    DA11 7NF Gravesend
    Kent
    British24311940001
    MAWLAW SECRETARIES LIMITED
    Black Friars Lane
    EC4V 6HD London
    20
    Secrétaire
    Black Friars Lane
    EC4V 6HD London
    20
    39182980001
    DEVINE, John Patrick
    16 Flamstead End Road
    Cheshunt
    EN8 0HH Waltham Cross
    Hertfordshire
    Administrateur
    16 Flamstead End Road
    Cheshunt
    EN8 0HH Waltham Cross
    Hertfordshire
    BritishGroup Director17853280001
    HEALD, Malcolm Barclay
    Summerley House
    Ellwood Road
    HP9 1EN Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Summerley House
    Ellwood Road
    HP9 1EN Beaconsfield
    Buckinghamshire
    EnglandBritishChartered Accountant1605080001
    LOVEJOY, Deborah Ann
    40 Elizabeth Street
    SW1W 9NZ London
    Administrateur
    40 Elizabeth Street
    SW1W 9NZ London
    United KingdomBritishSales Director32515820002
    OLDALE, John Keith
    Little Coopers Coopers Hill
    Eversley
    RG27 0QA Basingstoke
    Hampshire
    Administrateur
    Little Coopers Coopers Hill
    Eversley
    RG27 0QA Basingstoke
    Hampshire
    BritishSolicitor2038950001
    RICHARDSON, Dawn
    8 Ladas Roadhouse
    West Norwood
    London
    Administrateur
    8 Ladas Roadhouse
    West Norwood
    London
    BritishProduction Manager36564860002
    SMETHURST, Geoffrey Brian
    7 Birchwood Avenue
    Southborough
    TN4 0UD Tunbridge Wells
    Kent
    Administrateur
    7 Birchwood Avenue
    Southborough
    TN4 0UD Tunbridge Wells
    Kent
    BritishChartered Secretary156520001
    TIEDMAN, David Arthur
    26 Hartland Road
    CM16 4PE Epping
    Essex
    Administrateur
    26 Hartland Road
    CM16 4PE Epping
    Essex
    BritishCommercial Director17080540001

    BDL (DESIGN) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Rent deposit deed
    Créé le 23 oct. 2008
    Livré le 30 oct. 2008
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The sum of £25,000.00 paid by the company to the landlord; and any other sums paid into the account by the tenant pursuant to the deed and any interest credited to that account see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Grosvenor Estate Belgravia
    Transactions
    • 30 oct. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 01 juil. 1998
    Livré le 04 juil. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    40 elizabeth street london. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 04 juil. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 févr. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed and floating charge
    Créé le 07 mars 1996
    Livré le 09 mars 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Kellock Limited
    Transactions
    • 09 mars 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 mai 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 03 nov. 1994
    Livré le 15 nov. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 15 nov. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 févr. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 24 juin 1994
    Livré le 30 juin 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 30 juin 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 janv. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 19 août 1992
    Livré le 24 août 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Hongkong & Shanghai Banking Corporation Limited
    Transactions
    • 24 août 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 janv. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 19 août 1992
    Livré le 27 août 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    (For full details refer to doc M395). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 27 août 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 janv. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0