THE JEWISH ASSOCIATION FOR MENTAL ILLNESS

THE JEWISH ASSOCIATION FOR MENTAL ILLNESS

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéTHE JEWISH ASSOCIATION FOR MENTAL ILLNESS
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété privée à responsabilité limitée par garantie sans capital social, exemption d'utilisation de 'Limited'
    Numéro de société 02618170
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesNon
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de THE JEWISH ASSOCIATION FOR MENTAL ILLNESS ?

    • Autres activités de travail social sans hébergement n.c.a. (88990) / Activités de santé humaine et d'action sociale

    Où se situe THE JEWISH ASSOCIATION FOR MENTAL ILLNESS ?

    Adresse du siège social
    Amelie House Maurice And Vivienne Wohl Campus
    221 Golders Green Road
    NW11 9DQ London
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de THE JEWISH ASSOCIATION FOR MENTAL ILLNESS ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    THE JEWISH ASSOCIATION FOR THE MENTALLY ILL07 juin 199107 juin 1991

    Quels sont les derniers comptes de THE JEWISH ASSOCIATION FOR MENTAL ILLNESS ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2024

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour THE JEWISH ASSOCIATION FOR MENTAL ILLNESS ?

    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au07 juin 2025

    Quels sont les derniers dépôts pour THE JEWISH ASSOCIATION FOR MENTAL ILLNESS ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    La procédure de radiation volontaire a été suspendue.

    1 pagesSOAS(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    2 pagesDS01

    Période comptable actuelle prolongée du 31 mars 2025 au 30 sept. 2025

    1 pagesAA01

    Déclaration de confirmation établie le 07 juin 2025 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 mars 2024

    52 pagesAA

    Nomination de Mr Jonathan Simon West en tant qu'administrateur le 18 mars 2024

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Jonathan David Zenios en tant que directeur le 26 sept. 2024

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 07 juin 2024 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Mr Jonathan Zenios en tant qu'administrateur le 18 mars 2024

    2 pagesAP01

    Changement d'adresse du siège social de Amelie House the Maurice and Vivienne Wohl Campus 221 Golders Green Road London NW11 6TG United Kingdom à Amelie House Maurice and Vivienne Wohl Campus 221 Golders Green Road London NW11 9DQ le 08 avr. 2024

    1 pagesAD01

    Changement d'adresse du siège social de Leila's House, 55 Christchurch Avenue Christchurch Avenue London N12 0DG England à Amelie House the Maurice and Vivienne Wohl Campus 221 Golders Green Road London NW11 6TG le 04 avr. 2024

    1 pagesAD01

    Nomination de Mr Jonathan West en tant que secrétaire le 18 mars 2024

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Abigail Joanna Swerdlow en tant que directeur le 18 mars 2024

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Warren Paul Taylor en tant que directeur le 18 mars 2024

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Susan Sara Mandelbaum en tant que directeur le 18 mars 2024

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Gemma Lyons en tant que directeur le 18 mars 2024

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Gideon Max Holme Kay en tant que directeur le 18 mars 2024

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Michael Stuart Glass en tant que directeur le 18 mars 2024

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Tessa Shelley Ingram Arnold en tant que directeur le 18 mars 2024

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Daniel Carmel Brown en tant qu'administrateur le 18 mars 2024

    2 pagesAP01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2023

    55 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 07 juin 2023 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Ms Gemma Lyons en tant qu'administrateur le 09 févr. 2023

    2 pagesAP01

    Qui sont les dirigeants de THE JEWISH ASSOCIATION FOR MENTAL ILLNESS ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    WEST, Jonathan
    221 Golders Green Road
    NW11 9DQ London
    Amelie House
    England
    Secrétaire
    221 Golders Green Road
    NW11 9DQ London
    Amelie House
    England
    321285410001
    CARMEL BROWN, Daniel
    Maurice And Vivienne Wohl Campus
    221 Golders Green Road
    NW11 9DQ London
    Amelie House
    United Kingdom
    Administrateur
    Maurice And Vivienne Wohl Campus
    221 Golders Green Road
    NW11 9DQ London
    Amelie House
    United Kingdom
    United KingdomBritish321281370001
    DAWSON, Adam David
    Maurice And Vivienne Wohl Campus
    221 Golders Green Road
    NW11 9DQ London
    Amelie House
    United Kingdom
    Administrateur
    Maurice And Vivienne Wohl Campus
    221 Golders Green Road
    NW11 9DQ London
    Amelie House
    United Kingdom
    EnglandBritish156415400001
    WEST, Jonathan Simon
    Maurice And Vivienne Wohl Campus
    221 Golders Green Road
    NW11 9DQ London
    Amelie House
    United Kingdom
    Administrateur
    Maurice And Vivienne Wohl Campus
    221 Golders Green Road
    NW11 9DQ London
    Amelie House
    United Kingdom
    United KingdomBritish169908920002
    LAZARUS, Alan Brian
    Flat 10 Randall Court
    Page Street Mill Hill
    NW7 2NJ London
    Secrétaire
    Flat 10 Randall Court
    Page Street Mill Hill
    NW7 2NJ London
    British21758750001
    CCS SECRETARIES LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Secrétaire désigné
    120 East Road
    N1 6AA London
    900001720001
    AARON, Jean
    24 Brookland Rise
    NW11 6DP London
    Administrateur
    24 Brookland Rise
    NW11 6DP London
    United KingdomBritish52911560003
    AARON, Jean
    1 Queenswood Park
    Finchley
    N3 1UN London
    Administrateur
    1 Queenswood Park
    Finchley
    N3 1UN London
    British52911560001
    AARON, Martin, Professor
    24 Brookland Rise
    NW11 6DP London
    Administrateur
    24 Brookland Rise
    NW11 6DP London
    United KingdomBritish7380060005
    ARNOLD, Tessa Shelley Ingram
    Christchurch Avenue
    N12 0DG London
    Leila's House, 55 Christchurch Avenue
    England
    Administrateur
    Christchurch Avenue
    N12 0DG London
    Leila's House, 55 Christchurch Avenue
    England
    United KingdomBritish263181090001
    BENSON, Richard Jonathan
    Christchurch Avenue
    N12 0DG London
    Leila's House, 55 Christchurch Avenue
    England
    Administrateur
    Christchurch Avenue
    N12 0DG London
    Leila's House, 55 Christchurch Avenue
    England
    EnglandBritish264361250001
    BLANE, Michael Lawrence
    Christchurch Avenue
    N12 0DG London
    Leila's House, 55 Christchurch Avenue
    England
    Administrateur
    Christchurch Avenue
    N12 0DG London
    Leila's House, 55 Christchurch Avenue
    England
    EnglandAmerican37569570002
    BRESLAW, Jeffrey Arnold
    11 Littleberry Court
    St Vincents Lane Mill Hill
    NW7 1EN London
    Administrateur
    11 Littleberry Court
    St Vincents Lane Mill Hill
    NW7 1EN London
    United KingdomBritish103793070001
    CALVERT, Hyman Louis
    64 Deansway
    Finchley
    N2 0HY London
    Administrateur
    64 Deansway
    Finchley
    N2 0HY London
    British54160710001
    CALVERT, Hyman Louis
    64 Deansway
    Finchley
    N2 0HY London
    Administrateur
    64 Deansway
    Finchley
    N2 0HY London
    British54160710001
    CALVERT, Joan Reva
    64 Deansway
    Finchley
    N2 0HY London
    Administrateur
    64 Deansway
    Finchley
    N2 0HY London
    British54160800001
    CANNON, Elise Rebecca, Dr
    Christchurch Avenue
    N12 0DG London
    Leila's House, 55 Christchurch Avenue
    England
    Administrateur
    Christchurch Avenue
    N12 0DG London
    Leila's House, 55 Christchurch Avenue
    England
    EnglandBritish178245700001
    COHEN, Alan Charles, Dr
    Christchurch Avenue
    N12 0DG London
    Leila's House, 55 Christchurch Avenue
    England
    Administrateur
    Christchurch Avenue
    N12 0DG London
    Leila's House, 55 Christchurch Avenue
    England
    EnglandBritish134094310001
    COHEN, Terence Samuel Jamie Crane
    1 Cranley Terrace
    Holders Hill Drive
    NW4 1NQ London
    Administrateur
    1 Cranley Terrace
    Holders Hill Drive
    NW4 1NQ London
    United KingdomBritish82963910001
    CURRY, Lionel Gerald
    6 Priory Road
    NW6 4SG London
    Administrateur
    6 Priory Road
    NW6 4SG London
    United KingdomBritish75180780003
    FABIAN, Ross Marc
    Christchurch Avenue
    N12 0DG London
    Leila's House, 55 Christchurch Avenue
    England
    Administrateur
    Christchurch Avenue
    N12 0DG London
    Leila's House, 55 Christchurch Avenue
    England
    EnglandBritish220691140001
    FELDMAN, Raymond, Professor
    38 Harrowes Meade
    HA8 8RP Edgware
    Middlesex
    Administrateur
    38 Harrowes Meade
    HA8 8RP Edgware
    Middlesex
    British12033120001
    FOX, Debra Jane
    Christchurch Avenue
    N12 0DG London
    Leila's House, 55 Christchurch Avenue
    England
    Administrateur
    Christchurch Avenue
    N12 0DG London
    Leila's House, 55 Christchurch Avenue
    England
    EnglandBritish126187750001
    GALE, Norman Eric, Doctor
    Gorford Court Marsh Lane
    HA7 4TQ London
    Administrateur
    Gorford Court Marsh Lane
    HA7 4TQ London
    British54624850002
    GALE, Norman Eric, Reverend Doctor Ba
    Flat 19 Palace Court
    NW3 6DN London
    Administrateur
    Flat 19 Palace Court
    NW3 6DN London
    British54624850001
    GARDNER, Doris
    23 Cedar Drive
    N2 0PS London
    Administrateur
    23 Cedar Drive
    N2 0PS London
    EnglandBritish3098020002
    GARDNER, Doris
    69 Sheringham
    NW8 6RB London
    Administrateur
    69 Sheringham
    NW8 6RB London
    British3098020001
    GARDNER, Jack
    23 Cedar Drive
    N2 0PS London
    Administrateur
    23 Cedar Drive
    N2 0PS London
    British35683880002
    GLASS, Michael Stuart
    Christchurch Avenue
    N12 0DG London
    Leila's House, 55 Christchurch Avenue
    England
    Administrateur
    Christchurch Avenue
    N12 0DG London
    Leila's House, 55 Christchurch Avenue
    England
    EnglandBritish150613970002
    GOLDSTONE, Jennifer Anne
    67 Loom Lane
    WD7 8NX Radlett
    Hertfordshire
    Administrateur
    67 Loom Lane
    WD7 8NX Radlett
    Hertfordshire
    EnglandBritish60802370001
    GOODMAN, Lewis Raphael
    57 Acacia Road
    NW8 6AG London
    Administrateur
    57 Acacia Road
    NW8 6AG London
    British58321360001
    GRAYSON, Jose David
    Christchurch Avenue
    N12 0DG London
    Leila's House, 55 Christchurch Avenue
    England
    Administrateur
    Christchurch Avenue
    N12 0DG London
    Leila's House, 55 Christchurch Avenue
    England
    EnglandBritish174310490001
    HARRIS, Raymond Ian
    3 Golfside Close
    N20 0RD London
    Administrateur
    3 Golfside Close
    N20 0RD London
    United KingdomBritish91547170001
    HELMAN, Anthony Lawrence
    20 Duchy Road
    Hadley Wood
    EN4 0HU Barnet
    Hertfordshire
    Administrateur
    20 Duchy Road
    Hadley Wood
    EN4 0HU Barnet
    Hertfordshire
    EnglandBritish2108520001
    HUTCHINSON, James Philip
    Christchurch Avenue
    N12 0DG London
    Leila's House, 55 Christchurch Avenue
    England
    Administrateur
    Christchurch Avenue
    N12 0DG London
    Leila's House, 55 Christchurch Avenue
    England
    EnglandBritish131748800002

    Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour THE JEWISH ASSOCIATION FOR MENTAL ILLNESS ?

    Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
    Notifié leCessé leDéclaration
    07 juin 2017La société sait ou a des raisons de croire qu'aucune personne enregistrable ou entité juridique pertinente enregistrable n'est liée à la société.

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0