THE JEWISH ASSOCIATION FOR MENTAL ILLNESS
Vue d'ensemble
| Nom de la société | THE JEWISH ASSOCIATION FOR MENTAL ILLNESS |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société privée à responsabilité limitée par garantie sans capital social, exemption d'utilisation de 'Limited' |
| Numéro de société | 02618170 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe THE JEWISH ASSOCIATION FOR MENTAL ILLNESS ?
| Adresse du siège social | Amelie House Maurice And Vivienne Wohl Campus 221 Golders Green Road NW11 9DQ London United Kingdom |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de THE JEWISH ASSOCIATION FOR MENTAL ILLNESS ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 mars 2024 |
Quel est le statut de la derni ère déclaration de confirmation pour THE JEWISH ASSOCIATION FOR MENTAL ILLNESS ?
| Dernière déclaration de confirmation | |
|---|---|
| Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 07 juin 2025 |
Quels sont les derniers dépôts pour THE JEWISH ASSOCIATION FOR MENTAL ILLNESS ?
| Date | Description | Document | Type | |
|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||
La procédure de radiation volontaire a été suspendue. | 1 pages | SOAS(A) | ||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 2 pages | DS01 | ||
Période comptable actuelle prolongée du 31 mars 2025 au 30 sept. 2025 | 1 pages | AA01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 07 juin 2025 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes pour une petite entreprise établis au 31 mars 2024 | 52 pages | AA | ||
Nomination de Mr Jonathan Simon West en tant qu'administrateur le 18 mars 2024 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Jonathan David Zenios en tant que directeur le 26 sept. 2024 | 1 pages | TM01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 07 juin 2024 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Nomination de Mr Jonathan Zenios en tant qu'administrateur le 18 mars 2024 | 2 pages | AP01 | ||
Changement d'adresse du siège social de Amelie House the Maurice and Vivienne Wohl Campus 221 Golders Green Road London NW11 6TG United Kingdom à Amelie House Maurice and Vivienne Wohl Campus 221 Golders Green Road London NW11 9DQ le 08 avr. 2024 | 1 pages | AD01 | ||
Changement d'adresse du siège social de Leila's House, 55 Christchurch Avenue Christchurch Avenue London N12 0DG England à Amelie House the Maurice and Vivienne Wohl Campus 221 Golders Green Road London NW11 6TG le 04 avr. 2024 | 1 pages | AD01 | ||
Nomination de Mr Jonathan West en tant que secrétaire le 18 mars 2024 | 2 pages | AP03 | ||
Cessation de la nomination de Abigail Joanna Swerdlow en tant que directeur le 18 mars 2024 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Warren Paul Taylor en tant que directeur le 18 mars 2024 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Susan Sara Mandelbaum en tant que directeur le 18 mars 2024 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Gemma Lyons en tant que directeur le 18 mars 2024 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Gideon Max Holme Kay en tant que directeur le 18 mars 2024 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Michael Stuart Glass en tant que directeur le 18 mars 2024 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Tessa Shelley Ingram Arnold en tant que directeur le 18 mars 2024 | 1 pages | TM01 | ||
Nomination de Mr Daniel Carmel Brown en tant qu'administrateur le 18 mars 2024 | 2 pages | AP01 | ||
Comptes annuels établis au 31 mars 2023 | 55 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 07 juin 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Nomination de Ms Gemma Lyons en tant qu'administrateur le 09 févr. 2023 | 2 pages | AP01 | ||
Qui sont les dirigeants de THE JEWISH ASSOCIATION FOR MENTAL ILLNESS ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST, Jonathan | Secrétaire | 221 Golders Green Road NW11 9DQ London Amelie House England | 321285410001 | |||||||
| CARMEL BROWN, Daniel | Administrateur | Maurice And Vivienne Wohl Campus 221 Golders Green Road NW11 9DQ London Amelie House United Kingdom | United Kingdom | British | 321281370001 | |||||
| DAWSON, Adam David | Administrateur | Maurice And Vivienne Wohl Campus 221 Golders Green Road NW11 9DQ London Amelie House United Kingdom | England | British | 156415400001 | |||||
| WEST, Jonathan Simon | Administrateur | Maurice And Vivienne Wohl Campus 221 Golders Green Road NW11 9DQ London Amelie House United Kingdom | United Kingdom | British | 169908920002 | |||||
| LAZARUS, Alan Brian | Secrétaire | Flat 10 Randall Court Page Street Mill Hill NW7 2NJ London | British | 21758750001 | ||||||
| CCS SECRETARIES LIMITED | Secrétaire désigné | 120 East Road N1 6AA London | 900001720001 | |||||||
| AARON, Jean | Administrateur | 24 Brookland Rise NW11 6DP London | United Kingdom | British | 52911560003 | |||||
| AARON, Jean | Administrateur | 1 Queenswood Park Finchley N3 1UN London | British | 52911560001 | ||||||
| AARON, Martin, Professor | Administrateur | 24 Brookland Rise NW11 6DP London | United Kingdom | British | 7380060005 | |||||
| ARNOLD, Tessa Shelley Ingram | Administrateur | Christchurch Avenue N12 0DG London Leila's House, 55 Christchurch Avenue England | United Kingdom | British | 263181090001 | |||||
| BENSON, Richard Jonathan | Administrateur | Christchurch Avenue N12 0DG London Leila's House, 55 Christchurch Avenue England | England | British | 264361250001 | |||||
| BLANE, Michael Lawrence | Administrateur | Christchurch Avenue N12 0DG London Leila's House, 55 Christchurch Avenue England | England | American | 37569570002 | |||||
| BRESLAW, Jeffrey Arnold | Administrateur | 11 Littleberry Court St Vincents Lane Mill Hill NW7 1EN London | United Kingdom | British | 103793070001 | |||||
| CALVERT, Hyman Louis | Administrateur | 64 Deansway Finchley N2 0HY London | British | 54160710001 | ||||||
| CALVERT, Hyman Louis | Administrateur | 64 Deansway Finchley N2 0HY London | British | 54160710001 | ||||||
| CALVERT, Joan Reva | Administrateur | 64 Deansway Finchley N2 0HY London | British | 54160800001 | ||||||
| CANNON, Elise Rebecca, Dr | Administrateur | Christchurch Avenue N12 0DG London Leila's House, 55 Christchurch Avenue England | England | British | 178245700001 | |||||
| COHEN, Alan Charles, Dr | Administrateur | Christchurch Avenue N12 0DG London Leila's House, 55 Christchurch Avenue England | England | British | 134094310001 | |||||
| COHEN, Terence Samuel Jamie Crane | Administrateur | 1 Cranley Terrace Holders Hill Drive NW4 1NQ London | United Kingdom | British | 82963910001 | |||||
| CURRY, Lionel Gerald | Administrateur | 6 Priory Road NW6 4SG London | United Kingdom | British | 75180780003 | |||||
| FABIAN, Ross Marc | Administrateur | Christchurch Avenue N12 0DG London Leila's House, 55 Christchurch Avenue England | England | British | 220691140001 | |||||
| FELDMAN, Raymond, Professor | Administrateur | 38 Harrowes Meade HA8 8RP Edgware Middlesex | British | 12033120001 | ||||||
| FOX, Debra Jane | Administrateur | Christchurch Avenue N12 0DG London Leila's House, 55 Christchurch Avenue England | England | British | 126187750001 | |||||
| GALE, Norman Eric, Doctor | Administrateur | Gorford Court Marsh Lane HA7 4TQ London | British | 54624850002 | ||||||
| GALE, Norman Eric, Reverend Doctor Ba | Administrateur | Flat 19 Palace Court NW3 6DN London | British | 54624850001 | ||||||
| GARDNER, Doris | Administrateur | 23 Cedar Drive N2 0PS London | England | British | 3098020002 | |||||
| GARDNER, Doris | Administrateur | 69 Sheringham NW8 6RB London | British | 3098020001 | ||||||
| GARDNER, Jack | Administrateur | 23 Cedar Drive N2 0PS London | British | 35683880002 | ||||||
| GLASS, Michael Stuart | Administrateur | Christchurch Avenue N12 0DG London Leila's House, 55 Christchurch Avenue England | England | British | 150613970002 | |||||
| GOLDSTONE, Jennifer Anne | Administrateur | 67 Loom Lane WD7 8NX Radlett Hertfordshire | England | British | 60802370001 | |||||
| GOODMAN, Lewis Raphael | Administrateur | 57 Acacia Road NW8 6AG London | British | 58321360001 | ||||||
| GRAYSON, Jose David | Administrateur | Christchurch Avenue N12 0DG London Leila's House, 55 Christchurch Avenue England | England | British | 174310490001 | |||||
| HARRIS, Raymond Ian | Administrateur | 3 Golfside Close N20 0RD London | United Kingdom | British | 91547170001 | |||||
| HELMAN, Anthony Lawrence | Administrateur | 20 Duchy Road Hadley Wood EN4 0HU Barnet Hertfordshire | England | British | 2108520001 | |||||
| HUTCHINSON, James Philip | Administrateur | Christchurch Avenue N12 0DG London Leila's House, 55 Christchurch Avenue England | England | British | 131748800002 |
Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour THE JEWISH ASSOCIATION FOR MENTAL ILLNESS ?
| Notifié le | Cessé le | Déclaration |
|---|---|---|
| 07 juin 2017 | La société sait ou a des raisons de croire qu'aucune personne enregistrable ou entité juridique pertinente enregistrable n'est liée à la société. |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0