MEDITECH IT LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | MEDITECH IT LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 02620845 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe MEDITECH IT LIMITED ?
Adresse du siège social | Unit 3, Stourton Link Intermezzo Drive LS10 1DF Leeds England |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de MEDITECH IT LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 28 févr. 2021 |
Quels sont les derniers dépôts pour MEDITECH IT LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |
---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 1 pages | DS01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 12 juin 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes pour une petite entreprise établis au 28 févr. 2021 | 11 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 12 juin 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Cessation de la nomination de John Antony Midgley en tant que directeur le 15 févr. 2021 | 1 pages | TM01 | ||
Nomination de Mr Jack William Edwards-Fox en tant qu'administrateur le 15 févr. 2021 | 2 pages | AP01 | ||
Nomination de Ms Emma Claire Harvey-Kitching en tant qu'administrateur le 15 févr. 2021 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Paul Martin Steeper en tant que directeur le 15 févr. 2021 | 1 pages | TM01 | ||
Comptes pour une petite entreprise établis au 29 févr. 2020 | 11 pages | AA | ||
Modification des détails de Meditech Group Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 15 août 2017 | 2 pages | PSC05 | ||
Déclaration de confirmation établie le 12 juin 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes pour une petite entreprise établis au 28 févr. 2019 | 11 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 12 juin 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes pour une petite entreprise établis au 28 févr. 2018 | 11 pages | AA | ||
Cessation de la nomination de John Antony Midgley en tant que secrétaire le 18 sept. 2018 | 1 pages | TM02 | ||
Nomination de Ms Emma Claire Harvey-Kitching en tant que secrétaire le 18 sept. 2018 | 2 pages | AP03 | ||
Déclaration de confirmation établie le 12 juin 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes d'exonération totale établis au 28 févr. 2017 | 10 pages | AA | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr John Antony Midgley le 24 août 2017 | 2 pages | CH01 | ||
Modification des détails de Mr John Antony Midgley en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 24 août 2017 | 2 pages | PSC04 | ||
Changement d'adresse du siège social de Unit 7 Severn Road Hunslet Leeds LS10 1BL England à Unit 3, Stourton Link Intermezzo Drive Leeds LS10 1DF le 15 août 2017 | 1 pages | AD01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 12 juin 2017 avec mises à jour | 7 pages | CS01 | ||
legacy | 1 pages | SH20 | ||
Qui sont les dirigeants de MEDITECH IT LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HARVEY-KITCHING, Emma Claire | Secrétaire | Intermezzo Drive LS10 1DF Leeds Unit 3, Stourton Link England | 250527680001 | |||||||
EDWARDS-FOX, Jack William | Administrateur | Intermezzo Drive LS10 1DF Leeds Unit 3, Stourton Link England | England | British | Director | 279716140001 | ||||
HARVEY-KITCHING, Emma Claire | Administrateur | Intermezzo Drive LS10 1DF Leeds Unit 3, Stourton Link England | England | British | Director | 279714040001 | ||||
CROSS, Richard Alexander | Secrétaire | The Old School House Church Hill, Charing Heath TN27 0BU Ashford Kent | British | Company Director | 178817310001 | |||||
HOLLAMBY, John | Secrétaire | Melborne House 124a Borden Lane ME9 8HR Sittingbourne Kent | British | 11350680003 | ||||||
MIDGLEY, John Antony | Secrétaire | Intermezzo Drive LS10 1DF Leeds Unit 3, Stourton Link England | British | Director | 45716360002 | |||||
O CALLAGHAN, Perry Charles | Secrétaire | 9 Court Lodge Cottages Lower Road East Farleigh ME15 0JL Maidstone Kent | British | 79595830001 | ||||||
ORAM, Stephen Marcus | Secrétaire | Shernold House 1a Paynes Lane ME15 9QT Maidstone Kent | British | Accountant | 57274140002 | |||||
AA COMPANY SERVICES LIMITED | Secrétaire désigné | First Floor Offices 8-10 Stamford Hill N16 6XZ London | 900002630001 | |||||||
HBJGW SECRETARIAL SUPPORT LIMITED | Secrétaire | One Eleven Edmund Street B3 2HJ Birmingham West Midlands | 93128710002 | |||||||
CROSS, Richard Alexander | Administrateur | The Old School House Church Hill, Charing Heath TN27 0BU Ashford Kent | Uk | British | Company Director | 178817310001 | ||||
ELLIOTT, Roy Alexander | Administrateur | 22 Fiske Pightle Ipswich Road Willisham IP8 4SN Ipswich Suffolk | British | Prosthetist | 44159400001 | |||||
HOLLAMBY, John | Administrateur | Melborne House 124a Borden Lane ME9 8HR Sittingbourne Kent | British | Prosthetist | 11350680003 | |||||
IVES BROWN, Geoffrey William | Administrateur | 90 Broughton Road South Woodham Ferrers CM3 5FY Chelmsford Essex | British | Prosthetist | 44159310001 | |||||
JOHNSON, Robert Montague | Administrateur | 12 Hamilton Terrace NW8 9UG London | British & American | Director | 17964410002 | |||||
JOYCE, Shaun William | Administrateur | c/o Rsl Steeper Hunslet Trading Estate Severn Road LS10 1BL Leeds Unit 7 United Kingdom | England | British | Director | 133825540001 | ||||
MIDGLEY, John Antony | Administrateur | Intermezzo Drive LS10 1DF Leeds Unit 3, Stourton Link England | United Kingdom | British | Director | 45716360003 | ||||
MILLER, Anthony Charles | Administrateur | Walnut Tree Cottage Little London Combs IP14 2ES Stowmarket Suffolk | United Kingdom | British | Prosthetist | 17474200003 | ||||
O'CALLAGHAN, Perry Charles | Administrateur | 9 Court Lodge Cottages Lower Road East Farleigh ME15 0JL Maidstone Kent | England | British | Accountant | 30363240003 | ||||
ORAM, Stephen Marcus | Administrateur | Shernold House 1a Paynes Lane ME15 9QT Maidstone Kent | England | British | Accountant | 57274140002 | ||||
PARKER, Stephen Robert | Administrateur | 6 Aspen Way RM15 6TX South Ockendon Essex | British | Prosthetist | 70148000002 | |||||
PARKER, Stephen Robert | Administrateur | 3 Sutton Mead CM2 6QB Chelmsford Essex | British | Prosthetist | 70148000001 | |||||
PESENTI, Stephen John Ross | Administrateur | Flat 8 29 St Stephens Gardens W2 5NA London | British | Investment | 44840210001 | |||||
SHEARD, Gary, Dr | Administrateur | 51 Riverside 2 Medway City Estate ME2 4DP Rochester Kent | England | British | Director | 118863590001 | ||||
SMITH, David George Osborne | Administrateur | 71 Puttney Drive Kemsley ME10 2SJ Sittingbourne Kent | British | Prosthetics | 13513010001 | |||||
STEEPER, Paul Martin | Administrateur | Intermezzo Drive LS10 1DF Leeds Unit 3, Stourton Link England | England | British | Director | 183358890001 | ||||
TAYLOR, James Malcolm | Administrateur | Prospect House Whins Lane Wheelton PR6 8HN Chorley Lancashire | United Kingdom | British | Director | 41836630002 | ||||
THOMAS, Trevor George Corry | Administrateur | 51 Riverside 2 Medway City Estate ME2 4DP Rochester Kent | England | British | Director | 15006120001 | ||||
WEBSTER, Simon Philip | Administrateur | 27 Merrick Square SE1 4JB London | United Kingdom | British | Director | 30932730002 | ||||
BUYVIEW LTD | Administrateur désigné | 1st Floor Offices 8-10 Stamford Hill N16 6XZ London | 900002620001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur MEDITECH IT LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mr John Antony Midgley | 06 avr. 2016 | Intermezzo Drive LS10 1DF Leeds Unit 3, Stourton Link England | Non | ||||||||||
Nationalité: British Pays de résidence: United Kingdom | |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Mr Paul Martin Steeper | 06 avr. 2016 | Intermezzo Drive LS10 1DF Leeds Unit 3, Stourton Link England | Non | ||||||||||
Nationalité: British Pays de résidence: England | |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Meditech Group Limited | 06 avr. 2016 | Intermezzo Drive LS10 1DF Leeds Unit 3 Stourton Link England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
|
MEDITECH IT LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Créé le 05 mars 2004 Livré le 16 mars 2004 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 25 juil. 1995 Livré le 09 août 1995 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0