MEDITECH IT LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéMEDITECH IT LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02620845
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de MEDITECH IT LIMITED ?

    • Développement de logiciels professionnels et grand public (62012) / Information et communication

    Où se situe MEDITECH IT LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Unit 3, Stourton Link
    Intermezzo Drive
    LS10 1DF Leeds
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de MEDITECH IT LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    MEDITECH REHAB LIMITED17 juin 199117 juin 1991

    Quels sont les derniers comptes de MEDITECH IT LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au28 févr. 2021

    Quels sont les derniers dépôts pour MEDITECH IT LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    1 pagesDS01

    Déclaration de confirmation établie le 12 juin 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 28 févr. 2021

    11 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 12 juin 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de John Antony Midgley en tant que directeur le 15 févr. 2021

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Jack William Edwards-Fox en tant qu'administrateur le 15 févr. 2021

    2 pagesAP01

    Nomination de Ms Emma Claire Harvey-Kitching en tant qu'administrateur le 15 févr. 2021

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Paul Martin Steeper en tant que directeur le 15 févr. 2021

    1 pagesTM01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 29 févr. 2020

    11 pagesAA

    Modification des détails de Meditech Group Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 15 août 2017

    2 pagesPSC05

    Déclaration de confirmation établie le 12 juin 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 28 févr. 2019

    11 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 12 juin 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 28 févr. 2018

    11 pagesAA

    Cessation de la nomination de John Antony Midgley en tant que secrétaire le 18 sept. 2018

    1 pagesTM02

    Nomination de Ms Emma Claire Harvey-Kitching en tant que secrétaire le 18 sept. 2018

    2 pagesAP03

    Déclaration de confirmation établie le 12 juin 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale établis au 28 févr. 2017

    10 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr John Antony Midgley le 24 août 2017

    2 pagesCH01

    Modification des détails de Mr John Antony Midgley en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 24 août 2017

    2 pagesPSC04

    Changement d'adresse du siège social de Unit 7 Severn Road Hunslet Leeds LS10 1BL England à Unit 3, Stourton Link Intermezzo Drive Leeds LS10 1DF le 15 août 2017

    1 pagesAD01

    Déclaration de confirmation établie le 12 juin 2017 avec mises à jour

    7 pagesCS01

    legacy

    1 pagesSH20

    Qui sont les dirigeants de MEDITECH IT LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    HARVEY-KITCHING, Emma Claire
    Intermezzo Drive
    LS10 1DF Leeds
    Unit 3, Stourton Link
    England
    Secrétaire
    Intermezzo Drive
    LS10 1DF Leeds
    Unit 3, Stourton Link
    England
    250527680001
    EDWARDS-FOX, Jack William
    Intermezzo Drive
    LS10 1DF Leeds
    Unit 3, Stourton Link
    England
    Administrateur
    Intermezzo Drive
    LS10 1DF Leeds
    Unit 3, Stourton Link
    England
    EnglandBritishDirector279716140001
    HARVEY-KITCHING, Emma Claire
    Intermezzo Drive
    LS10 1DF Leeds
    Unit 3, Stourton Link
    England
    Administrateur
    Intermezzo Drive
    LS10 1DF Leeds
    Unit 3, Stourton Link
    England
    EnglandBritishDirector279714040001
    CROSS, Richard Alexander
    The Old School House
    Church Hill, Charing Heath
    TN27 0BU Ashford
    Kent
    Secrétaire
    The Old School House
    Church Hill, Charing Heath
    TN27 0BU Ashford
    Kent
    BritishCompany Director178817310001
    HOLLAMBY, John
    Melborne House
    124a Borden Lane
    ME9 8HR Sittingbourne
    Kent
    Secrétaire
    Melborne House
    124a Borden Lane
    ME9 8HR Sittingbourne
    Kent
    British11350680003
    MIDGLEY, John Antony
    Intermezzo Drive
    LS10 1DF Leeds
    Unit 3, Stourton Link
    England
    Secrétaire
    Intermezzo Drive
    LS10 1DF Leeds
    Unit 3, Stourton Link
    England
    BritishDirector45716360002
    O CALLAGHAN, Perry Charles
    9 Court Lodge Cottages
    Lower Road East Farleigh
    ME15 0JL Maidstone
    Kent
    Secrétaire
    9 Court Lodge Cottages
    Lower Road East Farleigh
    ME15 0JL Maidstone
    Kent
    British79595830001
    ORAM, Stephen Marcus
    Shernold House
    1a Paynes Lane
    ME15 9QT Maidstone
    Kent
    Secrétaire
    Shernold House
    1a Paynes Lane
    ME15 9QT Maidstone
    Kent
    BritishAccountant57274140002
    AA COMPANY SERVICES LIMITED
    First Floor Offices 8-10 Stamford Hill
    N16 6XZ London
    Secrétaire désigné
    First Floor Offices 8-10 Stamford Hill
    N16 6XZ London
    900002630001
    HBJGW SECRETARIAL SUPPORT LIMITED
    One Eleven Edmund Street
    B3 2HJ Birmingham
    West Midlands
    Secrétaire
    One Eleven Edmund Street
    B3 2HJ Birmingham
    West Midlands
    93128710002
    CROSS, Richard Alexander
    The Old School House
    Church Hill, Charing Heath
    TN27 0BU Ashford
    Kent
    Administrateur
    The Old School House
    Church Hill, Charing Heath
    TN27 0BU Ashford
    Kent
    UkBritishCompany Director178817310001
    ELLIOTT, Roy Alexander
    22 Fiske Pightle Ipswich Road
    Willisham
    IP8 4SN Ipswich
    Suffolk
    Administrateur
    22 Fiske Pightle Ipswich Road
    Willisham
    IP8 4SN Ipswich
    Suffolk
    BritishProsthetist44159400001
    HOLLAMBY, John
    Melborne House
    124a Borden Lane
    ME9 8HR Sittingbourne
    Kent
    Administrateur
    Melborne House
    124a Borden Lane
    ME9 8HR Sittingbourne
    Kent
    BritishProsthetist11350680003
    IVES BROWN, Geoffrey William
    90 Broughton Road
    South Woodham Ferrers
    CM3 5FY Chelmsford
    Essex
    Administrateur
    90 Broughton Road
    South Woodham Ferrers
    CM3 5FY Chelmsford
    Essex
    BritishProsthetist44159310001
    JOHNSON, Robert Montague
    12 Hamilton Terrace
    NW8 9UG London
    Administrateur
    12 Hamilton Terrace
    NW8 9UG London
    British & AmericanDirector17964410002
    JOYCE, Shaun William
    c/o Rsl Steeper
    Hunslet Trading Estate
    Severn Road
    LS10 1BL Leeds
    Unit 7
    United Kingdom
    Administrateur
    c/o Rsl Steeper
    Hunslet Trading Estate
    Severn Road
    LS10 1BL Leeds
    Unit 7
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector133825540001
    MIDGLEY, John Antony
    Intermezzo Drive
    LS10 1DF Leeds
    Unit 3, Stourton Link
    England
    Administrateur
    Intermezzo Drive
    LS10 1DF Leeds
    Unit 3, Stourton Link
    England
    United KingdomBritishDirector45716360003
    MILLER, Anthony Charles
    Walnut Tree Cottage Little London
    Combs
    IP14 2ES Stowmarket
    Suffolk
    Administrateur
    Walnut Tree Cottage Little London
    Combs
    IP14 2ES Stowmarket
    Suffolk
    United KingdomBritishProsthetist17474200003
    O'CALLAGHAN, Perry Charles
    9 Court Lodge Cottages
    Lower Road East Farleigh
    ME15 0JL Maidstone
    Kent
    Administrateur
    9 Court Lodge Cottages
    Lower Road East Farleigh
    ME15 0JL Maidstone
    Kent
    EnglandBritishAccountant30363240003
    ORAM, Stephen Marcus
    Shernold House
    1a Paynes Lane
    ME15 9QT Maidstone
    Kent
    Administrateur
    Shernold House
    1a Paynes Lane
    ME15 9QT Maidstone
    Kent
    EnglandBritishAccountant57274140002
    PARKER, Stephen Robert
    6 Aspen Way
    RM15 6TX South Ockendon
    Essex
    Administrateur
    6 Aspen Way
    RM15 6TX South Ockendon
    Essex
    BritishProsthetist70148000002
    PARKER, Stephen Robert
    3 Sutton Mead
    CM2 6QB Chelmsford
    Essex
    Administrateur
    3 Sutton Mead
    CM2 6QB Chelmsford
    Essex
    BritishProsthetist70148000001
    PESENTI, Stephen John Ross
    Flat 8 29 St Stephens Gardens
    W2 5NA London
    Administrateur
    Flat 8 29 St Stephens Gardens
    W2 5NA London
    BritishInvestment44840210001
    SHEARD, Gary, Dr
    51 Riverside 2
    Medway City Estate
    ME2 4DP Rochester
    Kent
    Administrateur
    51 Riverside 2
    Medway City Estate
    ME2 4DP Rochester
    Kent
    EnglandBritishDirector118863590001
    SMITH, David George Osborne
    71 Puttney Drive
    Kemsley
    ME10 2SJ Sittingbourne
    Kent
    Administrateur
    71 Puttney Drive
    Kemsley
    ME10 2SJ Sittingbourne
    Kent
    BritishProsthetics13513010001
    STEEPER, Paul Martin
    Intermezzo Drive
    LS10 1DF Leeds
    Unit 3, Stourton Link
    England
    Administrateur
    Intermezzo Drive
    LS10 1DF Leeds
    Unit 3, Stourton Link
    England
    EnglandBritishDirector183358890001
    TAYLOR, James Malcolm
    Prospect House Whins Lane
    Wheelton
    PR6 8HN Chorley
    Lancashire
    Administrateur
    Prospect House Whins Lane
    Wheelton
    PR6 8HN Chorley
    Lancashire
    United KingdomBritishDirector41836630002
    THOMAS, Trevor George Corry
    51 Riverside 2
    Medway City Estate
    ME2 4DP Rochester
    Kent
    Administrateur
    51 Riverside 2
    Medway City Estate
    ME2 4DP Rochester
    Kent
    EnglandBritishDirector15006120001
    WEBSTER, Simon Philip
    27 Merrick Square
    SE1 4JB London
    Administrateur
    27 Merrick Square
    SE1 4JB London
    United KingdomBritishDirector30932730002
    BUYVIEW LTD
    1st Floor Offices
    8-10 Stamford Hill
    N16 6XZ London
    Administrateur désigné
    1st Floor Offices
    8-10 Stamford Hill
    N16 6XZ London
    900002620001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur MEDITECH IT LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Mr John Antony Midgley
    Intermezzo Drive
    LS10 1DF Leeds
    Unit 3, Stourton Link
    England
    06 avr. 2016
    Intermezzo Drive
    LS10 1DF Leeds
    Unit 3, Stourton Link
    England
    Non
    Nationalité: British
    Pays de résidence: United Kingdom
    Nature du contrôle
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.
    Mr Paul Martin Steeper
    Intermezzo Drive
    LS10 1DF Leeds
    Unit 3, Stourton Link
    England
    06 avr. 2016
    Intermezzo Drive
    LS10 1DF Leeds
    Unit 3, Stourton Link
    England
    Non
    Nationalité: British
    Pays de résidence: England
    Nature du contrôle
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.
    Intermezzo Drive
    LS10 1DF Leeds
    Unit 3 Stourton Link
    England
    06 avr. 2016
    Intermezzo Drive
    LS10 1DF Leeds
    Unit 3 Stourton Link
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Limited Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement03039649
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    MEDITECH IT LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 05 mars 2004
    Livré le 16 mars 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 16 mars 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 mars 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 25 juil. 1995
    Livré le 09 août 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 09 août 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 mars 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0