PNI DIGITAL MEDIA EUROPE LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | PNI DIGITAL MEDIA EUROPE LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 02626037 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe PNI DIGITAL MEDIA EUROPE LIMITED ?
| Adresse du siège social | Suite R, Medina Chamber Town Quay SO14 2AQ Southampton |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de PNI DIGITAL MEDIA EUROPE LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 janv. 2017 |
Quels sont les derniers dépôts pour PNI DIGITAL MEDIA EUROPE LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Demande de radiation de la soci été du registre du commerce | 1 pages | DS01 | ||||||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||||||
État du capital au 25 oct. 2018
| 3 pages | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 21 mai 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||||||
Nomination de Steven Douglas Bussberg en tant qu'administrateur le 04 févr. 2018 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Christine Tomlinson Komola en tant que directeur le 03 févr. 2018 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Comptes pour une petite entreprise établis au 31 janv. 2017 | 12 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 21 mai 2017 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 janv. 2016 | 13 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 21 mai 2016 avec liste complète des actionnaires | 3 pages | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 janv. 2015 | 16 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 21 mai 2015 avec liste complète des actionnaires | 3 pages | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Période comptable actuelle prolongée du 30 sept. 2014 au 31 janv. 2015 | 1 pages | AA01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Richard Mills en tant que secrétaire le 11 juil. 2014 | 1 pages | TM02 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Cory Harrison Kent en tant que directeur le 07 juil. 2014 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Nomination de Miss Christine Komola en tant qu'administrateur le 11 juil. 2014 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Nomination de Miss Christina Gonzalez en tant que secrétaire le 11 juil. 2014 | 2 pages | AP03 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Peter David Fitzgerald en tant que directeur le 11 juil. 2014 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Karl Wilhelm Thomas Oertel en tant que directeur le 11 juil. 2014 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 21 mai 2014 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Comptes annuels établis au 30 sept. 2013 | 16 pages | AA | ||||||||||||||
Qui sont les dirigeants de PNI DIGITAL MEDIA EUROPE LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GONZALEZ, Christina | Secrétaire | Town Quay SO14 2AQ Southampton Suite R, Medina Chamber | 192508510001 | |||||||
| BUSSBERG, Steven Douglas | Administrateur | Town Quay SO14 2AQ Southampton Suite R, Medina Chamber | United States | American | 243755270001 | |||||
| BODYMORE, Simon | Secrétaire | Norton Court V7G 2E5 North Vancouver 1527 British Columbia Canada | British | 139114110001 | ||||||
| GOWER ISAAC, Edward Alexander | Secrétaire | 14 Bridge Road TW1 1RE Twickenham Middlesex | British | 82666270002 | ||||||
| KEEBLE, Michael Philip | Secrétaire | The Cottage Lower Street Shere GU5 9HX Guildford Surrey | British | 58448930001 | ||||||
| MACDONALD, John Malcolm Kenneth | Secrétaire | Ensor Woodland Drive KT24 5AN East Horsley Surrey | British | 33673310001 | ||||||
| MARTINEZ, Mary Ann | Secrétaire | 1 Foxglove Gardens Merrow Park GU4 7ES Guildford Surrey | British | 76419920001 | ||||||
| MILLS, Richard | Secrétaire | Town Quay SO14 2AQ Southampton Suite R, Medina Chamber England | 171322850001 | |||||||
| SLADEN, Mark | Secrétaire | 44 Jubilee Rd GU11 3QE Aldershot Hants | British | 124780840001 | ||||||
| SPARSHATT, Alison | Secrétaire | Michaelmas Cottage The Green GU8 6HA Elstead Surrey | British | 78094290001 | ||||||
| YASHIV, Yuval | Secrétaire | Flat 6 68 Greencroft Gardens NW6 3JQ London | French | 54203420001 | ||||||
| COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secrétaire désigné | Victoria House 64 Paul Street EC2A 4NG London | 900000080001 | |||||||
| BENSON, Peter Macleod | Administrateur | 2 Kings Quay Chelsea Harbour SW10 0UX London | England | British | 41171190007 | |||||
| BIGGS, Robert Nigel | Administrateur | 1 Foxglove Gardens Merrow Park GU4 7ES Guildford Surrey | England | British | 37514520001 | |||||
| BOTT, Gordon James | Administrateur | Tichsa 10 Greenhill Farm Bishops Itchington CV47 2SS Southam | United Kingdom | British | 30349880001 | |||||
| CHAPCHAL, Daniel Robert | Administrateur | Varykino 9 Ridgelands Fetcham KT22 9DB Leatherhead Surrey | England | British | 75090790001 | |||||
| CHISHOLM, John Robert | Administrateur | 2775 Cypress Street FOREIGN Vancouver V6j 5b9 British Columbia Canada | Canadian | 123034990001 | ||||||
| DRAKE, Thomas Roger | Administrateur | Warren Lea Sandy Lane Kingswood KT20 6ND Tadworth Surrey | England | British | 122933820001 | |||||
| FITZGERALD, Peter David | Administrateur | The Ridge Shootersway HP4 3NJ Berkhamsted Hertfordshire | England | British | 123034740002 | |||||
| GOWER ISAAC, Edward Alexander | Administrateur | 14 Bridge Road TW1 1RE Twickenham Middlesex | British | 82666270002 | ||||||
| KENT, Cory Harrison | Administrateur | 3520 Aintree Drive North Vancouver British Columbia V7r 4e3 Canada | Usa | Canadian | 123180970001 | |||||
| KOMOLA, Christine Tomlinson | Administrateur | Town Quay SO14 2AQ Southampton Suite R, Medina Chamber | United States | American | 279221610001 | |||||
| KURTZBARD, Yoav | Administrateur | 6 Ashley Court Frognal Lane NW3 7DX London | British | 45132920001 | ||||||
| MACDONALD, John Malcolm Kenneth | Administrateur | Ensor Woodland Drive KT24 5AN East Horsley Surrey | British | 33673310001 | ||||||
| MARTINEZ, Mary Ann | Administrateur | 1 Foxglove Gardens Merrow Park GU4 7ES Guildford Surrey | England | British | 76419920001 | |||||
| OERTEL, Karl Wilhelm Thomas | Administrateur | Town Quay SO14 2AQ Southampton Suite R, Medina Chamber England | United Kingdom | German | 173351170001 | |||||
| RALLO, Aaron | Administrateur | 15127 Ne 24th Street Apartment 479 Redmond 98052 King Usa | Usa | American | 123034910001 | |||||
| RICHARDS, Michael Clive | Administrateur | 46 Recreation Road GU1 1HP Guildford Surrey | British | 48310530001 | ||||||
| STROUD, Michael Hugh | Administrateur | 65 Applegarth Avenue GU2 6LX Guildford Surrey | United Kingdom | British | 154949870001 | |||||
| WARE, Harley Keith | Administrateur | Collingwood Crescent Surrey V3S 0J3 Canada 15860 Bc | United Kingdom | British | 54497260006 | |||||
| WHATLEY, Andrea | Administrateur | White Horse Cottage White Horse Lane Ripley GU23 6BJ Woking | British | 95462410002 | ||||||
| WRIGHT, Terence Richard, Dr | Administrateur | 182 Headstone Lane HA2 6LY Harrow Middlesex | United Kingdom | British | 336269790002 | |||||
| YASHIV, Yuval | Administrateur | 20 The Vale NW11 8SG London | French | 54203420002 | ||||||
| YOUNG-OF-GRAFFHAM, David Ivor, Lord | Administrateur | 28 York Terrace West NW1 4QA London | United Kingdom | British | 79261740001 | |||||
| ZIMMERMAN, Stephen Anthony | Administrateur | 35 Stormont Road N6 4NR London | United Kingdom | British | 13330330003 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur PNI DIGITAL MEDIA EUROPE LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pni Digital Media Ulc | 06 avr. 2016 | Carrall St Vancouver V6b 6e3 100-425 Bc Canada | Non | ||||
| |||||||
Nature du contrôle
| |||||||
PNI DIGITAL MEDIA EUROPE LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Deed of postponement and assignment of claims | Créé le 26 janv. 2012 Livré le 01 févr. 2012 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions As a continuing security all debts and liabilities present and future of pni digital media inc (incorporated in british columbia canada under number BC0509287) and all benefits and other rights which may arise under the claims see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Rent deposit deed | Créé le 22 avr. 2008 Livré le 24 avr. 2008 | En cours | Montant garanti £6,386.33 due or to become due from the company to the chargee | |
Brèves mentions The sum of £6,386.33. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Rent deposit deed | Créé le 27 nov. 2000 Livré le 15 déc. 2000 | Totalement satisfaite | Montant garanti £44,539.12 due or to become due from the company to the chargee | |
Brèves mentions Lease dated 29 february 1997 relating to ground floor 20 chancellor court surrey research park guildford surrey. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Fixed and floating charge | Créé le 02 juil. 1996 Livré le 05 juil. 1996 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Charge over credit balances | Créé le 30 mars 1993 Livré le 05 avr. 1993 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee in relation to a guarantee to a guarantee dated 11 march 1993 in favour of british railways board for £171,500 | |
Brèves mentions The sum of £171,500 together with interest accrued now or to be held by national westminster bank PLC on an account numbered 71010777 and earmarked or designated by reference to the company. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0