PREBON INVESTMENTS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéPREBON INVESTMENTS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02627770
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de PREBON INVESTMENTS LIMITED ?

    • (7415) /

    Où se situe PREBON INVESTMENTS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Tower 42 Level 37
    25 Old Broad Street
    EC2N 1HQ London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de PREBON INVESTMENTS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    F.P. INVESTMENTS LIMITED05 sept. 199105 sept. 1991
    MAWLAW 118 LIMITED09 juil. 199109 juil. 1991

    Quels sont les derniers comptes de PREBON INVESTMENTS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2009

    Quels sont les derniers dépôts pour PREBON INVESTMENTS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    6 pages4.71

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 29 juin 2011

    LRESSP

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2009

    3 pagesAA

    Cessation de la nomination de Andrew Evans en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Robin James Stewart en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Paul Richard Mainwaring le 29 juin 2010

    2 pagesCH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 09 juil. 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital09 août 2010

    État du capital au 09 août 2010

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Nicola Challen le 06 août 2010

    1 pagesCH03

    Résolutions

    Resolutions
    13 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution d'attribution de valeurs mobilières

    RES10
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01
    capital

    Résolutions

    Remove s/cap clause 18/06/2010
    RES13

    Comptes établis au 31 déc. 2008

    3 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    4 pages363a

    legacy

    1 pages288b

    Comptes établis au 31 déc. 2007

    3 pagesAA

    legacy

    1 pages287

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    2 pages288a

    Qui sont les dirigeants de PREBON INVESTMENTS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    CHALLEN, Nicola
    Level 37
    25 Old Broad Street
    EC2N 1HQ London
    Tower 42
    Secrétaire
    Level 37
    25 Old Broad Street
    EC2N 1HQ London
    Tower 42
    Other119903660002
    MAINWARING, Paul Richard
    7 Woodlands Park
    Merrow
    GU1 2TH Guildford
    Surrey
    Administrateur
    7 Woodlands Park
    Merrow
    GU1 2TH Guildford
    Surrey
    EnglandBritish116302540002
    STEWART, Robin James
    Level 37
    25 Old Broad Street
    EC2N 1HQ London
    Tower 42
    Administrateur
    Level 37
    25 Old Broad Street
    EC2N 1HQ London
    Tower 42
    EnglandBritish161299680001
    ANKERS, Peter
    104 Meridian Place
    Marsh Wall
    E14 9FF London
    Secrétaire
    104 Meridian Place
    Marsh Wall
    E14 9FF London
    British56413750001
    ANKERS, Peter
    104 Meridian Place
    Marsh Wall
    E14 9FF London
    Secrétaire
    104 Meridian Place
    Marsh Wall
    E14 9FF London
    British56413750001
    DE FREITAS, Maria Teresa
    Flat 1 47 Lloyd Baker Street
    WC1X 9AA London
    Secrétaire
    Flat 1 47 Lloyd Baker Street
    WC1X 9AA London
    British95153090009
    DEARLOVE, Juliet Mary
    Churchgate House
    15 Churchgate Street
    CM17 0JT Old Harlow
    Essex
    Secrétaire
    Churchgate House
    15 Churchgate Street
    CM17 0JT Old Harlow
    Essex
    British72784040001
    MAYHILL, Geoffrey Ronald
    27 Redmore Road
    W6 0HZ London
    Secrétaire
    27 Redmore Road
    W6 0HZ London
    New Zealander812670001
    PEEL, Alistair Charles
    Deep Acres
    HP6 5NX Amersham
    6
    Bucks
    England
    Secrétaire
    Deep Acres
    HP6 5NX Amersham
    6
    Bucks
    England
    Other132896170001
    SHAW, Gary Allan
    63a Cambray Road
    SW12 0ER London
    Secrétaire
    63a Cambray Road
    SW12 0ER London
    British67579830001
    MAWLAW SECRETARIES LIMITED
    Black Friars Lane
    EC4V 6HD London
    20
    Secrétaire
    Black Friars Lane
    EC4V 6HD London
    20
    39182980001
    PREBON SECRETARIES LIMITED
    Second Floor
    155 Bishopsgate
    EC2N 3DA London
    Secrétaire
    Second Floor
    155 Bishopsgate
    EC2N 3DA London
    37859290001
    COLLIS, Sarah Ann
    53 The Avenue
    West Ealing
    W13 8JR London
    Administrateur
    53 The Avenue
    West Ealing
    W13 8JR London
    EnglandBritish35447290002
    COWAN, Christopher Ian
    Ballards
    Ballards Lane
    RH8 0SN Limpsfield
    Surrey
    Administrateur
    Ballards
    Ballards Lane
    RH8 0SN Limpsfield
    Surrey
    British54679190001
    EVANS, Andrew Keith
    177 Burtons Road
    Hampton Hill
    TW12 1DX Hampton
    Middlesex
    Administrateur
    177 Burtons Road
    Hampton Hill
    TW12 1DX Hampton
    Middlesex
    EnglandBritish124021620001
    FARR, Richard Eric
    Kingston House
    Vicarage Way
    SL9 8AS Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Kingston House
    Vicarage Way
    SL9 8AS Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    British40864220002
    HOLMES, Deborah Ann
    87 Carrara Wharf
    Ranelagh Gardens Putney Bridge
    SW6 3UE London
    Administrateur
    87 Carrara Wharf
    Ranelagh Gardens Putney Bridge
    SW6 3UE London
    Australian113674080001
    HUGHES, Arthur Mcquade
    Miran San
    11 Windlesham Court Snows Ride
    GU20 6LA Windlesham
    Surrey
    Administrateur
    Miran San
    11 Windlesham Court Snows Ride
    GU20 6LA Windlesham
    Surrey
    United KingdomBritish1458920002
    JACK, Stephen Andrew
    1 Hunter Road
    West Wimbledon
    SW20 8NZ London
    Administrateur
    1 Hunter Road
    West Wimbledon
    SW20 8NZ London
    EnglandBritish13013280001
    KEENAN, Patrick Michael
    10 Plane Tree House
    Duchess Of Bedfords Walk
    W8 7QT London
    Administrateur
    10 Plane Tree House
    Duchess Of Bedfords Walk
    W8 7QT London
    Australian42704380002
    KEENAN, Patrick Michael
    84 Iverna Court
    Iverna Gardens Wrights Lane
    W8 6TU London
    Administrateur
    84 Iverna Court
    Iverna Gardens Wrights Lane
    W8 6TU London
    Australia42704380001
    MAYHILL, Geoffrey Ronald
    33 Lawn Crescent
    TW9 3NS Richmond
    Surrey
    Administrateur
    33 Lawn Crescent
    TW9 3NS Richmond
    Surrey
    British812670012
    NEVILLE, Simon Andrew
    2 Woodman Waye
    GU21 5SW Woking
    Surrey
    Administrateur
    2 Woodman Waye
    GU21 5SW Woking
    Surrey
    United KingdomBritish118361370001
    OLDALE, John Keith
    Little Coopers Coopers Hill
    Eversley
    RG27 0QA Basingstoke
    Hampshire
    Administrateur
    Little Coopers Coopers Hill
    Eversley
    RG27 0QA Basingstoke
    Hampshire
    British2038950001
    PLASCO, Joel Darren
    Flat 5
    1 Chepstow Place
    W2 4TE London
    Administrateur
    Flat 5
    1 Chepstow Place
    W2 4TE London
    British78522900003
    SMETHURST, Geoffrey Brian
    7 Birchwood Avenue
    Southborough
    TN4 0UD Tunbridge Wells
    Kent
    Administrateur
    7 Birchwood Avenue
    Southborough
    TN4 0UD Tunbridge Wells
    Kent
    British156520001
    TAYLOR, Kim Michael
    Firholm
    16 St Marys Road
    KT6 5EY Long Ditton
    Surrey
    Administrateur
    Firholm
    16 St Marys Road
    KT6 5EY Long Ditton
    Surrey
    British34697370003

    PREBON INVESTMENTS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Deed of assignment
    Créé le 03 août 1995
    Livré le 17 août 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or fulton prebon group limited to the chargee under the non-care restated agreement
    Brèves mentions
    All the company's right title and interest present and future in and to the assigned account and the assigned monies and all rights to require repayment of the assigned monies. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Samuel Montagu & Co. Limited
    Transactions
    • 17 août 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 31 oct. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee and debenture
    Créé le 08 sept. 1991
    Livré le 27 sept. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee as trustee for the security beneficiaries (as defined) under the terms of the relevant documents (as defined)
    Brèves mentions
    (See form 395 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Samuel Montagu & Co. Limited
    Transactions
    • 27 sept. 1991Enregistrement d'une charge
    • 31 oct. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Share charge
    Créé le 08 sept. 1991
    Livré le 27 sept. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee as trustee for the lenders (as defined) under the terms of the relevant documents (as defined)
    Brèves mentions
    All dividends, interests and other moneys paid or payable in relation to any shares in the capital of lcf limited, babcock fulton prebon (financial futures) limited, babcock & brown limited. (See form 395 for full details).
    Personnes ayant droit
    • Samuel Montagu & Co Limited
    Transactions
    • 27 sept. 1991Enregistrement d'une charge
    • 31 oct. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Security agreement.
    Créé le 08 sept. 1991
    Livré le 27 sept. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from thecompany and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the agreements and other security documents as defined in this charge.
    Brèves mentions
    All of the company's right,title and interest in and to the following detailed particulars as detailed on doc M395-ref M664.see clauses 1(a) to 1(u) inclusive detailed on schedules attached to doc M395.
    Personnes ayant droit
    • Samuel Montagu & Co. Limited
    • As Trustee for the Security Beneficiaries (As Defined)
    Transactions
    • 27 sept. 1991Enregistrement d'une charge
    • 31 oct. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    PREBON INVESTMENTS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    29 juin 2011Commencement of winding up
    13 sept. 2012Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Laura May Waters
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    practitioner
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Timothy Gerard Walsh
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    practitioner
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0