FIRTREE CARE LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéFIRTREE CARE LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02628796
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de FIRTREE CARE LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe FIRTREE CARE LIMITED ?

    Adresse du siège social
    6th Floor One London Wall
    EC2Y 5EB London
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de FIRTREE CARE LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    UNITED CARE (KENT) LIMITED16 oct. 199216 oct. 1992
    FIRTREE HOUSE NURSING HOME LIMITED09 mars 199209 mars 1992
    LESTER ALDRIDGE NUMBER 111 LIMITED12 juil. 199112 juil. 1991

    Quels sont les derniers comptes de FIRTREE CARE LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2020

    Quels sont les derniers dépôts pour FIRTREE CARE LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Cessation de la nomination de Richard Stephen Welch en tant que directeur le 28 févr. 2022

    1 pagesTM01

    Nomination de Paul Ray Womble en tant qu'administrateur le 28 févr. 2022

    2 pagesAP01

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2020

    2 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Richard Stephen Welch le 20 sept. 2021

    2 pagesCH01

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré 2 Temple Back East Temple Quay Bristol BS1 6EG

    1 pagesAD03

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée à 2 Temple Back East Temple Quay Bristol BS1 6EG

    1 pagesAD02

    Changement d'adresse du siège social de 6th Floor 125 London Wall London EC2Y 5AS England à 6th Floor One London Wall London EC2Y 5EB le 09 juil. 2021

    1 pagesAD01

    Cessation de la nomination de Sanne Group Secretaries (Uk) Limited en tant que secrétaire le 30 juin 2021

    1 pagesTM02

    Déclaration de confirmation établie le 22 mai 2021 avec mises à jour

    3 pagesCS01

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Approval of financial statements for 31/12/2019/director authorised to sign the balance sheet 22/12/2020
    RES13

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2019

    2 pagesAA

    Modification des coordonnées du secrétaire Sanne Group Secretaries (Uk) Limited le 10 août 2020

    1 pagesCH04

    Changement d'adresse du siège social de Asticus Building, 2nd Floor 21 Palmer Street London SW1H 0AD à 6th Floor 125 London Wall London EC2Y 5AS le 17 août 2020

    1 pagesAD01

    Déclaration de confirmation établie le 22 mai 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2018

    2 pagesAA

    Cessation de la nomination de Jonathan David Farkas en tant que directeur le 07 juin 2019

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Richard Stephen Welch en tant qu'administrateur le 07 juin 2019

    2 pagesAP01

    Déclaration de confirmation établie le 22 mai 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2017

    2 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 22 mai 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2016

    2 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 22 mai 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Qui sont les dirigeants de FIRTREE CARE LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    WOMBLE, Paul Ray
    E. John Carpenter Freeway
    Suite 1400
    75062 Irving
    545
    Texas
    United States
    Administrateur
    E. John Carpenter Freeway
    Suite 1400
    75062 Irving
    545
    Texas
    United States
    United StatesAmericanCfo293942010001
    ANGELL, Peter George
    29 Bowfield
    Hook
    RG27 9SA Basingstoke
    Hampshire
    Secrétaire
    29 Bowfield
    Hook
    RG27 9SA Basingstoke
    Hampshire
    British781800001
    BREW, Godfrey Arthur
    Plum Tree Cottage
    High Street
    SN8 3AB Burbage
    Wiltshire
    Secrétaire
    Plum Tree Cottage
    High Street
    SN8 3AB Burbage
    Wiltshire
    BritishSolicitor83362410001
    BREW, Godfrey Arthur
    Plum Tree Cottage
    High Street
    SN8 3AB Burbage
    Wiltshire
    Secrétaire
    Plum Tree Cottage
    High Street
    SN8 3AB Burbage
    Wiltshire
    BritishSolicitor83362410001
    DRAKE, John Alwyn
    10 Cavendish Grove
    SO23 7HQ Winchester
    Hampshire
    Secrétaire
    10 Cavendish Grove
    SO23 7HQ Winchester
    Hampshire
    BritishChartered Accountant53228410001
    JAMES, Nicholas David
    74 St Cross Road
    SO23 9PS Winchester
    Hampshire
    Secrétaire
    74 St Cross Road
    SO23 9PS Winchester
    Hampshire
    British36166630001
    JAMES, Nicholas David
    74 St Cross Road
    SO23 9PS Winchester
    Hampshire
    Secrétaire
    74 St Cross Road
    SO23 9PS Winchester
    Hampshire
    British36166630001
    POWELL, Elizabeth Mary
    High Pines 15 Pine Ridge Drive
    Lower Bourne
    GU10 3JR Farnham
    Surrey
    Secrétaire
    High Pines 15 Pine Ridge Drive
    Lower Bourne
    GU10 3JR Farnham
    Surrey
    BritishCo-Director51277850001
    SCHOFIELD, Nigel Bennett
    Bradbury House 830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    Secrétaire
    Bradbury House 830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    British52338530002
    LESTER ALDRIDGE (SECRETARIAL) LIMITED
    Russell House
    Oxford Road
    BH8 8EX Bournemouth
    Dorset
    Secrétaire
    Russell House
    Oxford Road
    BH8 8EX Bournemouth
    Dorset
    4056160001
    SANNE GROUP SECRETARIES (UK) LIMITED
    London Wall
    EC2Y 5AS London
    6th Floor, 125
    England
    Secrétaire
    London Wall
    EC2Y 5AS London
    6th Floor, 125
    England
    Type d'identificationSociété à responsabilité limitée du Royaume-Uni
    Numéro d'enregistrement8334728
    175738460001
    BRIERLEY, David Ian
    63a Belsize Lane
    NW3 5AU London
    Administrateur
    63a Belsize Lane
    NW3 5AU London
    EnglandBritishConsultant110007540001
    CORMACK, Derek George
    Bradbury House 830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    Administrateur
    Bradbury House 830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    EnglandIrishAccountant67400530015
    DIX, Michael John
    26 Kew Green
    Kew
    TW9 3BH London
    Administrateur
    26 Kew Green
    Kew
    TW9 3BH London
    BritishChartered Accountant188830010
    DONNELLY, Aelred Lance
    14 Fielders Way
    East Wellow
    SO51 6EX Romsey
    Hampshire
    Administrateur
    14 Fielders Way
    East Wellow
    SO51 6EX Romsey
    Hampshire
    United KingdomBritishCommercial Mortgage Broker20576700001
    FARKAS, Jonathan David
    Palmer Street
    SW1H 0AD London
    Asticus Building, 2nd Floor 21
    Administrateur
    Palmer Street
    SW1H 0AD London
    Asticus Building, 2nd Floor 21
    LuxembourgAmericanManaging Director193539990001
    GRIFFIN, Craig
    Halebourne House
    Halebourne Lane
    GU24 8SL Chobham
    Surrey
    Administrateur
    Halebourne House
    Halebourne Lane
    GU24 8SL Chobham
    Surrey
    United KingdomBritishProperty Director154122490001
    GUNN, Robert Henry
    2 Grovely Way
    Crampmoor
    SO51 9AX Romsey
    Hampshire
    Administrateur
    2 Grovely Way
    Crampmoor
    SO51 9AX Romsey
    Hampshire
    EnglandBritishNursing Home Operator Company Director20397500001
    HILL, Peter Martin
    Bradbury House 830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    Administrateur
    Bradbury House 830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    EnglandBritishAccountant130983750002
    HOLDEN, Brian John
    East Lodge Newbury Hill
    Penton Mewsey
    SP11 0RW Andover
    Hampshire
    Administrateur
    East Lodge Newbury Hill
    Penton Mewsey
    SP11 0RW Andover
    Hampshire
    BritishCompany Director895520003
    JAMES, Nicholas David
    74 St Cross Road
    SO23 9PS Winchester
    Hampshire
    Administrateur
    74 St Cross Road
    SO23 9PS Winchester
    Hampshire
    United KingdomBritishChartered Accountant36166630001
    JEFFERY, Paul Anthony Keith
    Bradbury House 830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    Administrateur
    Bradbury House 830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    United KingdomBritishAccountant65609290003
    JEFFREY, Helena
    Stable House Cockaynes Farm
    Cockaynes Lane
    CO7 8BZ Alresford
    Essex
    Administrateur
    Stable House Cockaynes Farm
    Cockaynes Lane
    CO7 8BZ Alresford
    Essex
    BritishCompany Director95101350001
    POWELL, David Martin Cleaton
    15 Pine Ridge Drive
    Lower Bourne
    GU10 3JR Farnham
    Surrey
    Administrateur
    15 Pine Ridge Drive
    Lower Bourne
    GU10 3JR Farnham
    Surrey
    BritishBanker10175760002
    SCHOFIELD, Nigel Bennett
    Bradbury House 830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    Administrateur
    Bradbury House 830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    United KingdomBritishSolicitor148139420001
    SILVER, Lynn Suzette
    25 Barham Avenue
    WD6 3PW Elstree
    Hertfordshire
    Administrateur
    25 Barham Avenue
    WD6 3PW Elstree
    Hertfordshire
    BritishDirector50950260001
    STREIFF, Mathieu Bernard
    Pollen House
    10 Cork Street
    W1S 3NP London
    2nd Floor
    Administrateur
    Pollen House
    10 Cork Street
    W1S 3NP London
    2nd Floor
    United StatesAmericanAttorney200529310001
    WELCH, Richard Stephen
    South Flower Street
    44th Floor
    90071 Los Angeles
    515
    California
    United States
    Administrateur
    South Flower Street
    44th Floor
    90071 Los Angeles
    515
    California
    United States
    United StatesAmericanCompany Director249076190001
    WHITE, Ian James
    Bradbury House 830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    Administrateur
    Bradbury House 830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    EnglandBritishAccountant133383410003
    LESTER ALDRIDGE (MANAGEMENT) LIMITED
    Russell House Oxford Road
    BH8 8EX Bournemouth
    Administrateur
    Russell House Oxford Road
    BH8 8EX Bournemouth
    43643830001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur FIRTREE CARE LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    21 Palmer Street
    SW1H 0AD London
    Asticus Building, 2nd Floor
    England
    06 avr. 2016
    21 Palmer Street
    SW1H 0AD London
    Asticus Building, 2nd Floor
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Limited Company
    Pays d'enregistrementUk
    Autorité légaleThe Companies Act 2006
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement04258255
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    FIRTREE CARE LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 28 juil. 2010
    Livré le 06 août 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each chargor to the chargee and to all or any of the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details. For details of property charged please refer to form MG01.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC (As Security Agent)
    Transactions
    • 06 août 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 21 sept. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 16 nov. 2007
    Livré le 27 nov. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the chargors to the chargee for the secured finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Ascot house 28 wingrove road fenham,34 and 36 wingrove road newcastle upon tyne t/no's TY221509 and TY52154,bradbury house bradbury house new street braintree t/no ESX647090, cheshire house 22 st mary's road ashton on mersey t/no GM54543 (for details of further properties charged please refer to form 395).
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 27 nov. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 sept. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 28 oct. 2005
    Livré le 03 nov. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All land in england and wales now vested in the chargor, all interests and rights in or relating to land or the proceeds of sale, all plant and machinery, all rental and other income. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee
    Transactions
    • 03 nov. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 sept. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 17 déc. 2003
    Livré le 06 janv. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    30 st james's road tunbridge wells kent t/nos K28024 and K810642. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 06 janv. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 sept. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 17 déc. 2003
    Livré le 06 janv. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 06 janv. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 sept. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 17 déc. 2003
    Livré le 30 déc. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land and buildings 30 st james's road tunbridge wells t/n K28024 by way of fixed charge all plant machinery implements utensils furniture and equipment, the goodwill of any business.
    Personnes ayant droit
    • Investec Bank (UK) Limited
    Transactions
    • 30 déc. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 janv. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 17 janv. 2000
    Livré le 26 janv. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company (formerly known as united care (kent) limited) to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 26 janv. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 janv. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 17 janv. 2000
    Livré le 19 janv. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Firtree nursing home st james's road tunbridge wells kent. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 19 janv. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 nov. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0