FIRTREE CARE LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | FIRTREE CARE LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 02628796 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe FIRTREE CARE LIMITED ?
Adresse du siège social | 6th Floor One London Wall EC2Y 5EB London United Kingdom |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de FIRTREE CARE LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2020 |
Quels sont les derniers dépôts pour FIRTREE CARE LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Cessation de la nomination de Richard Stephen Welch en tant que directeur le 28 févr. 2022 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Paul Ray Womble en tant qu'administrateur le 28 févr. 2022 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2020 | 2 pages | AA | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Richard Stephen Welch le 20 sept. 2021 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré 2 Temple Back East Temple Quay Bristol BS1 6EG | 1 pages | AD03 | ||||||||||
L'adresse d'inspection du registre a été modifiée à 2 Temple Back East Temple Quay Bristol BS1 6EG | 1 pages | AD02 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 6th Floor 125 London Wall London EC2Y 5AS England à 6th Floor One London Wall London EC2Y 5EB le 09 juil. 2021 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Sanne Group Secretaries (Uk) Limited en tant que secrétaire le 30 juin 2021 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 22 mai 2021 avec mises à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2019 | 2 pages | AA | ||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Sanne Group Secretaries (Uk) Limited le 10 août 2020 | 1 pages | CH04 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Asticus Building, 2nd Floor 21 Palmer Street London SW1H 0AD à 6th Floor 125 London Wall London EC2Y 5AS le 17 août 2020 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 22 mai 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2018 | 2 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de Jonathan David Farkas en tant que directeur le 07 juin 2019 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Richard Stephen Welch en tant qu'administrateur le 07 juin 2019 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 22 mai 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2017 | 2 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 22 mai 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2016 | 2 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 22 mai 2017 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de FIRTREE CARE LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOMBLE, Paul Ray | Administrateur | E. John Carpenter Freeway Suite 1400 75062 Irving 545 Texas United States | United States | American | Cfo | 293942010001 | ||||||||
ANGELL, Peter George | Secrétaire | 29 Bowfield Hook RG27 9SA Basingstoke Hampshire | British | 781800001 | ||||||||||
BREW, Godfrey Arthur | Secrétaire | Plum Tree Cottage High Street SN8 3AB Burbage Wiltshire | British | Solicitor | 83362410001 | |||||||||
BREW, Godfrey Arthur | Secrétaire | Plum Tree Cottage High Street SN8 3AB Burbage Wiltshire | British | Solicitor | 83362410001 | |||||||||
DRAKE, John Alwyn | Secrétaire | 10 Cavendish Grove SO23 7HQ Winchester Hampshire | British | Chartered Accountant | 53228410001 | |||||||||
JAMES, Nicholas David | Secrétaire | 74 St Cross Road SO23 9PS Winchester Hampshire | British | 36166630001 | ||||||||||
JAMES, Nicholas David | Secrétaire | 74 St Cross Road SO23 9PS Winchester Hampshire | British | 36166630001 | ||||||||||
POWELL, Elizabeth Mary | Secrétaire | High Pines 15 Pine Ridge Drive Lower Bourne GU10 3JR Farnham Surrey | British | Co-Director | 51277850001 | |||||||||
SCHOFIELD, Nigel Bennett | Secrétaire | Bradbury House 830 The Crescent Colchester Business Park CO4 9YQ Colchester Essex | British | 52338530002 | ||||||||||
LESTER ALDRIDGE (SECRETARIAL) LIMITED | Secrétaire | Russell House Oxford Road BH8 8EX Bournemouth Dorset | 4056160001 | |||||||||||
SANNE GROUP SECRETARIES (UK) LIMITED | Secrétaire | London Wall EC2Y 5AS London 6th Floor, 125 England |
| 175738460001 | ||||||||||
BRIERLEY, David Ian | Administrateur | 63a Belsize Lane NW3 5AU London | England | British | Consultant | 110007540001 | ||||||||
CORMACK, Derek George | Administrateur | Bradbury House 830 The Crescent Colchester Business Park CO4 9YQ Colchester Essex | England | Irish | Accountant | 67400530015 | ||||||||
DIX, Michael John | Administrateur | 26 Kew Green Kew TW9 3BH London | British | Chartered Accountant | 188830010 | |||||||||
DONNELLY, Aelred Lance | Administrateur | 14 Fielders Way East Wellow SO51 6EX Romsey Hampshire | United Kingdom | British | Commercial Mortgage Broker | 20576700001 | ||||||||
FARKAS, Jonathan David | Administrateur | Palmer Street SW1H 0AD London Asticus Building, 2nd Floor 21 | Luxembourg | American | Managing Director | 193539990001 | ||||||||
GRIFFIN, Craig | Administrateur | Halebourne House Halebourne Lane GU24 8SL Chobham Surrey | United Kingdom | British | Property Director | 154122490001 | ||||||||
GUNN, Robert Henry | Administrateur | 2 Grovely Way Crampmoor SO51 9AX Romsey Hampshire | England | British | Nursing Home Operator Company Director | 20397500001 | ||||||||
HILL, Peter Martin | Administrateur | Bradbury House 830 The Crescent Colchester Business Park CO4 9YQ Colchester Essex | England | British | Accountant | 130983750002 | ||||||||
HOLDEN, Brian John | Administrateur | East Lodge Newbury Hill Penton Mewsey SP11 0RW Andover Hampshire | British | Company Director | 895520003 | |||||||||
JAMES, Nicholas David | Administrateur | 74 St Cross Road SO23 9PS Winchester Hampshire | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 36166630001 | ||||||||
JEFFERY, Paul Anthony Keith | Administrateur | Bradbury House 830 The Crescent Colchester Business Park CO4 9YQ Colchester Essex | United Kingdom | British | Accountant | 65609290003 | ||||||||
JEFFREY, Helena | Administrateur | Stable House Cockaynes Farm Cockaynes Lane CO7 8BZ Alresford Essex | British | Company Director | 95101350001 | |||||||||
POWELL, David Martin Cleaton | Administrateur | 15 Pine Ridge Drive Lower Bourne GU10 3JR Farnham Surrey | British | Banker | 10175760002 | |||||||||
SCHOFIELD, Nigel Bennett | Administrateur | Bradbury House 830 The Crescent Colchester Business Park CO4 9YQ Colchester Essex | United Kingdom | British | Solicitor | 148139420001 | ||||||||
SILVER, Lynn Suzette | Administrateur | 25 Barham Avenue WD6 3PW Elstree Hertfordshire | British | Director | 50950260001 | |||||||||
STREIFF, Mathieu Bernard | Administrateur | Pollen House 10 Cork Street W1S 3NP London 2nd Floor | United States | American | Attorney | 200529310001 | ||||||||
WELCH, Richard Stephen | Administrateur | South Flower Street 44th Floor 90071 Los Angeles 515 California United States | United States | American | Company Director | 249076190001 | ||||||||
WHITE, Ian James | Administrateur | Bradbury House 830 The Crescent Colchester Business Park CO4 9YQ Colchester Essex | England | British | Accountant | 133383410003 | ||||||||
LESTER ALDRIDGE (MANAGEMENT) LIMITED | Administrateur | Russell House Oxford Road BH8 8EX Bournemouth | 43643830001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur FIRTREE CARE LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ga Hc Reit Ch Uk Senior Housing Portfolio Limited | 06 avr. 2016 | 21 Palmer Street SW1H 0AD London Asticus Building, 2nd Floor England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
|
FIRTREE CARE LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Créé le 28 juil. 2010 Livré le 06 août 2010 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from each chargor to the chargee and to all or any of the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details. For details of property charged please refer to form MG01. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 16 nov. 2007 Livré le 27 nov. 2007 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the chargors to the chargee for the secured finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Ascot house 28 wingrove road fenham,34 and 36 wingrove road newcastle upon tyne t/no's TY221509 and TY52154,bradbury house bradbury house new street braintree t/no ESX647090, cheshire house 22 st mary's road ashton on mersey t/no GM54543 (for details of further properties charged please refer to form 395). | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 28 oct. 2005 Livré le 03 nov. 2005 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions All land in england and wales now vested in the chargor, all interests and rights in or relating to land or the proceeds of sale, all plant and machinery, all rental and other income. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 17 déc. 2003 Livré le 06 janv. 2004 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions 30 st james's road tunbridge wells kent t/nos K28024 and K810642. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 17 déc. 2003 Livré le 06 janv. 2004 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 17 déc. 2003 Livré le 30 déc. 2003 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions F/H land and buildings 30 st james's road tunbridge wells t/n K28024 by way of fixed charge all plant machinery implements utensils furniture and equipment, the goodwill of any business. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 17 janv. 2000 Livré le 26 janv. 2000 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company (formerly known as united care (kent) limited) to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 17 janv. 2000 Livré le 19 janv. 2000 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Firtree nursing home st james's road tunbridge wells kent. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0