TANDATA SYSTEMS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéTANDATA SYSTEMS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02634022
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de TANDATA SYSTEMS LIMITED ?

    • (7222) /

    Où se situe TANDATA SYSTEMS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Acis House
    168 Cowley Road
    CB4 0DL Cambridge
    Cambridgeshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de TANDATA SYSTEMS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    M.B.H.15 LIMITED31 juil. 199131 juil. 1991

    Quels sont les derniers comptes de TANDATA SYSTEMS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2010

    Quels sont les derniers dépôts pour TANDATA SYSTEMS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation d'office

    1 pagesGAZ2

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2010

    6 pagesAA

    Nomination de Mr Simon Nicholas Davey en tant que secrétaire

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Dharminder Sandhu en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Richard Smith en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Richard Smith en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Nomination de Mr Steven Bruce Gallagher en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr James Frederic Carroll en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    legacy

    3 pagesMG02

    Déclaration annuelle jusqu'au 26 juin 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital27 juil. 2010

    État du capital au 27 juil. 2010

    • Capital: GBP 8,200
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2009

    17 pagesAA

    Statuts

    4 pagesMA

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01

    Résolutions

    Resolutions
    4 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2008

    19 pagesAA

    legacy

    2 pages403a

    legacy

    2 pages403a

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    1 pages353

    legacy

    32 pages395

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    1 pages287

    legacy

    1 pages225

    legacy

    1 pages288b

    Qui sont les dirigeants de TANDATA SYSTEMS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    DAVEY, Simon Nicholas
    Richmond Terrace
    3121 Richmond
    85c
    Victoria
    Australia
    Secrétaire
    Richmond Terrace
    3121 Richmond
    85c
    Victoria
    Australia
    154471840001
    CARROLL, James Frederic
    Passchendaele Street
    3188 Hampton
    7
    Victoria
    Australia
    Administrateur
    Passchendaele Street
    3188 Hampton
    7
    Victoria
    Australia
    AustraliaAustralianDirector112748560001
    GALLAGHER, Steven Bruce
    Canterbury Road
    3206 Middle Park
    28
    Victoria
    Australia
    Administrateur
    Canterbury Road
    3206 Middle Park
    28
    Victoria
    Australia
    AustraliaAustralianDirector273532040001
    BULL, Clifford
    The Boat House
    Braybank Old Mill Lane
    SL6 2BH Bray
    Berkshire
    Secrétaire
    The Boat House
    Braybank Old Mill Lane
    SL6 2BH Bray
    Berkshire
    British30079870003
    MOSES, Maurice
    C/O Alix Partners Ltd
    20 Balderton Street
    W1K 6TL London
    Secrétaire
    C/O Alix Partners Ltd
    20 Balderton Street
    W1K 6TL London
    BritishChartered Accountant127624210001
    SMITH, Richard Alexander Buchan
    13 Crown Lane
    Benson
    OX10 6LP Wallingford
    Oxfordshire
    Secrétaire
    13 Crown Lane
    Benson
    OX10 6LP Wallingford
    Oxfordshire
    BritishAccountant116071430001
    ALLAN, Keith Hugh
    Tudor Gardens
    Machen
    CF83 8PD Caerphilly
    7
    Mid Glamorgan
    United Kingdom
    Administrateur
    Tudor Gardens
    Machen
    CF83 8PD Caerphilly
    7
    Mid Glamorgan
    United Kingdom
    United KingdomBritishManaging Director30079890002
    BAKER, Stephen George
    The Mansion 123 High Street
    Earl Shilton
    LE9 7LR Leicester
    Administrateur
    The Mansion 123 High Street
    Earl Shilton
    LE9 7LR Leicester
    BritishDirector62285830001
    BUCKLEY, Ian
    Wytie House
    Malthouse Close
    B50 4JB Broom
    Warwickshire
    Administrateur
    Wytie House
    Malthouse Close
    B50 4JB Broom
    Warwickshire
    United KingdomBritishManaging Director72966900002
    BULL, Clifford
    The Boat House
    Braybank Old Mill Lane
    SL6 2BH Bray
    Berkshire
    Administrateur
    The Boat House
    Braybank Old Mill Lane
    SL6 2BH Bray
    Berkshire
    United KingdomBritishOperation Director30079870003
    FRIEDLI, Andre
    Clerk Tree Cottage
    90 Winterbourne Road
    RG20 8DR Boxford
    Berkshire
    Administrateur
    Clerk Tree Cottage
    90 Winterbourne Road
    RG20 8DR Boxford
    Berkshire
    SwissProject Director19032660005
    HODGSON, Philip Beverley
    100 Cambrian Road
    Walton Cardiff
    GL20 7RP Tewkesbury
    Gloucestershire
    Administrateur
    100 Cambrian Road
    Walton Cardiff
    GL20 7RP Tewkesbury
    Gloucestershire
    BritishTechnical Director30079880005
    MOSES, Maurice
    C/O Alix Partners Ltd
    20 Balderton Street
    W1K 6TL London
    Administrateur
    C/O Alix Partners Ltd
    20 Balderton Street
    W1K 6TL London
    United KingdomBritishChartered Accountant127624210001
    SANDHU, Dharminder Singh
    37 London Road
    Harston
    CB22 7QQ Cambridge
    Laburnum House
    United Kingdom
    Administrateur
    37 London Road
    Harston
    CB22 7QQ Cambridge
    Laburnum House
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector127274480002
    SMITH, Richard Alexander Buchan
    13 Crown Lane
    Benson
    OX10 6LP Wallingford
    Oxfordshire
    Administrateur
    13 Crown Lane
    Benson
    OX10 6LP Wallingford
    Oxfordshire
    EnglandBritishAccountant116071430001

    TANDATA SYSTEMS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture and guarantee
    Créé le 12 août 2009
    Livré le 18 août 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to any finance party or their assignee or successor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC (Security Agent)
    Transactions
    • 18 août 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 sept. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Guarantee & debenture
    Créé le 03 avr. 2008
    Livré le 23 avr. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each group company to the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Cetp Participations Sarl Sicar and Cetp Co-Investment Sarl Sicar (The Secured Parties)
    Transactions
    • 23 avr. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 sept. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee & debenture
    Créé le 10 nov. 2006
    Livré le 18 nov. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due by any group company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    L/H property at C4 knaves beach business centre loudwater high wycombe buckinghamshire. The l/h property at second floor deanland house cowley road cambridge. The l/h property at unit 5 woodland close clipstone nottinghamshire. For further details of property charged please refer to form 395.. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC Acting as Security Trustee for Itself and Each of the Finance Parties
    Transactions
    • 18 nov. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 sept. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 11 oct. 2005
    Livré le 18 oct. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company or any member(s) of the group to the chargee and the holders from time to time of the loan stock on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Inflexion Managers Limited (The Trustee)
    Transactions
    • 18 oct. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 déc. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Accession deed to a guarantee and debenture
    Créé le 11 oct. 2005
    Livré le 15 oct. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each group company to each finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC Acting as Security Trustee for Itself and for Each of the Finance Parties(The Security Trustee)
    Transactions
    • 15 oct. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 févr. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 26 nov. 1991
    Livré le 09 déc. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 09 déc. 1991Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 oct. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0