RUSSELL QUARRY PRODUCTS (SOUTHERN) LIMITED

RUSSELL QUARRY PRODUCTS (SOUTHERN) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéRUSSELL QUARRY PRODUCTS (SOUTHERN) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02638397
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de RUSSELL QUARRY PRODUCTS (SOUTHERN) LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe RUSSELL QUARRY PRODUCTS (SOUTHERN) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    1020 Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TS Wokingham
    Berkshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de RUSSELL QUARRY PRODUCTS (SOUTHERN) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    ECONOPAVE AGGREGATES LIMITED04 oct. 199104 oct. 1991
    DARLEYCROWN LIMITED15 août 199115 août 1991

    Quels sont les derniers comptes de RUSSELL QUARRY PRODUCTS (SOUTHERN) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2014

    Quels sont les derniers dépôts pour RUSSELL QUARRY PRODUCTS (SOUTHERN) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    5 pages4.71

    Changement d'adresse du siège social de No 1 Dorset Street Southampton Hampshire SO15 2DP à 1020 Eskdale Road Winnersh Wokingham Berkshire RG41 5TS le 08 mai 2017

    2 pagesAD01

    Changement d'adresse du siège social de Cemex House Coldharbour Lane Thorpe Egham Surrey TW20 8TD à No 1 Dorset Street Southampton Hampshire SO15 2DP le 28 sept. 2016

    2 pagesAD01

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    2 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 05 sept. 2016

    LRESSP

    Nomination de Vishal Puri en tant qu'administrateur le 29 juin 2016

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Larry Jose Zea Betancourt en tant que directeur le 29 juin 2016

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 mai 2016 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital06 juin 2016

    État du capital au 06 juin 2016

    • Capital: GBP 385,761
    SH01

    Satisfaction de la charge 1 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 2 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 3 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 4 en totalité

    2 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 5 en totalité

    2 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 6 en totalité

    2 pagesMR04

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2014

    8 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 mai 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital01 juin 2015

    État du capital au 01 juin 2015

    • Capital: GBP 385,761
    SH01

    Nomination de Mr Larry Jose Zea Betancourt en tant qu'administrateur le 23 mars 2015

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Michael Leslie Collins en tant que directeur le 23 mars 2015

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2013

    1 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 mai 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital02 juin 2014

    État du capital au 02 juin 2014

    • Capital: GBP 385,761
    SH01

    État du capital après une attribution d'actions au 11 mars 2014

    • Capital: GBP 385,761
    4 pagesSH01

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution d'attribution de valeurs mobilières

    RES10

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2012

    1 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de RUSSELL QUARRY PRODUCTS (SOUTHERN) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MURRAY, Daphne Margaret
    Coldharbour Lane
    Thorpe
    TW20 8TD Egham
    Cemex House
    Surrey
    Secrétaire
    Coldharbour Lane
    Thorpe
    TW20 8TD Egham
    Cemex House
    Surrey
    British77390020001
    PURI, Vishal
    Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TS Wokingham
    1020
    Berkshire
    Administrateur
    Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TS Wokingham
    1020
    Berkshire
    EnglandBritishSolicitor209516530001
    SMALLEY, Jason Alexander
    Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TS Wokingham
    1020
    Berkshire
    Administrateur
    Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TS Wokingham
    1020
    Berkshire
    EnglandBritishSolicitor163491340001
    CAMERON, Ian George
    8 Eastwood Avenue
    Giffnock
    G46 6LR Glasgow
    Lanarkshire
    Secrétaire
    8 Eastwood Avenue
    Giffnock
    G46 6LR Glasgow
    Lanarkshire
    British1236370002
    COX, Wendy Ann
    19 Perth Road
    PE9 2TX Stamford
    Lincolnshire
    Secrétaire
    19 Perth Road
    PE9 2TX Stamford
    Lincolnshire
    BritishSecretary12803030001
    DAVIDSON, Ronald
    6 Leighton Avenue
    FK15 0EB Dunblane
    Perthshire
    Secrétaire
    6 Leighton Avenue
    FK15 0EB Dunblane
    Perthshire
    BritishCompany Secretary14580001
    RENNIE, Gail
    17 Westerlands Drive
    G77 6YB Glasgow
    Secrétaire
    17 Westerlands Drive
    G77 6YB Glasgow
    BritishFinancial Controller81774170001
    L & A SECRETARIAL LIMITED
    31 Corsham Street
    N1 6DR London
    Secrétaire désigné
    31 Corsham Street
    N1 6DR London
    900001450001
    BELCH, Ross Alexander
    11 13 Kittochside Road
    Clarkston
    G76 9AT Glasgow
    Administrateur
    11 13 Kittochside Road
    Clarkston
    G76 9AT Glasgow
    BritishCompany Director41429090001
    BOTTLE, Stephen
    30 Alban Road
    SG6 2AT Letchworth
    Hertfordshire
    Administrateur
    30 Alban Road
    SG6 2AT Letchworth
    Hertfordshire
    BritishSolicitor70897900001
    COLLINS, Michael Leslie
    Coldharbour Lane
    Thorpe
    TW20 8TD Egham
    Cemex House
    Surrey
    Administrateur
    Coldharbour Lane
    Thorpe
    TW20 8TD Egham
    Cemex House
    Surrey
    EnglandBritishSolicitor70461210001
    DOUGHERTY, Brian Donald
    113 Finlay Rise Fairways
    Milngavie
    G62 6QL Glasgow
    Administrateur
    113 Finlay Rise Fairways
    Milngavie
    G62 6QL Glasgow
    BritishFinance Director62450210001
    GILLARD, Peter Henry
    First Floor Flat
    165 Fentiman Road, Vauxhall
    SW8 1JZ London
    Administrateur
    First Floor Flat
    165 Fentiman Road, Vauxhall
    SW8 1JZ London
    United KingdomBritishSolicitor66091700004
    MCCOLL, Stewart Fraser
    53 Westerlea Drive
    Bridge Of Allan
    FK9 4DQ Stirling
    Stirlingshire
    Administrateur
    53 Westerlea Drive
    Bridge Of Allan
    FK9 4DQ Stirling
    Stirlingshire
    BritishCompany Director14910001
    NICOLSON, Graeme Russell
    6 Otterburn Drive
    Giffnock
    G46 6PZ Glasgow
    Strathclyde
    Administrateur
    6 Otterburn Drive
    Giffnock
    G46 6PZ Glasgow
    Strathclyde
    ScotlandBritishCompany Director32694280001
    ROBINSON, John Anthony
    14 Daws Lea
    HP11 1QF High Wycombe
    Buckinghamshire
    Administrateur
    14 Daws Lea
    HP11 1QF High Wycombe
    Buckinghamshire
    BritishChartered Accountant52745500001
    SMITH, Andrew Michael
    Coldharbour Lane
    Thorpe
    TW20 8TD Egham
    Cemex House
    Surrey
    Administrateur
    Coldharbour Lane
    Thorpe
    TW20 8TD Egham
    Cemex House
    Surrey
    United KingdomBritishSolicitor112697170001
    YORK, David Michael
    42 Swallow Hill
    Thurlby
    PE10 0JB Bourne
    Lincolnshire
    Administrateur
    42 Swallow Hill
    Thurlby
    PE10 0JB Bourne
    Lincolnshire
    BritishDirector3663720001
    ZEA BETANCOURT, Larry Jose
    Cemex House
    Coldharbour Lane Thorpe
    TW20 8TD Egham
    Surrey
    Administrateur
    Cemex House
    Coldharbour Lane Thorpe
    TW20 8TD Egham
    Surrey
    EnglandVenezuelanBusiness Service Organisation Director132043870002
    L & A REGISTRARS LIMITED
    31 Corsham Street
    N1 6DR London
    Administrateur désigné
    31 Corsham Street
    N1 6DR London
    900001440001

    RUSSELL QUARRY PRODUCTS (SOUTHERN) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Charge and assignment
    Créé le 26 juil. 1993
    Livré le 06 août 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    (I) by way of charge all the agreement details of which are set out in the schedule hereto and the benefit of the same and all the premises comprised therein and the company's estate and interest in every conveyance,transfer or lease which may be granted to the company pursuant to the agreement.(by way of assignment all moneys due or owing or from time to time becoming due or owing to the company under or by virtue of the agreement. Schedule an agreement dated 27 february 1992 between the company and sly bros (potatoes) limited relating to the F./h of and the mineral rights in 5.793 acres of land off station road,deeping st.james,lincolnshire.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 06 août 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 mai 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Charge and assignment
    Créé le 26 juil. 1993
    Livré le 06 août 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    (I) by way of charge all the agreement details of which are set out in the schedule hereto and the benefit of the same and all the premises comprised therein and the company's estate and interest in every conveyance,transfer or lease which may be granted to the company pursuant to the agreement.(ii) by way oif assignment all moneys due or owing or from time to time becoming due or owing to the company under or by virtue of the agreement.schedule. An agreement dated 27 february 1992 between the company and sly bros (potatoes) limited relating to the f/h of and the mineral rights 29.949 acres ofland off station road,deeping st james,lincolnshire.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 06 août 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 mai 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Charge and assignment
    Créé le 26 juil. 1993
    Livré le 06 août 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    By way of charge all the agreement details of which are set out in the schedule hereto and the benefit of the same and all the premises comprised therein and the company's estate and interest in every conveyance,transfer or lease which may be granted to the company pursuant to the agreement (ii) by way of assignment all moneys due or owing from time to time becoming due or owing to the company under or by virtue of the agreement. Schedule. And agreement dated 27 february 1992 between the company and sly brothers (potatoes) limited relating to the f/h of and the mineral rights in 7.931 acres ofland off station road,deeping st james,lincolnshire.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 06 août 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 mai 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 04 mai 1992
    Livré le 21 mai 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    6.5 acres of land at deeping st james, lincs as comprised in a transfer dated 30/3/92.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 21 mai 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 mai 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 04 mai 1992
    Livré le 19 mai 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 19 mai 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 mai 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 04 mai 1992
    Livré le 19 mai 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land at deeping st james, lincs. T/no. LL56173.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 19 mai 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 mai 2016Satisfaction d'une charge (MR04)

    RUSSELL QUARRY PRODUCTS (SOUTHERN) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    05 sept. 2016Commencement of winding up
    15 août 2017Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Sean Kenneth Croston
    1 Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    Hampshire
    practitioner
    1 Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    Hampshire

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0