CAPITA LONDON MARKET SERVICES LIMITED

CAPITA LONDON MARKET SERVICES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCAPITA LONDON MARKET SERVICES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02646739
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CAPITA LONDON MARKET SERVICES LIMITED ?

    • Assurance non-vie (65120) / Activités financières et d'assurance

    Où se situe CAPITA LONDON MARKET SERVICES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    61-71 Victoria Street
    London
    SW1H 0XA
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de CAPITA LONDON MARKET SERVICES LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    CAPITA EASTGATE INSURANCE SERVICES LIMITED15 janv. 200115 janv. 2001
    EASTGATE SYNDICATE MANAGEMENT LIMITED30 déc. 199630 déc. 1996
    CITY RUN-OFF LIMITED01 oct. 199101 oct. 1991
    GOLDFLIGHT LIMITED18 sept. 199118 sept. 1991

    Quels sont les derniers comptes de CAPITA LONDON MARKET SERVICES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2013

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour CAPITA LONDON MARKET SERVICES LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour CAPITA LONDON MARKET SERVICES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    4 pagesDS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2013

    7 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 juin 2014 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital25 juil. 2014

    État du capital au 25 juil. 2014

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Nomination de Mrs Francesca Anne Todd en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Richard Shearer en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2012

    17 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 juin 2013 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital25 juil. 2013

    État du capital après une attribution d'actions au 25 juil. 2013

    SH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2011

    12 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 juin 2012 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Richard John Shearer le 01 juil. 2011

    2 pagesCH01

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré

    1 pagesAD03

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2010

    7 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 juin 2011 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de 17 Rochester Row Westminster London SW1P 1QT England

    1 pagesAD02

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré

    1 pagesAD03

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    État du capital au 22 juin 2011

    • Capital: GBP 2
    4 pagesSH19

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2009

    8 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 juin 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Modification des coordonnées du secrétaire Capita Group Secretary Limited le 01 oct. 2009

    1 pagesCH04

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré

    1 pagesAD03

    Qui sont les dirigeants de CAPITA LONDON MARKET SERVICES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    CAPITA GROUP SECRETARY LIMITED
    Rochester Row
    SW1P 1QT London
    17
    United Kingdom
    Secrétaire
    Rochester Row
    SW1P 1QT London
    17
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement2376959
    138426340001
    TODD, Francesca Anne
    Rochester Row
    SW1P 1QT London
    17
    United Kingdom
    Administrateur
    Rochester Row
    SW1P 1QT London
    17
    United Kingdom
    EnglandBritish72249980002
    CAPITA CORPORATE DIRECTOR LIMITED
    Rochester Row
    Westminster
    SW1P 1QT London
    17
    England
    Administrateur
    Rochester Row
    Westminster
    SW1P 1QT London
    17
    England
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement5641516
    129795770003
    BRINTON, David Harry
    7 Dene Lane
    Lower Bourne
    GU10 3PW Farnham
    Surrey
    Secrétaire
    7 Dene Lane
    Lower Bourne
    GU10 3PW Farnham
    Surrey
    British10796560001
    GODDARD, Peter
    Fernmead
    Glebe Road, Fernhurst
    GU27 3EQ Haslemere
    Surrey
    Secrétaire
    Fernmead
    Glebe Road, Fernhurst
    GU27 3EQ Haslemere
    Surrey
    British73067120001
    GRAINGER, Derek Charles
    12 Woodville Road
    EN5 5HA New Barnet
    Hertfordshire
    Secrétaire
    12 Woodville Road
    EN5 5HA New Barnet
    Hertfordshire
    British813700001
    HURST, Gordon Mark
    The Manor House
    Reading Road Padworth Common
    RG7 4QG Reading
    Berkshire
    Secrétaire
    The Manor House
    Reading Road Padworth Common
    RG7 4QG Reading
    Berkshire
    British60918000001
    CAPITA COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    The Registry
    34 Beckenham Road
    BR3 4TU Beckenham
    Kent
    Secrétaire
    The Registry
    34 Beckenham Road
    BR3 4TU Beckenham
    Kent
    102944500001
    EASTGATE INSURANCE SERVICES LIMITED
    Pullman Place
    Great Western Road
    GL1 3EA Gloucester
    Secrétaire
    Pullman Place
    Great Western Road
    GL1 3EA Gloucester
    84326030002
    BAILEY, Stephen Richard Derrick
    Somerville 6 Parkmead
    SW15 5RS London
    Administrateur
    Somerville 6 Parkmead
    SW15 5RS London
    British26241640001
    BARCLAY, Robert Lynam
    9 Woodbury Park Road
    TN4 9NQ Tunbridge Wells
    Kent
    Administrateur
    9 Woodbury Park Road
    TN4 9NQ Tunbridge Wells
    Kent
    United KingdomBritish6831990001
    BARRY, Raymond James
    Wits End 11 Peel Place
    Clayhall
    IG5 0PS Ilford
    Essex
    Administrateur
    Wits End 11 Peel Place
    Clayhall
    IG5 0PS Ilford
    Essex
    British5557380001
    BEDFORD, Nicolas Norman
    Flat 1 Victoria Gardens
    15 Marston Ferry Road
    OX2 7EF Oxford
    Administrateur
    Flat 1 Victoria Gardens
    15 Marston Ferry Road
    OX2 7EF Oxford
    EnglandBritish147404780001
    BRAITHWAITE, Philip Charles
    90 Rosebury Road
    Muswell Hill
    N10 2LA London
    Administrateur
    90 Rosebury Road
    Muswell Hill
    N10 2LA London
    British110004810001
    BRINTON, David Harry
    7 Dene Lane
    Lower Bourne
    GU10 3PW Farnham
    Surrey
    Administrateur
    7 Dene Lane
    Lower Bourne
    GU10 3PW Farnham
    Surrey
    EnglandBritish10796560001
    BRINTON, David Harry
    7 Dene Lane
    Lower Bourne
    GU10 3PW Farnham
    Surrey
    Administrateur
    7 Dene Lane
    Lower Bourne
    GU10 3PW Farnham
    Surrey
    EnglandBritish10796560001
    CARRUTHERS, James Maxwell
    118 East Road
    West Mersea
    CO5 8SA Colchester
    Essex
    Administrateur
    118 East Road
    West Mersea
    CO5 8SA Colchester
    Essex
    EnglandBritish54993740001
    CARTER, Richard Graham
    6 Sherenden Park
    Golden Green
    TN11 0LQ Tonbridge
    Kent
    Administrateur
    6 Sherenden Park
    Golden Green
    TN11 0LQ Tonbridge
    Kent
    British562930001
    GIOIOSA, Kathryn
    16 Central Pond
    GL1 5BY Gloucester
    Gloucestershire
    Administrateur
    16 Central Pond
    GL1 5BY Gloucester
    Gloucestershire
    British88147090001
    GODDARD, Peter
    Fernmead
    Glebe Road, Fernhurst
    GU27 3EQ Haslemere
    Surrey
    Administrateur
    Fernmead
    Glebe Road, Fernhurst
    GU27 3EQ Haslemere
    Surrey
    British73067120001
    GRAY, David Robin
    21 Careys Cottages
    SO42 7TF Brockenhurst
    Hampshire
    Administrateur
    21 Careys Cottages
    SO42 7TF Brockenhurst
    Hampshire
    British88116900001
    GRAY, David Robin
    21 Careys Cottages
    SO42 7TF Brockenhurst
    Hampshire
    Administrateur
    21 Careys Cottages
    SO42 7TF Brockenhurst
    Hampshire
    British88116900001
    GROVE, Peter Ernest
    31 Alderton Hill
    IG10 3JD Loughton
    Essex
    Administrateur
    31 Alderton Hill
    IG10 3JD Loughton
    Essex
    British4807730001
    HEAD III, John C
    67 Riverside Drive
    New York
    FOREIGN Usa
    Administrateur
    67 Riverside Drive
    New York
    FOREIGN Usa
    American38116990001
    HOLDER, Lawrence Albert
    Springate Cottage
    Radleys End
    CM6 3PT Dunmow
    Essex
    Administrateur
    Springate Cottage
    Radleys End
    CM6 3PT Dunmow
    Essex
    British62735620001
    HOLLAND, Richard Francis
    28 Broadway
    SK9 1NB Wilmslow
    Administrateur
    28 Broadway
    SK9 1NB Wilmslow
    EnglandBritish170173810002
    HURST, Gordon Mark
    The Manor House
    Reading Road Padworth Common
    RG7 4QG Reading
    Berkshire
    Administrateur
    The Manor House
    Reading Road Padworth Common
    RG7 4QG Reading
    Berkshire
    British60918000001
    IRBY III, Alton Fernando
    5 Cottesmore Gardens
    W8 5PR London
    Administrateur
    5 Cottesmore Gardens
    W8 5PR London
    American72828910001
    JEWELL, David Raymond
    17 Fitzwalter Road
    CO3 3SY Colchester
    Essex
    Administrateur
    17 Fitzwalter Road
    CO3 3SY Colchester
    Essex
    EnglandBritish15781330001
    KING, John Bryan
    Rochester Row
    SW1P 1QT London
    17-19
    United Kingdom
    Administrateur
    Rochester Row
    SW1P 1QT London
    17-19
    United Kingdom
    EnglandBritish261883440001
    LLOYD-ROBERTS, George Edward
    22 Duncan Terrace
    N1 8BS London
    Administrateur
    22 Duncan Terrace
    N1 8BS London
    EnglandBritish3162860002
    MAXWELL, Malcolm John Henry
    Bracken Lodge
    10 Cole Green
    SG14 2NL Hertford
    Hertfordshire
    Administrateur
    Bracken Lodge
    10 Cole Green
    SG14 2NL Hertford
    Hertfordshire
    British15781360001
    MCCANN, Peter John
    14 Ross Way
    Langdon Hills
    SS16 6LX Basildon
    Essex
    Administrateur
    14 Ross Way
    Langdon Hills
    SS16 6LX Basildon
    Essex
    United KingdomBritish39976250001
    MCCOY, Robin Edward
    14 Brayburne Avenue
    SW4 6AA London
    Administrateur
    14 Brayburne Avenue
    SW4 6AA London
    British51429940001
    MCCOY, Robin Edward
    14 Brayburne Avenue
    SW4 6AA London
    Administrateur
    14 Brayburne Avenue
    SW4 6AA London
    British51429940001

    CAPITA LONDON MARKET SERVICES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Guarantee & debenture
    Créé le 30 nov. 1998
    Livré le 16 déc. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    In favour of national westminster bank PLC as security trustee for the secured parties (as defined) the actual, contingent, present and/or future obligations and liabilities of the company to any of the secured parties under or pursuant to any of the financing documents (as defined) (including this guarantee and debenture) (the "secured obligations")
    Brèves mentions
    By way of legal mortgage all estates or interests in the f/h, l/h and other immovable property described in the schedule below being none; by way of fixed charge all estates in any f/h, l/h and other immovable property as at the date of this debenture, all plant machinery vehicles computers and other office equipment, all book and other debts, the goodwill and uncalled capital; by way of floating charge the undertaking and all its property assets and rights whatsoever and wheresoever present and future.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 16 déc. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 déc. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 26 juin 1996
    Livré le 04 juil. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lombard North Central PLC
    Transactions
    • 04 juil. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 juin 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 06 juin 1996
    Livré le 14 juin 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 14 juin 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 janv. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Rent deposit deed
    Créé le 25 sept. 1992
    Livré le 01 oct. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease of even date or the deed
    Brèves mentions
    The deposit sum of £80,531 and any interest thereon.
    Personnes ayant droit
    • Mase Westpac Limited
    Transactions
    • 01 oct. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 déc. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0