NEWS DATACOM LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | NEWS DATACOM LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 02646785 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe NEWS DATACOM LIMITED ?
| Adresse du siège social | 1 Callaghan Square CF10 5BT Cardiff United Kingdom |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de NEWS DATACOM LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 27 juil. 2019 |
Quels sont les derniers dépôts pour NEWS DATACOM LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 15 nov. 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Evan Barry Sloves le 27 nov. 2019 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 27 juil. 2019 | 5 pages | AA | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 juil. 2018 | 4 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 15 nov. 2018 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de One London Road Staines Middlesex TW18 4EX à 1 Callaghan Square Cardiff CF10 5BT le 11 oct. 2018 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 3 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||
État du capital au 31 août 2018
| 5 pages | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomination de Evan Sloves en tant qu'administrateur le 28 juin 2018 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Ismat Levin en tant que directeur le 09 juin 2018 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 29 juil. 2017 | 4 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 15 nov. 2017 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 4 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 5 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 juil. 2016 | 5 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Mr Sajaid Rashid en tant qu'administrateur le 16 mars 2017 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de David James Sweet en tant que directeur le 16 mars 2017 | 2 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 15 nov. 2016 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 25 juil. 2015 | 4 pages | AA | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de NEWS DATACOM LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RASHID, Sajaid | Administrateur | New Square Bedfont Lakes TW14 8HA Feltham 9 Middlesex England | England | British | 227062400001 | |||||
| SLOVES, Evan Barry | Administrateur | East Tasman Drive 95134 San Jose 300 United States | United States | American | 99784540002 | |||||
| MEDLOCK, Charles Richard Kenneth | Secrétaire | 1 Blackwater View Lower Sandhurst Road Finchampstead RG40 3TF Wokingham Berkshire | British | 23450040004 | ||||||
| ROGERS, Eleanor | Secrétaire | 393 London Road CR4 4BF Mitcham Surrey | British | 141000001 | ||||||
| STEHRENBERGER, Peter Walter | Secrétaire | The Knapp Oak Way RH2 7ES Reigate Surrey | Swiss | 415350001 | ||||||
| WOODWARD, Andrew Paul | Secrétaire | London Road TW18 4EX Staines One Middlesex | British | 100885620001 | ||||||
| BARDEN-STYLIANOU, Stelios Stephen | Administrateur | 47 Carlyle Court Chelsea Harbour SW10 0UQ London | England | British | 125782940001 | |||||
| BARRACLOUGH, Stephen Thomas | Administrateur | Flat 1 Brasenose House 35 Kensington High Street W8 5EB London | British | 32978040002 | ||||||
| BROWN, Steven John | Administrateur | 7 Broadwater Lane Aston SG2 7EN Stevenage Hertfordshire | England | British | 3379480001 | |||||
| CHISHOLM, Samuel Hewlings | Administrateur | Flat 7 21 Hyde Park Square W2 London | New Zealander | 14185520001 | ||||||
| CLARK, Greogory John, Dr | Administrateur | 2142 Century Park Lane CA 90067 Los Angeles California America | American | 45010780001 | ||||||
| FISCHER, August Antonius | Administrateur | 58 Egerton Crescent SW3 2ED London | Swiss | 40347940002 | ||||||
| GERSH, Alexander | Administrateur | London Road TW18 4EX Staines One Middlesex | United Kingdom | British | 174100540001 | |||||
| HONEY, Stanley Kohnen | Administrateur | 827 Lytton Street Palo Alto Ca 94301 America | American | 32567760001 | ||||||
| LEVIN, Ismat | Administrateur | London Road TW18 4EX Staines One Middlesex | England | British | 83241580001 | |||||
| LINFORD, Richard Martin | Administrateur | Four Beeches Beech Close KT11 2EN Cobham Surrey | United Kingdom | British | 77209960001 | |||||
| MEDLOCK, Charles Richard Kenneth | Administrateur | 1 Blackwater View Lower Sandhurst Road Finchampstead RG40 3TF Wokingham Berkshire | British | 23450040004 | ||||||
| NIELSEN, Gorm Ward | Administrateur | London Road TW18 4EX Staines One Middlesex United Kingdom | United Kingdom | British | 169694340001 | |||||
| PELED, Abraham, Dr | Administrateur | 28 Wynnstay Gardens W8 London | United States | 44312940003 | ||||||
| PRICE, Thomas George | Administrateur | The Cottage 25 North Park SL9 8JS Gerrards Cross Buckinghamshire | British | 22878750001 | ||||||
| SISKIND, Arthur Michael | Administrateur | 2 Vine Place Westchester County NY10538 Larchmont Usa | American | 49338320001 | ||||||
| SMITH, Peter Wade | Administrateur | Harwood Mount Spring Lane SL6 6PW Maidenhead Berkshire | Australian | 36065300002 | ||||||
| SWEET, David James | Administrateur | New Square Bedfont Lakes TW14 8HA Feltham 9 Middlesex United Kingdom | United Kingdom | British | 161536210001 | |||||
| WOODWARD, Andrew Paul | Administrateur | London Road TW18 4EX Staines One Middlesex | United Kingdom | British | 100885620001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur NEWS DATACOM LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi-Media Vision Limited | 06 avr. 2016 | London Road TW18 4EX Staines One Middlesex United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
NEWS DATACOM LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Intellectual property security agreement | Créé le 10 mars 2011 Livré le 18 mars 2011 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the borrowers and the other loan parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Right title and interest in all copyrights and copyright licenses, all patents and patent licenses, all trademarks and trademark licenses and all trade secrets and trade secret licenses see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 10 mars 2011 Livré le 18 mars 2011 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the borrowers and the other loan parties to any counterparty that is a secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Intellectual property security agreement | Créé le 28 avr. 2009 Livré le 06 mai 2009 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from any obigor to any priority secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions All its right, title and interest in, to and under all copyrights, all patents and all trademarks see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 06 févr. 2009 Livré le 09 févr. 2009 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from any obligor to any creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 28 janv. 2009 Livré le 30 janv. 2009 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from any obligor to any creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0