EWART PROPERTY HOLDINGS (STAMFORD STREET) LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | EWART PROPERTY HOLDINGS (STAMFORD STREET) LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 02649675 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe EWART PROPERTY HOLDINGS (STAMFORD STREET) LIMITED ?
| Adresse du siège social | c/o TEACHER STERN LLP 31-41 Bedford Row WC1R 4JH London |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de EWART PROPERTY HOLDINGS (STAMFORD STREET) LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 30 juin 2015 |
Quels sont les derniers dépôts pour EWART PROPERTY HOLDINGS (STAMFORD STREET) LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Nicholas Emlyn Peter Reid en tant que directeur le 30 mars 2017 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 27 sept. 2016 avec mises à jour | 6 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 juin 2015 | 5 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de Edmund Charles Mccann en tant que directeur le 28 sept. 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Francis Edward Boyd en tant que directeur le 28 sept. 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 27 sept. 2015 avec liste complète des actionnaires | 7 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessation de la nomination de Brian Snoddon en tant que directeur le 10 juin 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Samuel James Harris en tant que directeur le 10 juin 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes pour une petite entreprise établis au 30 juin 2014 | 10 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 27 sept. 2014 avec liste complète des actionnaires | 9 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une petite entreprise établis au 30 juin 2013 | 10 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 27 sept. 2013 avec liste complète des actionnaires | 9 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
La procédure de radiation d'office a été abandonnée | 1 pages | DISS40 | ||||||||||
Comptes pour une petite entreprise établis au 30 juin 2012 | 9 pages | AA | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office | 1 pages | GAZ1 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 27 sept. 2012 avec liste complète des actionnaires | 9 pages | AR01 | ||||||||||
Période comptable actuelle prolongée du 31 déc. 2011 au 30 juin 2012 | 1 pages | AA01 | ||||||||||
Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2010 | 9 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 27 sept. 2011 avec liste complète des actionnaires | 9 pages | AR01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de * 10 Orange Street Haymarket London WC2H 7DQ* le 17 nov. 2010 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2009 | 8 pages | AA | ||||||||||
legacy | 7 pages | MG01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de EWART PROPERTY HOLDINGS (STAMFORD STREET) LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CREIGHTON, David Andrew | Secrétaire | Malone Park House Malone Park BT9 6NL Belfast | British | 83528100001 | ||||||
| CREIGHTON, David Andrew | Administrateur | Malone Park House Malone Park BT9 6NL Belfast | Northern Ireland | British | 83528100001 | |||||
| KENNY, Timothy, Mr. | Secrétaire | 10 Carrickbrack Heath Sutton IRISH Dublin 13 Ireland | Irish | 113651250001 | ||||||
| PATTISON, Eric | Secrétaire | 10 Oakfern BT36 5FN Newtownabbey County Antrim | British | 64178730001 | ||||||
| PINCUS, Barry Martin | Secrétaire | 19 Willifield Way NW11 7XU London | British | 46444010002 | ||||||
| BOYD, Francis Edward | Administrateur | Rademon Estate 60 Ballynahinch Road BT30 9HS Crossgar County Down | Northern Ireland | Northern Irish | 83528370002 | |||||
| BYRNE, Philip Patrick | Administrateur | 29 Upper Merrion Street Dublin 2 Republic Of Ireland | Irish | 58604950001 | ||||||
| ELLIOTT, Acheson | Administrateur | 57 Craigdarragh Road BT19 1UB Helen's Bay County Down N. Ireland | Northern Ireland | British | 144365710001 | |||||
| HARRIS, Samuel James | Administrateur | 2 The Pines Culcavy Road BT26 6NT Hillsborough County Down Northern Ireland | Northern Ireland | British | 158466790001 | |||||
| KENNY, Timothy, Mr. | Administrateur | 10 Carrickbrack Heath Sutton IRISH Dublin 13 Ireland | Ireland | Irish | 113651250001 | |||||
| KLIMT, Peter Richard | Administrateur | Redington Road NW3 7RS London 54 | United Kingdom | British | 23621230001 | |||||
| MCCANN, Edmund Charles | Administrateur | 9 Deramore Drive BT9 5JQ Belfast Northern Ireland | Northern Ireland | Irish | 144512890001 | |||||
| NAGGAR, Guy Anthony | Administrateur | Avenue Road NW8 6HR London 61 | United Kingdom | Italian | 1496660001 | |||||
| NOLAN, Geraldine | Administrateur | 620 Clonard Road IRISH Crumlin Dublin 12 Ireland | Irish | 83257760001 | ||||||
| REID, Nicholas Emlyn Peter | Administrateur | 32 Rushvale Road BT39 9NN Ballyclare County Antrim | Northern Ireland | British | 75236310001 | |||||
| SMYTH, Noel Martin | Administrateur | Lisieux Hall Murphystown Road IRISH Sandyford Dublin 18 Ireland | Ireland | Irish | 91238420001 | |||||
| SNODDON, Brian | Administrateur | Culcavy Road BT26 6JD Hillsborough 23 County Down United Kingdom | Northern Ireland | British | 143738840001 | |||||
| SNODDON, James Myrvan | Administrateur | 43 Carnreagh BT26 6LJ Hillsborough County Down Northern Ireland | British | 143651570001 | ||||||
| STOUTZKER, Ian Isaac | Administrateur | 33 Wilton Crescent SW1X 8RX London | England | British | 2658490001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur EWART PROPERTY HOLDINGS (STAMFORD STREET) LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brunswick (No 1) Limited | 06 avr. 2016 | Fountain Street BT1 5EB Belfast 51-55 Northern Ireland | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
EWART PROPERTY HOLDINGS (STAMFORD STREET) LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Charge over deposits | Créé le 08 oct. 2010 Livré le 16 oct. 2010 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the mortgagor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions The deposit(s) being any sums deposited in the accounts and any other sum or sums which are from time to time deposited see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Security interest agreement | Créé le 17 nov. 2005 Livré le 30 nov. 2005 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions 27,250,000 units in the unit trust known as bridge end unit trust, and the related rights,. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Charge over deposits | Créé le 18 oct. 2005 Livré le 27 oct. 2005 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions By way of a first fixed charge the deposit. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Mortgage debenture | Créé le 30 juin 2004 Livré le 08 juil. 2004 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 12 mars 2004 Livré le 25 mars 2004 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the finance parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions All that l/h land known as the western section of the island site, hammersmith broadway, hammersmith, london t/no BGL10281, all that f/h land situated at fleet road, fleet in the county of hampshire and known as the hart centre t/nos HP389489, HP315793 and HP320745, and all that f/h land situated at market street and 21 and 23 the market place in newbury in the county of west berkshire and k/a the kennet centre t/no BK235120,. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 03 nov. 2000 Livré le 13 nov. 2000 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from ewart property holdings limited (as borrower) to the chargee pursuant to a loan agreement in the amount of £23,000,000 dated 10TH february 1999 (as amended by a supplementary loan agreement dated 1ST november 1999) and/or any other finance documents (as defined in such loan agreement) | |
Brèves mentions Inclusive of property k/a wakefield house 9-15 stamford street london SE1 t/no;-SGL326607. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 14 avr. 2000 Livré le 27 avr. 2000 | Totalement satisfaite | Montant garanti All present and future obligations and liabilities whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever of (I) the borrower to the lender under the facility letter and the windsor dacility letter and (ii) of the company to the security trustee pursuant to the debenture | |
Brèves mentions Freehold property k/a wakefield house 9-15 stamford street london t/n SGL326607. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Deed of legal charge | Créé le 17 sept. 1992 Livré le 02 oct. 1992 | Totalement satisfaite | Montant garanti £8,400,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge. | |
Brèves mentions The f/h property k/as 9 to 15 (odd) stamford street in the l/b of southwark.t/n sgl 326607.floating charge all the company's property assets and rights whatsoever and wheresoever present and/or future. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0