EWART PROPERTY HOLDINGS (STAMFORD STREET) LIMITED

EWART PROPERTY HOLDINGS (STAMFORD STREET) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéEWART PROPERTY HOLDINGS (STAMFORD STREET) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02649675
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de EWART PROPERTY HOLDINGS (STAMFORD STREET) LIMITED ?

    • Autre location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués (68209) / Activités immobilières

    Où se situe EWART PROPERTY HOLDINGS (STAMFORD STREET) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    c/o TEACHER STERN LLP
    31-41 Bedford Row
    WC1R 4JH London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de EWART PROPERTY HOLDINGS (STAMFORD STREET) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    KINGSHOLME LIMITED27 sept. 199127 sept. 1991

    Quels sont les derniers comptes de EWART PROPERTY HOLDINGS (STAMFORD STREET) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 juin 2015

    Quels sont les derniers dépôts pour EWART PROPERTY HOLDINGS (STAMFORD STREET) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Cessation de la nomination de Nicholas Emlyn Peter Reid en tant que directeur le 30 mars 2017

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 27 sept. 2016 avec mises à jour

    6 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 juin 2015

    5 pagesAA

    Cessation de la nomination de Edmund Charles Mccann en tant que directeur le 28 sept. 2015

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Francis Edward Boyd en tant que directeur le 28 sept. 2015

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 27 sept. 2015 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital29 oct. 2015

    État du capital au 29 oct. 2015

    • Capital: GBP 600
    SH01

    Cessation de la nomination de Brian Snoddon en tant que directeur le 10 juin 2015

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Samuel James Harris en tant que directeur le 10 juin 2015

    1 pagesTM01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 30 juin 2014

    10 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 27 sept. 2014 avec liste complète des actionnaires

    9 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital29 sept. 2014

    État du capital au 29 sept. 2014

    • Capital: GBP 600
    SH01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 30 juin 2013

    10 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 27 sept. 2013 avec liste complète des actionnaires

    9 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital10 oct. 2013

    État du capital au 10 oct. 2013

    • Capital: GBP 600
    SH01

    La procédure de radiation d'office a été abandonnée

    1 pagesDISS40

    Comptes pour une petite entreprise établis au 30 juin 2012

    9 pagesAA

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Déclaration annuelle jusqu'au 27 sept. 2012 avec liste complète des actionnaires

    9 pagesAR01

    Période comptable actuelle prolongée du 31 déc. 2011 au 30 juin 2012

    1 pagesAA01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2010

    9 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 27 sept. 2011 avec liste complète des actionnaires

    9 pagesAR01

    Changement d'adresse du siège social de * 10 Orange Street Haymarket London WC2H 7DQ* le 17 nov. 2010

    1 pagesAD01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2009

    8 pagesAA

    legacy

    7 pagesMG01

    Qui sont les dirigeants de EWART PROPERTY HOLDINGS (STAMFORD STREET) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    CREIGHTON, David Andrew
    Malone Park House
    Malone Park
    BT9 6NL Belfast
    Secrétaire
    Malone Park House
    Malone Park
    BT9 6NL Belfast
    British83528100001
    CREIGHTON, David Andrew
    Malone Park House
    Malone Park
    BT9 6NL Belfast
    Administrateur
    Malone Park House
    Malone Park
    BT9 6NL Belfast
    Northern IrelandBritish83528100001
    KENNY, Timothy, Mr.
    10 Carrickbrack Heath
    Sutton
    IRISH Dublin 13
    Ireland
    Secrétaire
    10 Carrickbrack Heath
    Sutton
    IRISH Dublin 13
    Ireland
    Irish113651250001
    PATTISON, Eric
    10 Oakfern
    BT36 5FN Newtownabbey
    County Antrim
    Secrétaire
    10 Oakfern
    BT36 5FN Newtownabbey
    County Antrim
    British64178730001
    PINCUS, Barry Martin
    19 Willifield Way
    NW11 7XU London
    Secrétaire
    19 Willifield Way
    NW11 7XU London
    British46444010002
    BOYD, Francis Edward
    Rademon Estate
    60 Ballynahinch Road
    BT30 9HS Crossgar
    County Down
    Administrateur
    Rademon Estate
    60 Ballynahinch Road
    BT30 9HS Crossgar
    County Down
    Northern IrelandNorthern Irish83528370002
    BYRNE, Philip Patrick
    29 Upper Merrion Street
    Dublin 2
    Republic Of Ireland
    Administrateur
    29 Upper Merrion Street
    Dublin 2
    Republic Of Ireland
    Irish58604950001
    ELLIOTT, Acheson
    57 Craigdarragh Road
    BT19 1UB Helen's Bay
    County Down
    N. Ireland
    Administrateur
    57 Craigdarragh Road
    BT19 1UB Helen's Bay
    County Down
    N. Ireland
    Northern IrelandBritish144365710001
    HARRIS, Samuel James
    2 The Pines
    Culcavy Road
    BT26 6NT Hillsborough
    County Down
    Northern Ireland
    Administrateur
    2 The Pines
    Culcavy Road
    BT26 6NT Hillsborough
    County Down
    Northern Ireland
    Northern IrelandBritish158466790001
    KENNY, Timothy, Mr.
    10 Carrickbrack Heath
    Sutton
    IRISH Dublin 13
    Ireland
    Administrateur
    10 Carrickbrack Heath
    Sutton
    IRISH Dublin 13
    Ireland
    IrelandIrish113651250001
    KLIMT, Peter Richard
    Redington Road
    NW3 7RS London
    54
    Administrateur
    Redington Road
    NW3 7RS London
    54
    United KingdomBritish23621230001
    MCCANN, Edmund Charles
    9 Deramore Drive
    BT9 5JQ Belfast
    Northern Ireland
    Administrateur
    9 Deramore Drive
    BT9 5JQ Belfast
    Northern Ireland
    Northern IrelandIrish144512890001
    NAGGAR, Guy Anthony
    Avenue Road
    NW8 6HR London
    61
    Administrateur
    Avenue Road
    NW8 6HR London
    61
    United KingdomItalian1496660001
    NOLAN, Geraldine
    620 Clonard Road
    IRISH Crumlin
    Dublin 12
    Ireland
    Administrateur
    620 Clonard Road
    IRISH Crumlin
    Dublin 12
    Ireland
    Irish83257760001
    REID, Nicholas Emlyn Peter
    32 Rushvale Road
    BT39 9NN Ballyclare
    County Antrim
    Administrateur
    32 Rushvale Road
    BT39 9NN Ballyclare
    County Antrim
    Northern IrelandBritish75236310001
    SMYTH, Noel Martin
    Lisieux Hall
    Murphystown Road
    IRISH Sandyford
    Dublin 18
    Ireland
    Administrateur
    Lisieux Hall
    Murphystown Road
    IRISH Sandyford
    Dublin 18
    Ireland
    IrelandIrish91238420001
    SNODDON, Brian
    Culcavy Road
    BT26 6JD Hillsborough
    23
    County Down
    United Kingdom
    Administrateur
    Culcavy Road
    BT26 6JD Hillsborough
    23
    County Down
    United Kingdom
    Northern IrelandBritish143738840001
    SNODDON, James Myrvan
    43 Carnreagh
    BT26 6LJ Hillsborough
    County Down
    Northern Ireland
    Administrateur
    43 Carnreagh
    BT26 6LJ Hillsborough
    County Down
    Northern Ireland
    British143651570001
    STOUTZKER, Ian Isaac
    33 Wilton Crescent
    SW1X 8RX London
    Administrateur
    33 Wilton Crescent
    SW1X 8RX London
    EnglandBritish2658490001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur EWART PROPERTY HOLDINGS (STAMFORD STREET) LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Brunswick (No 1) Limited
    Fountain Street
    BT1 5EB Belfast
    51-55
    Northern Ireland
    06 avr. 2016
    Fountain Street
    BT1 5EB Belfast
    51-55
    Northern Ireland
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementNorthern Ireland
    Autorité légaleCompanies Act Ni
    Lieu d'enregistrementUk
    Numéro d'enregistrementNi429823
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    EWART PROPERTY HOLDINGS (STAMFORD STREET) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Charge over deposits
    Créé le 08 oct. 2010
    Livré le 16 oct. 2010
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the mortgagor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The deposit(s) being any sums deposited in the accounts and any other sum or sums which are from time to time deposited see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Aib Group (UK) PLC (the Bank)
    Transactions
    • 16 oct. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    Security interest agreement
    Créé le 17 nov. 2005
    Livré le 30 nov. 2005
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    27,250,000 units in the unit trust known as bridge end unit trust, and the related rights,. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Aib Group (UK) P.L.C.
    Transactions
    • 30 nov. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    Charge over deposits
    Créé le 18 oct. 2005
    Livré le 27 oct. 2005
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    By way of a first fixed charge the deposit. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Aib Group UK PLC
    Transactions
    • 27 oct. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    Mortgage debenture
    Créé le 30 juin 2004
    Livré le 08 juil. 2004
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Aib Group (UK) PLC
    Transactions
    • 08 juil. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 12 mars 2004
    Livré le 25 mars 2004
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the finance parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All that l/h land known as the western section of the island site, hammersmith broadway, hammersmith, london t/no BGL10281, all that f/h land situated at fleet road, fleet in the county of hampshire and known as the hart centre t/nos HP389489, HP315793 and HP320745, and all that f/h land situated at market street and 21 and 23 the market place in newbury in the county of west berkshire and k/a the kennet centre t/no BK235120,. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Ulster Bank Limited and Ulster Bank Ireland Limited (The Security Trustee)
    Transactions
    • 25 mars 2004Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 03 nov. 2000
    Livré le 13 nov. 2000
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from ewart property holdings limited (as borrower) to the chargee pursuant to a loan agreement in the amount of £23,000,000 dated 10TH february 1999 (as amended by a supplementary loan agreement dated 1ST november 1999) and/or any other finance documents (as defined in such loan agreement)
    Brèves mentions
    Inclusive of property k/a wakefield house 9-15 stamford street london SE1 t/no;-SGL326607. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Dunloe Ewart Finance B.V.
    Transactions
    • 13 nov. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 14 avr. 2000
    Livré le 27 avr. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All present and future obligations and liabilities whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever of (I) the borrower to the lender under the facility letter and the windsor dacility letter and (ii) of the company to the security trustee pursuant to the debenture
    Brèves mentions
    Freehold property k/a wakefield house 9-15 stamford street london t/n SGL326607. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Morgan Stanley Mortgage Servicing Limited (The Security Trustee)
    Transactions
    • 27 avr. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 déc. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of legal charge
    Créé le 17 sept. 1992
    Livré le 02 oct. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £8,400,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge.
    Brèves mentions
    The f/h property k/as 9 to 15 (odd) stamford street in the l/b of southwark.t/n sgl 326607.floating charge all the company's property assets and rights whatsoever and wheresoever present and/or future.
    Personnes ayant droit
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transactions
    • 02 oct. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 avr. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0