02650075 LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la société02650075 LIMITED
    Statut de la sociétéLiquidation
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02650075
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de 02650075 LIMITED ?

    • autres activités d'impression n.c.a. (18129) / Industries manufacturières

    Où se situe 02650075 LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Pearl Assurance House, 319 Ballards Lane
    N12 8LY London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de 02650075 LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    GEMINI PRESS LIMITED25 nov. 199125 nov. 1991
    LEGISTSHELFCO NO.109 LIMITED30 sept. 199130 sept. 1991

    Quels sont les derniers comptes de 02650075 LIMITED ?

    En retardOui
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 janv. 2015
    Date d'échéance des prochains comptes31 oct. 2015
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 janv. 2014

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour 02650075 LIMITED ?

    En retardOui
    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au30 avr. 2017
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation14 mai 2017
    En retardOui

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour 02650075 LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel
    En retardOui

    Quels sont les derniers dépôts pour 02650075 LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Restauration par ordonnance du tribunal - précédemment en liquidation volontaire de créanciers

    3 pagesREST-CVL

    Certificat de changement de nom

    Company name changed shelfco 1234\certificate issued on 14/11/23
    pagesCERTNM

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers

    14 pagesLIQ14

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 14 nov. 2019

    13 pagesLIQ03

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 14 nov. 2018

    11 pagesLIQ03

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 15 nov. 2017

    12 pagesLIQ03

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 15 nov. 2016

    18 pages4.68

    Changement d'adresse du siège social de 2/3 Pavilion Buildings Brighton BN1 1EE England à Pearl Assurance House, 319 Ballards Lane London N12 8LY le 09 déc. 2016

    2 pagesAD01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Avis de cessation d'agir en tant que liquidateur volontaire

    1 pages4.40

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 15 avr. 2016

    18 pages4.68

    Avis au Registre du commerce et des sociétés de l'avis de désistement

    3 pagesF10.2

    Avis au Registre du commerce et des sociétés de l'avis de désistement

    3 pagesF10.2

    Avis au Registre du commerce et des sociétés de l'avis de désistement

    3 pagesF10.2

    Déclaration des affaires avec le formulaire 4.19 attaché

    6 pages4.20

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution extraordinaire pour la liquidation au 16 avr. 2015

    LRESEX

    Changement d'adresse du siège social de 1a Dolphin Way Shoreham by Sea West Sussex BN43 6NZ à 2/3 Pavilion Buildings Brighton BN1 1EE le 28 avr. 2015

    1 pagesAD01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Owen Jones le 01 déc. 2014

    2 pagesCH01

    Comptes annuels établis au 31 janv. 2014

    21 pagesAA

    Comptes consolidés établis au 31 juil. 2013

    27 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 avr. 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital11 août 2014

    État du capital au 11 août 2014

    • Capital: GBP 61,763
    SH01

    Certificat de changement de nom

    Company name changed gemini press LIMITED\certificate issued on 14/05/14
    3 pagesCERTNM
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name14 mai 2014

    Résolution de changement de nom

    RES15
    change-of-name14 mai 2014

    Changement de nom" par résolution

    NM01

    Période comptable précédente raccourcie du 31 juil. 2014 au 31 janv. 2014

    1 pagesAA01

    Qui sont les dirigeants de 02650075 LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    JONES, Owen
    Ballards Lane
    N12 8LY London
    Pearl Assurance House, 319
    Secrétaire
    Ballards Lane
    N12 8LY London
    Pearl Assurance House, 319
    164265960001
    BOYLE, John
    Ballards Lane
    N12 8LY London
    Pearl Assurance House, 319
    Administrateur
    Ballards Lane
    N12 8LY London
    Pearl Assurance House, 319
    ScotlandBritishCompany Director13608470008
    CROPPER, Stephen Andrew
    Ballards Lane
    N12 8LY London
    Pearl Assurance House, 319
    Administrateur
    Ballards Lane
    N12 8LY London
    Pearl Assurance House, 319
    EnglandBritishPrinter38816830004
    GWYNNE, Nicholas
    Ballards Lane
    N12 8LY London
    Pearl Assurance House, 319
    Administrateur
    Ballards Lane
    N12 8LY London
    Pearl Assurance House, 319
    EnglandBritishPrinter68213350003
    JONES, Owen Rhys
    Ballards Lane
    N12 8LY London
    Pearl Assurance House, 319
    Administrateur
    Ballards Lane
    N12 8LY London
    Pearl Assurance House, 319
    EnglandBritishFinance Director173156970002
    TULLEY, Mark Lee
    Ballards Lane
    N12 8LY London
    Pearl Assurance House, 319
    Administrateur
    Ballards Lane
    N12 8LY London
    Pearl Assurance House, 319
    EnglandBritishGroup Sales Director68213410002
    BLACKBURN, Alan Jim
    43 Arlington Avenue
    Goring By Sea
    BN12 4SU Worthing
    West Sussex
    Secrétaire
    43 Arlington Avenue
    Goring By Sea
    BN12 4SU Worthing
    West Sussex
    British15607910001
    HOLMES, Nigel David
    Flat 2
    11 The Martlet
    BN3 6NT Hove
    East Sussex
    Secrétaire
    Flat 2
    11 The Martlet
    BN3 6NT Hove
    East Sussex
    BritishCompany Director24756150004
    LEGIST CORPORATE SERVICES LIMITED
    P O Box 613
    Epworth House 25 City Road
    EC1Y 1BY London
    Secrétaire
    P O Box 613
    Epworth House 25 City Road
    EC1Y 1BY London
    32823060001
    BLACKBURN, Alan Jim
    43 Arlington Avenue
    Goring By Sea
    BN12 4SU Worthing
    West Sussex
    Administrateur
    43 Arlington Avenue
    Goring By Sea
    BN12 4SU Worthing
    West Sussex
    British15607910001
    CURRAN, John Paul
    1a Dolphin Way
    Shoreham By Sea
    BN43 6NZ West Sussex
    Administrateur
    1a Dolphin Way
    Shoreham By Sea
    BN43 6NZ West Sussex
    ScotlandBritishChartered Accountant44316690001
    HOLMES, Nigel David
    Flat 2
    11 The Martlet
    BN3 6NT Hove
    East Sussex
    Administrateur
    Flat 2
    11 The Martlet
    BN3 6NT Hove
    East Sussex
    EnglandBritishCompany Director24756150004
    PATERSON, Ronald George
    3 Orlando Road
    SW4 0LE London
    Administrateur
    3 Orlando Road
    SW4 0LE London
    EnglandBritishSolicitor27681590002
    THOMLINSON, Antony Howard
    7 Portland Road
    W11 4LH London
    Administrateur
    7 Portland Road
    W11 4LH London
    BritishSolicitor33437790001
    WEIR, Derek James
    1a Dolphin Way
    Shoreham By Sea
    BN43 6NZ West Sussex
    Administrateur
    1a Dolphin Way
    Shoreham By Sea
    BN43 6NZ West Sussex
    ScotlandBritishCompany Director83668830001

    02650075 LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 16 août 2013
    Livré le 21 août 2013
    En cours
    Brève description
    A. by way of first fixed charge:. (I) all real property;. (Ii) all licences to enter upon or use land and the benefit of all other agreements relating to land; and. (Iii) the proceeds of sale of all real property;. B. by way of first fixed charge the intellectual property;. "Real property" means all estates and interests in freehold, leasehold and other immovable property (wherever situated) now or in future belonging to the obligor, or in which the obligor has an interest at any time, together with:. (A) all buildings and fixtures (including trade fixtures) and fixed p&m at any time thereon;. (B) all easements, rights and agreements in respect thereof; and. (C) the benefit of all covenants given in respect thereof;. "Intellectual property rights" means:. (I) any patents, trade marks, service marks, designs, business names, copyrights, design rights, moral rights, inventions, confidential information, know-how and other intellectual property rights and interests whether registered or unregistered; and. (Ii) the benefit of all applications and rights to use such assets of the company.. Notification of addition to or amendment of charge.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Centric SPV1 Limited
    Transactions
    • 21 août 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    Chattel mortgage
    Créé le 13 nov. 2012
    Livré le 29 nov. 2012
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Komori lithrone ls 529P (m) 5- colour press serial number 101 5 colour printing press.
    Personnes ayant droit
    • Lombard North Central PLC
    Transactions
    • 29 nov. 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    Charge of deposit
    Créé le 19 oct. 2012
    Livré le 26 oct. 2012
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The deposit of £20,000 and all amounts in the future credited to account number 27091597 with national westminster bank PLC.
    Personnes ayant droit
    • Lombard North Central Public Limited Company
    Transactions
    • 26 oct. 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    Composite guarantee and debentures
    Créé le 27 janv. 2011
    Livré le 29 janv. 2011
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Centric Spv 1 Limited
    Transactions
    • 29 janv. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    Debenture
    Créé le 27 juil. 2008
    Livré le 08 août 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transactions
    • 08 août 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 janv. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    All assets debenture
    Créé le 05 mars 2007
    Livré le 07 mars 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transactions
    • 07 mars 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 janv. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 17 déc. 1998
    Livré le 19 déc. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • G E Capital Commercial Finance Limited
    Transactions
    • 19 déc. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 juil. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 18 déc. 1995
    Livré le 21 déc. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Venture Factors PLC
    Transactions
    • 21 déc. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 mai 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 24 avr. 1995
    Livré le 25 avr. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H-unit 1 stockwell lodge conway street and parking spaces 1 and 2 hove east sussex title no ESX147181 and assigns the goodwill of the business (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 25 avr. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 mai 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed equitable charge
    Créé le 21 mars 1994
    Livré le 22 mars 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of any agreement
    Brèves mentions
    All debts the subject of an agreement for the factoring or discounting of debts between the company and the security holder which fail to vest absolutely in the security holder. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Venture Factors PLC
    Transactions
    • 22 mars 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 mai 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 18 déc. 1992
    Livré le 30 déc. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Venture Factors Limited
    Transactions
    • 30 déc. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 juin 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    02650075 LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    16 avr. 2015Commencement of winding up
    07 avr. 2021Dissolved on
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    David J Buchler
    6 Grosvenor Street
    Mayfair
    W1K 4PZ London
    practitioner
    6 Grosvenor Street
    Mayfair
    W1K 4PZ London
    David Rubin
    Pearl Assurance House
    319 Ballards Lane
    N12 8LY London
    practitioner
    Pearl Assurance House
    319 Ballards Lane
    N12 8LY London
    Jonathan James Beard
    2-3 Pavilion Buildings
    BN1 1EE Brighton
    East Sussex
    practitioner
    2-3 Pavilion Buildings
    BN1 1EE Brighton
    East Sussex
    John Walters
    2-3 Pavilion Buildings
    BN1 1EE Brighton
    East Sussex
    practitioner
    2-3 Pavilion Buildings
    BN1 1EE Brighton
    East Sussex

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0