02650075 LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | 02650075 LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Liquidation |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 02650075 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Oui |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe 02650075 LIMITED ?
Adresse du siège social | Pearl Assurance House, 319 Ballards Lane N12 8LY London |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de 02650075 LIMITED ?
En retard | Oui |
---|---|
Prochains comptes | |
Fin de la prochaine période comptable le | 31 janv. 2015 |
Date d'échéance des prochains comptes | 31 oct. 2015 |
Derniers comptes | |
Derniers comptes arrêtés au | 31 janv. 2014 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour 02650075 LIMITED ?
En retard | Oui |
---|---|
Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 30 avr. 2017 |
Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 14 mai 2017 |
En retard | Oui |
Quel est le statut du dernier bilan annuel pour 02650075 LIMITED ?
Bilan annuel |
|
---|
Quels sont les derniers dépôts pour 02650075 LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Restauration par ordonnance du tribunal - précédemment en liquidation volontaire de créanciers | 3 pages | REST-CVL | ||||||||||||||
Certificat de changement de nom Company name changed shelfco 1234\certificate issued on 14/11/23 | pages | CERTNM | ||||||||||||||
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||||||
Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers | 14 pages | LIQ14 | ||||||||||||||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 14 nov. 2019 | 13 pages | LIQ03 | ||||||||||||||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 14 nov. 2018 | 11 pages | LIQ03 | ||||||||||||||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 15 nov. 2017 | 12 pages | LIQ03 | ||||||||||||||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 15 nov. 2016 | 18 pages | 4.68 | ||||||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 2/3 Pavilion Buildings Brighton BN1 1EE England à Pearl Assurance House, 319 Ballards Lane London N12 8LY le 09 déc. 2016 | 2 pages | AD01 | ||||||||||||||
Nomination d'un liquidateur volontaire | 1 pages | 600 | ||||||||||||||
Avis de cessation d'agir en tant que liquidateur volontaire | 1 pages | 4.40 | ||||||||||||||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 15 avr. 2016 | 18 pages | 4.68 | ||||||||||||||
Avis au Registre du commerce et des sociétés de l'avis de désistement | 3 pages | F10.2 | ||||||||||||||
Avis au Registre du commerce et des sociétés de l'avis de désistement | 3 pages | F10.2 | ||||||||||||||
Avis au Registre du commerce et des sociétés de l'avis de désistement | 3 pages | F10.2 | ||||||||||||||
Déclaration des affaires avec le formulaire 4.19 attaché | 6 pages | 4.20 | ||||||||||||||
Nomination d'un liquidateur volontaire | 1 pages | 600 | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 1a Dolphin Way Shoreham by Sea West Sussex BN43 6NZ à 2/3 Pavilion Buildings Brighton BN1 1EE le 28 avr. 2015 | 1 pages | AD01 | ||||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Owen Jones le 01 déc. 2014 | 2 pages | CH01 | ||||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 janv. 2014 | 21 pages | AA | ||||||||||||||
Comptes consolidés établis au 31 juil. 2013 | 27 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 30 avr. 2014 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Certificat de changement de nom Company name changed gemini press LIMITED\certificate issued on 14/05/14 | 3 pages | CERTNM | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Période comptable précédente raccourcie du 31 juil. 2014 au 31 janv. 2014 | 1 pages | AA01 | ||||||||||||||
Qui sont les dirigeants de 02650075 LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JONES, Owen | Secrétaire | Ballards Lane N12 8LY London Pearl Assurance House, 319 | 164265960001 | |||||||
BOYLE, John | Administrateur | Ballards Lane N12 8LY London Pearl Assurance House, 319 | Scotland | British | Company Director | 13608470008 | ||||
CROPPER, Stephen Andrew | Administrateur | Ballards Lane N12 8LY London Pearl Assurance House, 319 | England | British | Printer | 38816830004 | ||||
GWYNNE, Nicholas | Administrateur | Ballards Lane N12 8LY London Pearl Assurance House, 319 | England | British | Printer | 68213350003 | ||||
JONES, Owen Rhys | Administrateur | Ballards Lane N12 8LY London Pearl Assurance House, 319 | England | British | Finance Director | 173156970002 | ||||
TULLEY, Mark Lee | Administrateur | Ballards Lane N12 8LY London Pearl Assurance House, 319 | England | British | Group Sales Director | 68213410002 | ||||
BLACKBURN, Alan Jim | Secrétaire | 43 Arlington Avenue Goring By Sea BN12 4SU Worthing West Sussex | British | 15607910001 | ||||||
HOLMES, Nigel David | Secrétaire | Flat 2 11 The Martlet BN3 6NT Hove East Sussex | British | Company Director | 24756150004 | |||||
LEGIST CORPORATE SERVICES LIMITED | Secrétaire | P O Box 613 Epworth House 25 City Road EC1Y 1BY London | 32823060001 | |||||||
BLACKBURN, Alan Jim | Administrateur | 43 Arlington Avenue Goring By Sea BN12 4SU Worthing West Sussex | British | 15607910001 | ||||||
CURRAN, John Paul | Administrateur | 1a Dolphin Way Shoreham By Sea BN43 6NZ West Sussex | Scotland | British | Chartered Accountant | 44316690001 | ||||
HOLMES, Nigel David | Administrateur | Flat 2 11 The Martlet BN3 6NT Hove East Sussex | England | British | Company Director | 24756150004 | ||||
PATERSON, Ronald George | Administrateur | 3 Orlando Road SW4 0LE London | England | British | Solicitor | 27681590002 | ||||
THOMLINSON, Antony Howard | Administrateur | 7 Portland Road W11 4LH London | British | Solicitor | 33437790001 | |||||
WEIR, Derek James | Administrateur | 1a Dolphin Way Shoreham By Sea BN43 6NZ West Sussex | Scotland | British | Company Director | 83668830001 |
02650075 LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Créé le 16 août 2013 Livré le 21 août 2013 | En cours | ||
Brève description A. by way of first fixed charge:. (I) all real property;. (Ii) all licences to enter upon or use land and the benefit of all other agreements relating to land; and. (Iii) the proceeds of sale of all real property;. B. by way of first fixed charge the intellectual property;. "Real property" means all estates and interests in freehold, leasehold and other immovable property (wherever situated) now or in future belonging to the obligor, or in which the obligor has an interest at any time, together with:. (A) all buildings and fixtures (including trade fixtures) and fixed p&m at any time thereon;. (B) all easements, rights and agreements in respect thereof; and. (C) the benefit of all covenants given in respect thereof;. "Intellectual property rights" means:. (I) any patents, trade marks, service marks, designs, business names, copyrights, design rights, moral rights, inventions, confidential information, know-how and other intellectual property rights and interests whether registered or unregistered; and. (Ii) the benefit of all applications and rights to use such assets of the company.. Notification of addition to or amendment of charge. La charge flottante couvre tout: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Chattel mortgage | Créé le 13 nov. 2012 Livré le 29 nov. 2012 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Komori lithrone ls 529P (m) 5- colour press serial number 101 5 colour printing press. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Charge of deposit | Créé le 19 oct. 2012 Livré le 26 oct. 2012 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions The deposit of £20,000 and all amounts in the future credited to account number 27091597 with national westminster bank PLC. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Composite guarantee and debentures | Créé le 27 janv. 2011 Livré le 29 janv. 2011 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 27 juil. 2008 Livré le 08 août 2008 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
All assets debenture | Créé le 05 mars 2007 Livré le 07 mars 2007 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 17 déc. 1998 Livré le 19 déc. 1998 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 18 déc. 1995 Livré le 21 déc. 1995 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Mortgage | Créé le 24 avr. 1995 Livré le 25 avr. 1995 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions L/H-unit 1 stockwell lodge conway street and parking spaces 1 and 2 hove east sussex title no ESX147181 and assigns the goodwill of the business (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Fixed equitable charge | Créé le 21 mars 1994 Livré le 22 mars 1994 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of any agreement | |
Brèves mentions All debts the subject of an agreement for the factoring or discounting of debts between the company and the security holder which fail to vest absolutely in the security holder. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 18 déc. 1992 Livré le 30 déc. 1992 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
02650075 LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Creditors voluntary liquidation |
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0