FLEXIMEDIA LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéFLEXIMEDIA LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02654520
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de FLEXIMEDIA LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe FLEXIMEDIA LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Media House
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Hampshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de FLEXIMEDIA LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    PRECIS (1128) LIMITED16 oct. 199116 oct. 1991

    Quels sont les derniers comptes de FLEXIMEDIA LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2014

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour FLEXIMEDIA LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour FLEXIMEDIA LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    État du capital au 10 déc. 2015

    • Capital: GBP 0.10
    4 pagesSH19

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 sept. 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital05 oct. 2015

    État du capital au 05 oct. 2015

    • Capital: GBP 3,430,447.1
    SH01

    legacy

    94 pagesPARENT_ACC

    legacy

    1 pagesAGREEMENT1

    legacy

    3 pagesGUARANTEE1

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 sept. 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital01 oct. 2014

    État du capital au 01 oct. 2014

    • Capital: GBP 3,430,447.1
    SH01

    legacy

    92 pagesPARENT_ACC

    legacy

    1 pagesAGREEMENT1

    legacy

    3 pagesGUARANTEE1

    Cessation de la nomination de Caroline Withers en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Mine Ozkan Hifzi en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Nomination de Robert Dominic Dunn en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Robert Gale en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 sept. 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital09 oct. 2013

    État du capital au 09 oct. 2013

    • Capital: GBP 3,430,447.1
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2012

    4 pagesAA

    legacy

    3 pagesGUARANTEE1

    Modification des coordonnées de l'administrateur Caroline Bernadette Elizabeth Withers le 14 mars 2013

    2 pagesCH01

    Cessation de la nomination de Joanne Tillbrook en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Caroline Bernadette Elizabeth Withers en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Qui sont les dirigeants de FLEXIMEDIA LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    JAMES, Gillian Elizabeth
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    Secrétaire
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    151020850001
    DUNN, Robert Dominic
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    Administrateur
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    EnglandBritish179134020002
    HIFZI, Mine Ozkan
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    Administrateur
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    EnglandBritish182167230001
    BURNS, Clive
    The Cottage
    Lamer Hill Gate Lower Gustard Wood
    AL4 8RX Wheathampstead
    Hertfordshire
    Secrétaire
    The Cottage
    Lamer Hill Gate Lower Gustard Wood
    AL4 8RX Wheathampstead
    Hertfordshire
    British71073800001
    LUARD, Roger David Eckford
    Rookwoods Water Lane
    Oakridge
    GL6 7PN Stroud
    Gloucestershire
    Secrétaire
    Rookwoods Water Lane
    Oakridge
    GL6 7PN Stroud
    Gloucestershire
    British28242190001
    LUIZ, Mark Walter
    165 Cranley Gardens
    N10 3AE London
    Secrétaire
    165 Cranley Gardens
    N10 3AE London
    British37860010002
    TAYLOR, Richard George
    72 Hall Green Lane
    Hutton
    CM13 2QT Brentwood
    Essex
    Secrétaire
    72 Hall Green Lane
    Hutton
    CM13 2QT Brentwood
    Essex
    British47989960001
    OFFICE ORGANIZATION & SERVICES LIMITED
    Level 1 Exchange House
    Primrose Street
    EC2A 2HS London
    Secrétaire
    Level 1 Exchange House
    Primrose Street
    EC2A 2HS London
    2519400001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secrétaire désigné
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    VIRGIN MEDIA SECRETARIES LIMITED
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    Secrétaire
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    101107380002
    BRETT, Stephen Marc
    2092 Hardscrabble Drive
    Boulder
    Colorado
    880303
    Usa
    Administrateur
    2092 Hardscrabble Drive
    Boulder
    Colorado
    880303
    Usa
    American21673650001
    BURDICK, Charles James
    9 Ormonde Place
    SW1W 8HX London
    Administrateur
    9 Ormonde Place
    SW1W 8HX London
    British-American52311710004
    BYNG, Timothy Howard St George, Viscount
    Great Hunts Place
    Owslebury
    SO17 2WL Winchester
    Hampshire
    Administrateur
    Great Hunts Place
    Owslebury
    SO17 2WL Winchester
    Hampshire
    British28242300001
    COOK, Stephen Sands
    24a Redcliffe Square
    SW10 9JY London
    Administrateur
    24a Redcliffe Square
    SW10 9JY London
    British73000530008
    GALE, Robert Charles
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    Administrateur
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    EnglandBritish96956740001
    HARMAN, Phillip Brent
    1 Cartwright Way
    Barnes
    SW13 8HD London
    Administrateur
    1 Cartwright Way
    Barnes
    SW13 8HD London
    New Zealander51102310001
    KOPPEL, Montague
    20 Chapel Street
    SW1X 7BY London
    Administrateur
    20 Chapel Street
    SW1X 7BY London
    British63610140001
    LUARD, Roger David Eckford
    Rookwoods Water Lane
    Oakridge
    GL6 7PN Stroud
    Gloucestershire
    Administrateur
    Rookwoods Water Lane
    Oakridge
    GL6 7PN Stroud
    Gloucestershire
    British28242190001
    LUIZ, Mark Walter
    165 Cranley Gardens
    N10 3AE London
    Administrateur
    165 Cranley Gardens
    N10 3AE London
    British37860010002
    MACKENZIE, Robert Mario
    Great Portland Street
    W1W 5QA London
    160
    London
    United Kingdom
    Administrateur
    Great Portland Street
    W1W 5QA London
    160
    London
    United Kingdom
    United KingdomBritish47785600002
    OPIE, Lisa Moreen
    6 Millfield
    HP4 2PB Berkhamsted
    Hertfordshire
    Administrateur
    6 Millfield
    HP4 2PB Berkhamsted
    Hertfordshire
    United KingdomBritish88563310001
    RAMPTON, Jack Leslie, Sir
    17 The Ridgeway
    TN10 4NQ Tonbridge
    Kent
    Administrateur
    17 The Ridgeway
    TN10 4NQ Tonbridge
    Kent
    British13438080001
    SINGER, Adam Nicholas
    8 Oxhey Road
    Oxhey
    WD1 4QE Watford
    Hertfordshire
    Administrateur
    8 Oxhey Road
    Oxhey
    WD1 4QE Watford
    Hertfordshire
    British35783020005
    SINGER, Adam Nicholas
    10747 East Crestline Circle
    Englewood Arapahoe Colorado 80111
    Usa
    Administrateur
    10747 East Crestline Circle
    Englewood Arapahoe Colorado 80111
    Usa
    British35783020003
    SMITH, Neil Reynolds
    Brettwood
    Green Lane Churt
    GU10 2PA Farnham
    Surrey
    Administrateur
    Brettwood
    Green Lane Churt
    GU10 2PA Farnham
    Surrey
    British79956240002
    TILLBROOK, Joanne Christine
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    Administrateur
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United KingdomBritish164134250001
    TILLBROOK, Joanne Christine
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    Administrateur
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United KingdomBritish164134250001
    TINDALE, Lawrence Victor Dolman
    3 Amyand Park Gardens
    TW1 3HS Twickenham
    Middlesex
    Administrateur
    3 Amyand Park Gardens
    TW1 3HS Twickenham
    Middlesex
    British629850001
    WALL, Malcolm Robert
    The Close
    2 Longfield Drive East Sheen
    SW14 7AU London
    Administrateur
    The Close
    2 Longfield Drive East Sheen
    SW14 7AU London
    EnglandBritish178772080002
    WITHERS, Caroline Bernadette Elizabeth
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    Administrateur
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United KingdomBritish140137570002
    YASSUKOVICH, Stanislas Michael
    37 Eaton Place
    SW1X 8DF London
    Administrateur
    37 Eaton Place
    SW1X 8DF London
    American39995940002
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Administrateur désigné
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001
    VIRGIN MEDIA DIRECTORS LIMITED
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    Administrateur
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    101107430002
    VIRGIN MEDIA SECRETARIES LIMITED
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    Administrateur
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    101107380002

    FLEXIMEDIA LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Composite debenture
    Créé le 29 juin 2010
    Livré le 08 juil. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due to the chargee, all monies due or to become due from the obligors (or any one or more of them) to the senior finance parties (or any one or more of them) and all monies due or to become due from all or any of the obligors to the hedge counterparties (or any one or more of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Deutsche Bank Ag, London Branch
    Transactions
    • 08 juil. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 12 oct. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Confirmation deed
    Créé le 15 avr. 2010
    Livré le 04 mai 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the obligors (or any one or more of them) to the senior finance parties (or any one or more of them) on any account whatosover under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The chargor acknowledges and agrees to the new sfa and the transactions contemplated thereby and confirm all payment and performance obligations contingent or otherwise and undertakings arising under or in connection with its respective agreements, guarantees, pledges and grants of encumbrances under and subject to the terms of the group intercreditor agreement and each security document to which it is party. See image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Deutsche Bank Ag, London Branch
    Transactions
    • 04 mai 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 12 oct. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    A composite debenture
    Créé le 19 janv. 2010
    Livré le 22 janv. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due to the chargee from the obligors (or any one or more of them) to the senior finance parties (or any one or more of them) and from all or any of the obligors to the hedge counterparties (or any one or more of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Deutsche Bank Ag London Branch (The Security Trustee)
    Transactions
    • 22 janv. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 25 mai 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Composite debenture
    Créé le 19 janv. 2010
    Livré le 22 janv. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due to the chargee from the obligors (or any one or more of them) to the senior finance parties (or any one or more of them) and from all or any of the obligors to the hedge counterparties (or any one or more of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Deutsche Bank Ag London Branch (The Security Trustee)
    Transactions
    • 22 janv. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 12 oct. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Composite debenture
    Créé le 10 déc. 2009
    Livré le 17 déc. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the obligors to the hedge counterparties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Deutsche Bank Ag
    Transactions
    • 17 déc. 2009Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 25 mai 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Guarantee & debenture
    Créé le 14 juil. 2004
    Livré le 23 juil. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All rights title benefit and interest in and to a) all indebtedness from s from telewest UK limited, flextech investments (jersey) LTD or any member of the tcn's group b) any interest and other amounts due. A floating charge over all assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Cibc World Markets PLC, in Its Capacity as New Security Trustee for the New Beneficiaries
    Transactions
    • 23 juil. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 janv. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of subordination
    Créé le 14 juil. 2004
    Livré le 23 juil. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The collateral instruments being the finance documents, any guarantees and any other documents or instruments. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Cibc World Markets PLC, in Its Capacity as New Security Trustee for the New Beneficiaries
    Transactions
    • 23 juil. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 janv. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Composite debenture
    Créé le 02 mars 2000
    Livré le 16 mars 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee as security trustee for the beneficiaries (as defined) (in this capacity the "security trustee") under or pursuant to the transaction documents (as defined) on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All stocks shares and securities of any kind whatsoever whether marketable or otherwise. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Toronto-Dominion Bank
    Transactions
    • 16 mars 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 déc. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Composite debenture
    Créé le 27 août 1997
    Livré le 12 sept. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargees under the terms of the transaction documents (as defined in the debenture)
    Brèves mentions
    All the undertaking goodwill property assets and rights of such chargor as specified in the debenture (the "charged assets"). See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Toronto-Dominion Bank(In It's Capacity as Security Trustee for the Beneficiaries)
    Transactions
    • 12 sept. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 déc. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0