L & H DEVELOPMENTS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéL & H DEVELOPMENTS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02662561
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de L & H DEVELOPMENTS LIMITED ?

    • Développement de projets de construction (41100) / Construction

    Où se situe L & H DEVELOPMENTS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de L & H DEVELOPMENTS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    LONDON AND HENLEY LIMITED17 mars 199317 mars 1993
    LONDON AND HENLEY INVESTMENTS LIMITED23 juin 199223 juin 1992
    TARGETRAISE LIMITED13 nov. 199113 nov. 1991

    Quels sont les derniers comptes de L & H DEVELOPMENTS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2018

    Quels sont les derniers dépôts pour L & H DEVELOPMENTS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Satisfaction de la charge 6 en totalité

    4 pagesMR04

    Déclaration de confirmation établie le 13 nov. 2018 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Timothy Andrew Roberts en tant que directeur le 25 avr. 2018

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Sarah Morrell Barzycki en tant que directeur le 30 mars 2018

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Nigel Mark Webb en tant que directeur le 25 avr. 2018

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Charles John Middleton en tant qu'administrateur le 25 avr. 2018

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Bruce Michael James en tant qu'administrateur le 25 avr. 2018

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Jonathan Charles Mcnuff en tant qu'administrateur le 25 avr. 2018

    2 pagesAP01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2018

    4 pagesAA

    Cessation de la nomination de Lucinda Margaret Bell en tant que directeur le 19 janv. 2018

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 13 nov. 2017 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Nigel Mark Webb le 25 mai 2017

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mrs Lucinda Margaret Bell le 25 mai 2017

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mrs Sarah Morrell Barzycki le 25 mai 2017

    2 pagesCH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2017

    3 pagesAA

    Cessation de la nomination de Christopher Michael John Forshaw en tant que directeur le 05 avr. 2017

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Christopher Michael John Forshaw en tant que directeur le 05 avr. 2017

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Christopher Michael John Forshaw en tant que directeur le 05 avr. 2017

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Ndiana Ekpo en tant que secrétaire le 06 déc. 2016

    1 pagesTM02

    Nomination de British Land Company Secretarial Limited en tant que secrétaire le 06 déc. 2016

    2 pagesAP04

    Déclaration de confirmation établie le 13 nov. 2016 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2016

    4 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de L & H DEVELOPMENTS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BRITISH LAND COMPANY SECRETARIAL LIMITED
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Secrétaire
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement8992198
    187856670001
    JAMES, Bruce Michael
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Administrateur
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    EnglandBritish226746900001
    MCNUFF, Jonathan Charles
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    Administrateur
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    United KingdomBritish205624050001
    MIDDLETON, Charles John
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    Administrateur
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    United KingdomBritish79841030002
    BRAINE, Anthony
    21 Woodville Road
    Ealing
    W5 2SE London
    Secrétaire
    21 Woodville Road
    Ealing
    W5 2SE London
    British32809000002
    BURGESS, Graeme
    Bali Hai
    Cudham Lane North
    TN14 7RB Sevenoaks
    Kent
    Secrétaire
    Bali Hai
    Cudham Lane North
    TN14 7RB Sevenoaks
    Kent
    British102349020001
    CADER, Tariq Azad
    19 Brookview Road
    Streatham
    SW16 6UA London
    Secrétaire
    19 Brookview Road
    Streatham
    SW16 6UA London
    British42841550001
    EKPO, Ndiana
    Chislehurst Road
    BR5 1NR Petts Wood
    182
    Kent
    United Kingdom
    Secrétaire
    Chislehurst Road
    BR5 1NR Petts Wood
    182
    Kent
    United Kingdom
    Other138446320001
    KEARTON GEE, Frank Watts
    The Windrush
    Stoke Row Road
    RG9 5JD Peppard Common
    Oxfordshire
    Secrétaire
    The Windrush
    Stoke Row Road
    RG9 5JD Peppard Common
    Oxfordshire
    British16914130001
    SCUDAMORE, Rebecca Jane
    40 Canbury Avenue
    KT2 6JP Kingston Upon Thames
    Surrey
    Secrétaire
    40 Canbury Avenue
    KT2 6JP Kingston Upon Thames
    Surrey
    Other72249480003
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secrétaire désigné
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BARZYCKI, Sarah Morrell
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    Administrateur
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    United KingdomBritish58016770004
    BELL, Lucinda Margaret
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    Administrateur
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    EnglandBritish32809050044
    BOWDEN, Robert Edward
    The Chase
    Ongar Road
    CM15 0DG Kelvedon Hatch
    Essex
    Administrateur
    The Chase
    Ongar Road
    CM15 0DG Kelvedon Hatch
    Essex
    United KingdomBritish152497530001
    CADER, Tariq Azad
    19 Brookview Road
    Streatham
    SW16 6UA London
    Administrateur
    19 Brookview Road
    Streatham
    SW16 6UA London
    British42841550001
    CARTER, Simon Geoffrey
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    Administrateur
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    United KingdomBritish170891060001
    CLARKE, Peter Courtenay
    Oakmeade
    Park Road
    SL2 4PG Stoke Poges
    Berkshire
    Administrateur
    Oakmeade
    Park Road
    SL2 4PG Stoke Poges
    Berkshire
    United KingdomBritish78691990003
    CLARKE, Peter Courtenay
    Langkawi
    2 Ashlea Road
    SL9 8NY Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Langkawi
    2 Ashlea Road
    SL9 8NY Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    British78691990001
    COOK, Kevin William
    Oakcroft Redlands Lane
    Ewshot
    GU10 5AS Farnham
    Surrey
    Administrateur
    Oakcroft Redlands Lane
    Ewshot
    GU10 5AS Farnham
    Surrey
    British16914120001
    ECCLES, Christopher John
    7 Grovenor Road
    Chiswick
    W41 3EJ London
    Administrateur
    7 Grovenor Road
    Chiswick
    W41 3EJ London
    British61037210002
    ECCLES, Christopher John
    Salcombe Regis House
    Salcombe Regis
    EX10 0JH Sidmouth
    Devon
    Administrateur
    Salcombe Regis House
    Salcombe Regis
    EX10 0JH Sidmouth
    Devon
    Great BritainBritish61037210003
    FORSHAW, Christopher Michael John
    44 Kerris Way
    Lower Earley
    RG6 5UW Reading
    Berkshire
    Administrateur
    44 Kerris Way
    Lower Earley
    RG6 5UW Reading
    Berkshire
    EnglandBritish1898090001
    GROSE, Benjamin Toby
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Administrateur
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritish146546000001
    GUNSTON, Michael Ian
    Larchmont
    Hambledon Road, Denmead
    PO7 6HB Waterlooville
    Hampshire
    Administrateur
    Larchmont
    Hambledon Road, Denmead
    PO7 6HB Waterlooville
    Hampshire
    United KingdomBritish3079890002
    HAMILTON, Laura Louise
    5 Park Lodge
    Park Close
    SW1X 7PH London
    Administrateur
    5 Park Lodge
    Park Close
    SW1X 7PH London
    American73545680001
    HESTER, Stephen Alan Michael
    3 Ilchester Place
    W14 8AA London
    Administrateur
    3 Ilchester Place
    W14 8AA London
    British51688320001
    JONES, Andrew Marc
    Hazlewell Road
    Putney
    SW15 6LH London
    2
    Administrateur
    Hazlewell Road
    Putney
    SW15 6LH London
    2
    EnglandBritish82020730004
    KEARTON GEE, Frank Watts
    The Windrush
    Stoke Row Road
    RG9 5JD Peppard Common
    Oxfordshire
    Administrateur
    The Windrush
    Stoke Row Road
    RG9 5JD Peppard Common
    Oxfordshire
    EnglandBritish16914130001
    METLISS, Cyril
    25 Foscote Road
    Hendon
    NW4 3SE London
    Administrateur
    25 Foscote Road
    Hendon
    NW4 3SE London
    British3079600001
    MOORE, Albert Richard Jr
    5 Relton Mews
    SW7 1ET London
    Administrateur
    5 Relton Mews
    SW7 1ET London
    Usa73545620001
    RITBLAT, John, Sir
    The Doric Villa 20 York Terrace East
    Regents Park
    NW1 4PT London
    Administrateur
    The Doric Villa 20 York Terrace East
    Regents Park
    NW1 4PT London
    EnglandBritish41694870001
    RITBLAT, Nicholas Simon Jonathan
    37 Queens Grove
    NW8 6HN London
    Administrateur
    37 Queens Grove
    NW8 6HN London
    United KingdomBritish35758050004
    ROBERTS, Graham Charles
    6a Lower Belgrave Street
    SW1W 0LJ London
    Administrateur
    6a Lower Belgrave Street
    SW1W 0LJ London
    EnglandBritish79807180002
    ROBERTS, Timothy Andrew
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    Administrateur
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    EnglandBritish63986410004
    SMITH, Stephen Paul
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Administrateur
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    EnglandBritish148183670001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur L & H DEVELOPMENTS LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    London And Henley Limited
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    England
    06 avr. 2016
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Company Limited By Shares
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.

    L & H DEVELOPMENTS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 21 déc. 2000
    Livré le 05 janv. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies and liabilities due or to become due from the borrower or the company to the beneficiaries under the finance documents or otherwise on any current or other account whatever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Abbey National Treasury Services PLC (The Security Trustee)
    Transactions
    • 05 janv. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 févr. 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    Floating charge debenture
    Créé le 19 juil. 2000
    Livré le 27 juil. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever and whether or not the chargee shall have been an original party to the relevant transaction
    Brèves mentions
    By way of floating charge all the assets undertaking and property.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 27 juil. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 mars 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 18 déc. 1997
    Livré le 24 déc. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Floating charge over the undertaking and all its property and assets present and future.
    Personnes ayant droit
    • Kleinwort Benson Development Capital Limitedas Security Trustee for the Security Beneficiaries (As Defined Therein)
    Transactions
    • 24 déc. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 sept. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Floating charge
    Créé le 27 juin 1997
    Livré le 16 juil. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 16 juil. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 mars 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 26 juil. 1995
    Livré le 05 août 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever as defined in the deed
    Brèves mentions
    Floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill book debts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Kleinwort Benson Development Capital Limitedies as Defined Therein ("the Security Trustee")(As Security Trustee for the Security Beneficiar
    Transactions
    • 05 août 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    • 05 août 1995Enregistrement d'une charge (395)
    Floating charge
    Créé le 26 juil. 1995
    Livré le 28 juil. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 28 juil. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 déc. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0