FIRST WINDFARM HOLDINGS LIMITED

FIRST WINDFARM HOLDINGS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéFIRST WINDFARM HOLDINGS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02664824
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de FIRST WINDFARM HOLDINGS LIMITED ?

    • Activités des sièges sociaux (70100) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe FIRST WINDFARM HOLDINGS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Alexander House 1 Mandarin Road
    Rainton Bridge Business Park
    DH4 5RA Houghton Le Spring, Sunderland
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de FIRST WINDFARM HOLDINGS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2017

    Quels sont les derniers dépôts pour FIRST WINDFARM HOLDINGS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Restauration par ordonnance du tribunal

    3 pagesAC92

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    1 pagesDS01

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 18 oct. 2019

    • Capital: GBP 1.00
    3 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Company ordinary shares cancelled 03/10/2019
    RES13
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Déclaration de confirmation établie le 15 mai 2019 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2017

    21 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 15 mai 2018 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Notification de Edf Energy Renewables Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 16 mars 2018

    2 pagesPSC02

    Cessation de Edf Energy Renewables Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 16 mars 2018

    1 pagesPSC07

    Nomination de Mr Hassaan Majid en tant qu'administrateur le 01 févr. 2018

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Owen John Henry Forster en tant que directeur le 01 févr. 2018

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Geraldine Marie Roseline Anceau en tant que directeur le 01 févr. 2018

    1 pagesTM01

    Satisfaction de la charge 6 en totalité

    4 pagesMR04

    Modification des détails de Edf Energy Renewables Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 23 nov. 2017

    2 pagesPSC05

    Changement d'adresse du siège social de Alexander House 1 Mandarin Road Rainton Bridge Business Park, Houghton Le Spring Sunderland England DH4 5RA England à Alexander House 1 Mandarin Road Rainton Bridge Business Park Houghton Le Spring, Sunderland England DH4 5RA le 24 nov. 2017

    1 pagesAD01

    Changement d'adresse du siège social de 40 Grosvenor Place London SW1X 7EN à Alexander House 1 Mandarin Road Rainton Bridge Business Park, Houghton Le Spring Sunderland England DH4 5RA le 24 nov. 2017

    1 pagesAD01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2016

    17 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 15 mai 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Qui sont les dirigeants de FIRST WINDFARM HOLDINGS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    LIND, Susan Elizabeth
    1 Mandarin Road
    Rainton Bridge Business Park
    DH4 5RA Houghton Le Spring, Sunderland
    Alexander House
    England
    Secrétaire
    1 Mandarin Road
    Rainton Bridge Business Park
    DH4 5RA Houghton Le Spring, Sunderland
    Alexander House
    England
    195217100001
    HUE, Matthieu Thomas
    1 Mandarin Road
    Rainton Bridge Business Park
    DH4 5RA Houghton Le Spring, Sunderland
    Alexander House
    England
    Administrateur
    1 Mandarin Road
    Rainton Bridge Business Park
    DH4 5RA Houghton Le Spring, Sunderland
    Alexander House
    England
    EnglandFrench183883770001
    MAJID, Hassaan
    1 Mandarin Road
    Rainton Bridge Business Park
    DH4 5RA Houghton Le Spring, Sunderland
    Alexander House
    England
    Administrateur
    1 Mandarin Road
    Rainton Bridge Business Park
    DH4 5RA Houghton Le Spring, Sunderland
    Alexander House
    England
    EnglandBritish227170770002
    COLLINGWOOD, Martin Bernard
    727 Beverley High Road
    HU6 7ER Hull
    North Humberside
    Secrétaire
    727 Beverley High Road
    HU6 7ER Hull
    North Humberside
    British70996440001
    HARDIE III, George William
    6858 Carolyn Crest
    Dallas
    Texas 75214
    Usa
    Secrétaire
    6858 Carolyn Crest
    Dallas
    Texas 75214
    Usa
    American75914880001
    HENDERSON, Robert Raymond
    Grosvenor Place
    SW1X 7EN London
    40
    United Kingdom
    Secrétaire
    Grosvenor Place
    SW1X 7EN London
    40
    United Kingdom
    British65382610001
    JOHNSON, Andrew Robert
    5 Plough Farm Close
    HA4 7GH Ruislip
    Middlesex
    Secrétaire
    5 Plough Farm Close
    HA4 7GH Ruislip
    Middlesex
    British9845710001
    LARSEN, Bruno Kold
    Egernsundvej 1
    Silkeborg
    8600
    Denmark
    Secrétaire
    Egernsundvej 1
    Silkeborg
    8600
    Denmark
    Danish133554920001
    RAMSAY, Andrew Stephen James
    The Manse
    Langford
    GL7 3LW Lechlade
    Gloucestershire
    Secrétaire
    The Manse
    Langford
    GL7 3LW Lechlade
    Gloucestershire
    British76376410001
    SAMPSON, Jeremy Andrew
    10 Rowan Place
    HP6 6UR Amersham
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    10 Rowan Place
    HP6 6UR Amersham
    Buckinghamshire
    British37740260002
    SHEPHERD, Clare Marie Ann
    18 Claremont Road
    Highgate
    N6 5BY London
    Secrétaire
    18 Claremont Road
    Highgate
    N6 5BY London
    British36244350001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secrétaire désigné
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    ANCEAU, Geraldine Marie Roseline
    Grosvenor Place
    Victoria
    SW1X 7EN London
    40
    England
    England
    Administrateur
    Grosvenor Place
    Victoria
    SW1X 7EN London
    40
    England
    England
    FranceFrench220722130001
    ANDRE, Yvon Jean Marie
    9 Rue Des Dardanelles
    Paris 75017
    France
    Administrateur
    9 Rue Des Dardanelles
    Paris 75017
    France
    French109739740001
    BAKER, David Simon George
    Grosvenor Place
    SW1X 7EN London
    40
    Administrateur
    Grosvenor Place
    SW1X 7EN London
    40
    United KingdomBritish197462530001
    CHESTER, Peter Francis, Dr
    Tanglewood
    Pyle Hill Mayford
    GU22 0SR Woking
    Surrey
    Administrateur
    Tanglewood
    Pyle Hill Mayford
    GU22 0SR Woking
    Surrey
    British21707600003
    CLINGENSMITH, Robert Lamont
    5 Morningside
    Plumbland, Aspatria
    CA7 2EY Wigton
    Cumbria
    Administrateur
    5 Morningside
    Plumbland, Aspatria
    CA7 2EY Wigton
    Cumbria
    American54465360002
    CROUZAT, Philippe
    Grosvenor Place
    SW1X 7EN London
    40
    United Kingdom
    Administrateur
    Grosvenor Place
    SW1X 7EN London
    40
    United Kingdom
    FranceFrench127904930002
    EGAL, Christian Dominique Yves Marie
    Grosvenor Place
    SW1X 7EN London
    40
    Administrateur
    Grosvenor Place
    SW1X 7EN London
    40
    FranceFrench199687190001
    EVANS, Thomas John
    Iona Strathallan Close
    Darley Dale
    DE4 2HJ Matlock
    Derbyshire
    Administrateur
    Iona Strathallan Close
    Darley Dale
    DE4 2HJ Matlock
    Derbyshire
    EnglandBritish38384630001
    FORSTER, Owen John Henry
    1 Mandarin Road
    Rainton Bridge Business Park
    DH4 5RA Houghton Le Spring, Sunderland
    Alexander House
    England
    England
    Administrateur
    1 Mandarin Road
    Rainton Bridge Business Park
    DH4 5RA Houghton Le Spring, Sunderland
    Alexander House
    England
    England
    EnglandBritish208859480001
    GACA, John Alexander
    19 Walden Lodge Close
    SN10 5BU Devires
    Wiltshire
    Administrateur
    19 Walden Lodge Close
    SN10 5BU Devires
    Wiltshire
    British34143350001
    GUYLER, Robert
    Grosvenor Place
    SW1X 7EN London
    40
    Administrateur
    Grosvenor Place
    SW1X 7EN London
    40
    ScotlandBritish183996210001
    HARDIE III, George William
    6858 Carolyn Crest
    Dallas
    Texas 75214
    Usa
    Administrateur
    6858 Carolyn Crest
    Dallas
    Texas 75214
    Usa
    American75914880001
    HARRIS, Vincent Richard
    Ashlea Whiteway View
    Stratton
    GL7 2HY Cirencester
    Gloucestershire
    Administrateur
    Ashlea Whiteway View
    Stratton
    GL7 2HY Cirencester
    Gloucestershire
    EnglandBritish22138120001
    JACKSON, Roderick James
    2 One Tree Lane
    HP9 2BU Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Administrateur
    2 One Tree Lane
    HP9 2BU Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British58381220001
    JOHNSON, Andrew Robert
    5 Plough Farm Close
    HA4 7GH Ruislip
    Middlesex
    Administrateur
    5 Plough Farm Close
    HA4 7GH Ruislip
    Middlesex
    United KingdomBritish9845710001
    JUIN, Laurence
    Grosvenor Place
    SW1X 7EN London
    40
    United Kingdom
    Administrateur
    Grosvenor Place
    SW1X 7EN London
    40
    United Kingdom
    FranceFrench153653210001
    KNIGHT, Gordon Malcolm
    Treetops
    38 Hale Road
    HP22 6NF Wendover
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Treetops
    38 Hale Road
    HP22 6NF Wendover
    Buckinghamshire
    British35969440001
    LARSEN, Bruno Kold
    Grosvenor Place
    SW1X 7EN London
    40
    United Kingdom
    Administrateur
    Grosvenor Place
    SW1X 7EN London
    40
    United Kingdom
    DenmarkDanish133554920016
    LINDLEY, David
    Woodfield House
    Farm Lane, Jordans
    HP9 2UP Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Woodfield House
    Farm Lane, Jordans
    HP9 2UP Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British84553070001
    LOPEZ-CACICEDO, Carlos, Dr
    Chaucers
    Ogbourne Maizey
    SN8 1XB Marlborough
    Wiltshire
    Administrateur
    Chaucers
    Ogbourne Maizey
    SN8 1XB Marlborough
    Wiltshire
    Spanish14105600003
    LORD, Richard
    31 Sweetcroft Lane
    UB10 9LE Hillingdon
    Middlesex
    Administrateur
    31 Sweetcroft Lane
    UB10 9LE Hillingdon
    Middlesex
    British32964470001
    MOURATOGLOU, Paris Paraskevas
    64 Boulevard D' Inkermann
    Neuilly Sur Seine
    92200
    France
    Administrateur
    64 Boulevard D' Inkermann
    Neuilly Sur Seine
    92200
    France
    FranceFrench88093180001
    OGLE, Roger Anthony
    Fewster Barn
    Fewster Road
    GL6 0DH Nailsworth
    Gloucestershire
    Administrateur
    Fewster Barn
    Fewster Road
    GL6 0DH Nailsworth
    Gloucestershire
    United KingdomBritish78166840001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur FIRST WINDFARM HOLDINGS LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    1 Mandarin Road
    Rainton Bridge Business Park
    DH4 5RA Houghton Le Spring, Sunderland
    Alexander House
    England
    England
    16 mars 2018
    1 Mandarin Road
    Rainton Bridge Business Park
    DH4 5RA Houghton Le Spring, Sunderland
    Alexander House
    England
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementUnited Kingdom
    Autorité légaleUnited Kingdom
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement06456689
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.
    1 Mandarin Road
    Rainton Bridge Business Park
    DH4 5RA Houghton Le Spring, Sunderland
    Alexander House
    England
    England
    06 avr. 2016
    1 Mandarin Road
    Rainton Bridge Business Park
    DH4 5RA Houghton Le Spring, Sunderland
    Alexander House
    England
    England
    Oui
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementUnited Kingdom
    Autorité légaleCompanies Act
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement06658187
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    FIRST WINDFARM HOLDINGS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 31 mars 2003
    Livré le 02 avr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The assets and undertakings. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Australia and New Zealand Banking Group Limited (As Security Trustee)
    Transactions
    • 02 avr. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 janv. 2014L'ensemble de la propriété ou de l'entreprise a été libéré de la charge (MR05)
    • 14 févr. 2014L'ensemble de la propriété ou de l'entreprise a été libéré de la charge (MR05)
    • 22 déc. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Supplemental deed
    Créé le 21 août 2002
    Livré le 05 sept. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Fortis Bank S.A./N.V.
    Transactions
    • 05 sept. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 avr. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Composite debenture between westbury windfarms limited, cemmaes windfarm limited, cold northcott windfarm limited, llangwyryfon windfarm limited, tregulland windfarm limited, great orton windfarm ii limited, first windfarm holdings limited, (together the "group members") and fortis bank S.A./N.V.
    Créé le 31 oct. 2001
    Livré le 08 nov. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All present and future moneys, obligations and liabilities from time to time due, (whether owed jointly or severally or in any capacity whatsoever of each group member to the chargee), owing or incurred by the company under or pursuant to: (a) the secured documents (b) the guarantees and indemnities given by the company under the debenture, which secure all the obligations under the secured documents and each of the company and the group members; and (c) all other provisions of the debenture (all terms as defined)
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Fortis Bank S.A./N.V. as the Lender and the Account Bank and Its Successorsin Title, Assignees and Transferees
    Transactions
    • 08 nov. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 avr. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Supplemental debenture
    Créé le 23 janv. 2001
    Livré le 24 janv. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies obligations and liabbilities due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to a facility agreement dated 3RD december 1998 a composite guarantee and debenture dated 3RD december 1998 , as amended by the debenture
    Brèves mentions
    The l/h property being llangwyrfron windfarm cemmaes windfarm and great orton windfarm. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Orix Ireland Limited
    Transactions
    • 24 janv. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 déc. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 03 déc. 1998
    Livré le 17 déc. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys, obligations and liabilities from time to time due, owing or incurred by the company to the chargee under or pursuant to: (a) a facility agreement dated 3RD december 1998 and made between westbury windfarms limited (the "borrower") and the lender, as that agreement may from time to time be amended, varied, novated, supplemented or replaced (the "facility agreement"); or (b) the debenture
    Brèves mentions
    First fixed charges over all of the present and future assets of the company of the following types: land, interests in land and fixtures, plant, machinery and equipment, goodwill and uncalled capital; it also creates a first floating charge over all other present and future assets of the company.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Orix Ireland Limited (The "Lender")on Behalf of Itself and the Banks from Time to Time Parties to the Facility Agreement
    Transactions
    • 17 déc. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 déc. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 28 févr. 1992
    Livré le 13 mars 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due from the company to any bank secured creditors (as defined in the deed) on any account whatsoever under the terms of any of the finance documents (as defined in the deed)
    Brèves mentions
    (For full details see form 395 tc ref: M44). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 13 mars 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 avr. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0