MICHAEL RICHARD HOMES LIMITED

MICHAEL RICHARD HOMES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéMICHAEL RICHARD HOMES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02665115
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de MICHAEL RICHARD HOMES LIMITED ?

    • (7011) /

    Où se situe MICHAEL RICHARD HOMES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    St Johns Court
    Wiltell Road
    WS14 9DS Lichfield
    Staffordshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de MICHAEL RICHARD HOMES LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    TOWERVERSE LIMITED22 nov. 199122 nov. 1991

    Quels sont les derniers comptes de MICHAEL RICHARD HOMES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2004

    Quels sont les derniers dépôts pour MICHAEL RICHARD HOMES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Avis de compte final avant dissolution

    1 pages4.43

    Résumé des recettes et paiements du récepteur jusqu'au 04 août 2010

    2 pages3.6

    legacy

    2 pagesLQ02

    Résumé des recettes et paiements du récepteur jusqu'au 27 oct. 2009

    2 pages3.6

    Résumé des recettes et paiements du récepteur jusqu'au 27 oct. 2008

    5 pages3.6

    Résumé des recettes et paiements du récepteur

    2 pages3.6

    Résumé des recettes et paiements du récepteur

    2 pages3.6

    legacy

    1 pages287

    Nomination d'un liquidateur

    1 pages4.31

    Ordonnance du tribunal pour liquider

    2 pagesCOCOMP

    Ordonnance du tribunal pour liquider

    2 pagesCOCOMP

    Rapport du séquestre administratif

    12 pages3.10

    legacy

    1 pages287

    legacy

    1 pages405(1)

    legacy

    3 pages395

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 mars 2004

    6 pagesAA

    legacy

    3 pages395

    legacy

    8 pages363s

    legacy

    pages363(288)

    legacy

    7 pages363s

    legacy

    1 pages287

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 mars 2003

    6 pagesAA

    legacy

    3 pages395

    legacy

    2 pages288a

    Qui sont les dirigeants de MICHAEL RICHARD HOMES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    CLEVELEY, Karen
    75 Tiddington Road
    CV37 7AF Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Secrétaire
    75 Tiddington Road
    CV37 7AF Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    BritishDirector116431080001
    CLEVELEY, Karen
    75 Tiddington Road
    CV37 7AF Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Administrateur
    75 Tiddington Road
    CV37 7AF Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    United KingdomBritishDirector116431080001
    CLEVELEY, Michael Richard
    75 Tiddington Road
    CV37 7AF Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Administrateur
    75 Tiddington Road
    CV37 7AF Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Great BritainBritishDirector116430680001
    DAUNCEY, Andrew John
    4 The Farriers
    High Street Broom
    B50 4GZ Alcester
    Warwickshire
    Administrateur
    4 The Farriers
    High Street Broom
    B50 4GZ Alcester
    Warwickshire
    United KingdomBritishBuild Director193205220001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secrétaire désigné
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    FLOWER, Terry Victor
    30 Apsley Grove
    Dorridge
    B93 8QP Solihull
    West Midlands
    Administrateur
    30 Apsley Grove
    Dorridge
    B93 8QP Solihull
    West Midlands
    United KingdomBritishDeveloper75464950001
    GREEN, Michael Lewis
    52 Moorfield Drive
    B63 3TQ Halesowen
    West Midlands
    Administrateur
    52 Moorfield Drive
    B63 3TQ Halesowen
    West Midlands
    BritishQuantity Surveyor14559930001
    PRICE, Stewart James
    The Willows Dogkennel Lane
    B63 3DB Halesowen
    West Midlands
    Administrateur
    The Willows Dogkennel Lane
    B63 3DB Halesowen
    West Midlands
    BritishDirector12626590001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Administrateur désigné
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    MICHAEL RICHARD HOMES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Mortgage
    Créé le 09 août 2005
    Livré le 13 août 2005
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The property k/a land on the north side of limbrick close, shirley t/no WM854170.
    Personnes ayant droit
    • Ghl Developments Limited
    Transactions
    • 13 août 2005Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 24 nov. 2004
    Livré le 02 déc. 2004
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land at limbrick close solihull t/n WM840151,. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 02 déc. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    Charge over cash deposit
    Créé le 17 nov. 2003
    Livré le 19 nov. 2003
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The account number 50004760-4 at the bank.
    Personnes ayant droit
    • Heritable Bank Limited
    Transactions
    • 19 nov. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    Rent deposit deed
    Créé le 29 sept. 2003
    Livré le 04 oct. 2003
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The sum from time to time in a deposit account opened by project office furniture limited with national westminster bank PLC being an initial sum of £11,205.00. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Project Office Furniture Limited
    Transactions
    • 04 oct. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    Security assignment
    Créé le 20 sept. 2002
    Livré le 25 sept. 2002
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The contract dated 28/6/2002 relating to land at the builders yard,leamington rd,willersey,gloucestershire.
    Personnes ayant droit
    • Norman Mundy Footwear Limited
    Transactions
    • 25 sept. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    Floating charge
    Créé le 28 juin 2002
    Livré le 12 juil. 2002
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All the undertaking goodwill assets rights revenues and property of the company whatsoever and wheresoever both present and future including all tangible and intangible assets and its uncalled capital for the time being and any land or buildings and any interest of the company therein and any futher property asset or right mentioned. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Heritable Bank Limited
    Transactions
    • 12 juil. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    Security assignment
    Créé le 28 juin 2002
    Livré le 12 juil. 2002
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The full benefit right title and interest of the assignor in a contract dated 28 june 2002 and all rights and remedies of the assignor under or pursuant to the terms of the contract.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Heritable Bank Limited
    Transactions
    • 12 juil. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    Mortgage
    Créé le 15 janv. 1999
    Livré le 03 févr. 1999
    En cours
    Montant garanti
    £100,000 due from the company to the chargee on the security of this deed and pursuant to a facility letter dated 12TH january 1999 and any document supplemental to it
    Brèves mentions
    F/H land k/a barford garage wellesbourne road barford warwickshire.
    Personnes ayant droit
    • Roger Malcolm Holbeche
    • Jonathan Lavy
    Transactions
    • 03 févr. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 15 janv. 1999
    Livré le 25 janv. 1999
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land k/a barford garage wellesbourne road warwickshire including all buildings and erections and all fixtures and fittings and all rents and other income derived from the property. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Heritable and General Investment Bank Limited
    Transactions
    • 25 janv. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 14 oct. 1996
    Livré le 22 oct. 1996
    En cours
    Montant garanti
    £48,000 and all other monies due or to become due from the compay to the chargee
    Brèves mentions
    F/H land adjoining 1 woodlea drive solihull and land to the rear of 94,96, 98 and 100 sharmans cross road part of t/n's WM334153, WM433911, WM593314 nad WM319540 and f/h land being part of 100 sharmans cross road solihull.
    Personnes ayant droit
    • Margaret Evelyn Tullah
    Transactions
    • 22 oct. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    Floating charge
    Créé le 14 oct. 1996
    Livré le 23 oct. 1996
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Floating charge and goodwill. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Heritable and General Investment Bank Limited
    Transactions
    • 23 oct. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 14 oct. 1996
    Livré le 23 oct. 1996
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land being part of the land adjoining 1 woodlea drive solihull and land to the rear of 94, 96, 98 and 100 sharmans cross road each parcel respectively forming part of a larger piece or parcel of land under t/n's WM334153 WM433911 and wm 319540 and all that f/h land being part of 100 sharmans cross road solihull including all buildings and erections thereon and all fixtures fittings therein and all rents and other income derived from the property. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Heritable and General Investment Bank Limited
    Transactions
    • 23 oct. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 09 juil. 1996
    Livré le 18 juil. 1996
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    By way of legal mortgage land at the rear of 162/164 sandy hill road, shirley, solihull. And the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 18 juil. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 12 sept. 1994
    Livré le 14 sept. 1994
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brèves mentions
    F/H-land being part of lodge road knowle solihull west midlands. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 14 sept. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 14 juil. 1994
    Livré le 20 juil. 1994
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 20 juil. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 nov. 2005Nomination d'un administrateur ou d'un gestionnaire (405 (1))
    • 111 août 2010Avis de cessation d'exercer en tant qu'administrateur ou gestionnaire (LQ02)
      • Numéro de dossier 1

    MICHAEL RICHARD HOMES LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    14 juil. 1994Instrument date
    Administrative receiver appointed
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Allan Watson Graham
    One Snowhill Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    practitioner
    One Snowhill Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Andrew Stephen Mcgill
    Kpmg Llp
    2 Cornwall Street
    B3 2DL Birmingham
    practitioner
    Kpmg Llp
    2 Cornwall Street
    B3 2DL Birmingham
    2
    DateType
    31 mai 2011Conclusion of winding up
    21 oct. 2005Petition date
    30 janv. 2006Commencement of winding up
    08 sept. 2011Dissolved on
    Compulsory liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    The Official Receiver Or Birmingham
    3rd Floor East
    Ladywood House
    B2 4UP 45-46 Stephenson Street
    Birmingham
    practitioner
    3rd Floor East
    Ladywood House
    B2 4UP 45-46 Stephenson Street
    Birmingham
    The Official Receiver Or London
    21 Bloomsbury Street
    London
    WC1B 3SS
    practitioner
    21 Bloomsbury Street
    London
    WC1B 3SS
    Martin Frederick Peter Smith
    Dains
    St Johns Court
    WS14 9DS Wiltell Road
    Lichfield Staffs
    practitioner
    Dains
    St Johns Court
    WS14 9DS Wiltell Road
    Lichfield Staffs

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0