THE EASTERN AFRICA ASSOCIATION
Vue d'ensemble
| Nom de la société | THE EASTERN AFRICA ASSOCIATION |
|---|---|
| Statut de la société | Active |
| Forme juridique | Société privée à responsabilité limitée par garantie sans capital social, exemption d'utilisation de 'Limited' |
| Numéro de société | 02666005 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe THE EASTERN AFRICA ASSOCIATION ?
| Adresse du siège social | Harlow Enterprise Hub Kao Hockham Building Edinburgh Way CM20 2NQ Harlow Essex |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de THE EASTERN AFRICA ASSOCIATION ?
| En retard | Non |
|---|---|
| Prochains comptes | |
| Fin de la prochaine période comptable le | 31 déc. 2025 |
| Date d'échéance des prochains comptes | 30 sept. 2026 |
| Derniers comptes | |
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2024 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour THE EASTERN AFRICA ASSOCIATION ?
| Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 09 juin 2026 |
|---|---|
| Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 23 juin 2026 |
| Dernière déclaration de confirmation | |
| Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 09 juin 2025 |
| En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour THE EASTERN AFRICA ASSOCIATION ?
| Date | Description | Document | Type | |
|---|---|---|---|---|
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Praveen Moman le 07 nov. 2025 | 2 pages | CH01 | ||
Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2024 | 13 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 09 juin 2025 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2023 | 13 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 09 juin 2024 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Cessation de la nomination de Mansukhlal Radia en tant que directeur le 25 sept. 2023 | 1 pages | TM01 | ||
Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2022 | 13 pages | AA | ||
Cessation de la nomination de Jeffrey Russell James en tant que directeur le 29 juin 2023 | 1 pages | TM01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 09 juin 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Cessation de la nomination de Patrick Cecil Rowley Orr en tant que directeur le 13 janv. 2023 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Afshin Ghassmi en tant que directeur le 31 oct. 2022 | 1 pages | TM01 | ||
Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2021 | 13 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 09 juin 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2020 | 16 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 09 juin 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Nomination de Mr William Tobias Latta en tant qu'administrateur le 01 mars 2021 | 2 pages | AP01 | ||
Nomination de Mr Jeremy John Elton Lefroy en tant qu'administrateur le 19 déc. 2020 | 2 pages | AP01 | ||
Nomination de Ms Agnes Wanjiku Gitau en tant qu'administrateur le 16 nov. 2020 | 2 pages | AP01 | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Sir Henry Campbell Bellingham le 12 nov. 2020 | 2 pages | CH01 | ||
Notification d'une déclaration relative à une personne disposant d'un contrôle significatif | 2 pages | PSC08 | ||
Cessation de la nomination de John Charles Small en tant que directeur le 14 juil. 2020 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de John Charles Small en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 14 juil. 2020 | 1 pages | PSC07 | ||
Nomination de Mr John Paul Wise Fone en tant que secrétaire le 19 août 2020 | 2 pages | AP03 | ||
Cessation de la nomination de John Charles Small en tant que secrétaire le 14 juil. 2020 | 1 pages | TM02 | ||
Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2019 | 20 pages | AA | ||
Qui sont les dirigeants de THE EASTERN AFRICA ASSOCIATION ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FONE, John Paul Wise | Secrétaire | Kao Hockham Building Edinburgh Way CM20 2NQ Harlow Harlow Enterprise Hub Essex | 273289990001 | |||||||
| BELLINGHAM, Henry Campbell, Lord | Administrateur | Parliament Square SW1A 0AA London House Of Lords England | England | British | 55041780002 | |||||
| CECIL, Valentine, Lord | Administrateur | Gunter Grove SW10 0UJ London 38 | United Kingdom | British | 98394010002 | |||||
| GITAU, Agnes Wanjiku | Administrateur | Paul Street EC2 4NE London 86-90 England | England | British,Kenyan | 192475510001 | |||||
| GREENE, David Michael | Administrateur | 51 Colebrooke Row N1 8AF London | United Kingdom | United Kingdom | 64269560001 | |||||
| GRIFFITHS, Frank | Administrateur | Waterside Drive PO19 8RN Chichester Cherry Tree Cottage West Sussex | United Kingdom | British | 139207100001 | |||||
| LATTA, William Tobias | Administrateur | Vespan Road W12 9QG London 63 England | England | British | 280303050001 | |||||
| LEFROY, Jeremy John Elton | Administrateur | Highway Lane Keele ST5 5AN Newcastle 9 England | United Kingdom | British | 69461880001 | |||||
| MOMAN, Praveen | Administrateur | Cadogan Square SW1X 0DY London 75 England | United Kingdom | British | 69084890003 | |||||
| SHAH, Kamal Rasiklal Dhanraj | Administrateur | Finsbury Circus EC2M 7SH London Stephenson Harwood Llp England | England | British | 165869730001 | |||||
| BUCKMASTER, Christopher Meredith | Secrétaire | 23 Kensington Place W8 7PT London | British | 39758440002 | ||||||
| SMALL, John Charles | Secrétaire | 12 Penshurst CM17 0BP Harlow Essex | British | 66580220001 | ||||||
| WOOD, John Alan | Secrétaire | Hilden,King Street Odiham RG29 1NJ Hook Hampshire | British | 59690720001 | ||||||
| BECKWITH, John Daniel Stewart | Administrateur | Coolham Road Coneyhurst RH14 9DH Billingshurst Bramley Lodge West Sussex | British | 41642410001 | ||||||
| BIRD, Robert Anthony | Administrateur | Salmons Farm Salmons Lane Coggeshall CO6 1RY Colchester Essex | British | 77906340001 | ||||||
| BOWDEN, Lorna | Administrateur | 84b College Road BR1 3PE Bromley Kent | British | 41838200001 | ||||||
| BRADY, Stephen William | Administrateur | 15 Geralds Grove SM7 1NE Banstead Surrey | England | British | 98394120001 | |||||
| BRAZIER, Philip Lionel | Administrateur | The Elms Aspenden SG9 9PG Buntingford Hertfordshire | British | 9058260001 | ||||||
| BRODIE, Gordon | Administrateur | 53 Queens Road SL4 3BQ Windsor Berkshire | British | 51140120001 | ||||||
| BULLOCK, Gareth Richard | Administrateur | 47 Kingston Lane TW11 9HN Teddington Middlesex | United Kingdom | British | 86839910001 | |||||
| CAROE, Peter Richard | Administrateur | 15 Lisgar Terrace W14 8SJ London | United Kingdom | British | 60645040002 | |||||
| CARTER, David | Administrateur | The Old Chapel Hempton OX15 0QS Banbury Oxfordshire | United Kingdom | British | 62696360002 | |||||
| COUCHMAN, Avril Jeanette | Administrateur | Dalhanna Cockerhurst Road, Shoreham TN14 7UA Sevenoaks Kent | British | 80373950001 | ||||||
| DAVIDSON, Timothy Alexander | Administrateur | Summerfield Cottage Dummer RG25 2AX Basingstoke Hampshire | British | 41036730001 | ||||||
| DAVIES, Michael Grant | Administrateur | Flat 7 77 Clapham Common South Side SW4 9DG London | British | 122592310001 | ||||||
| ECKHART, Klaus Andrew | Administrateur | Wedgwood Blacksmith Lane Chilworth GU4 8NF Guildford Surrey | United Kingdom | British | 9801940001 | |||||
| ECKHART, Klaus Andrew | Administrateur | Wedgwood Blacksmith Lane Chilworth GU4 8NF Guildford Surrey | United Kingdom | British | 9801940001 | |||||
| ESCOTT, Richard Anthony Graham | Administrateur | Tranters 27 St Albans Road RH2 9LL Reigate Surrey | United Kingdom | British | 11314040001 | |||||
| FAIRBURN, Richard Arthur | Administrateur | Swallowfield, Coxs Drove Fulbourn CB1 5HE Cambridge Cambridgeshire | British | 62250940002 | ||||||
| FERGUSON, Cornelie Annis | Administrateur | Tottenham Road N1 4EA London 99 England | United Kingdom | British | 142673670001 | |||||
| FERGUSON, Iain George Thomas | Administrateur | Summerfield House Mill Lane CB1 6JY Linton Cambridge | British | 33220580001 | ||||||
| FLETCHER, Daniel Paul | Administrateur | High Hollow Icehouse Wood RH8 9DW Oxted Surrey | British | 141388010001 | ||||||
| FONE, John Paul Wise | Administrateur | Swyffehurst Burwash Road Broad Oak TN21 8UP Heathfield East Susex | United Kingdom | British | 29538120002 | |||||
| FOY, Christopher | Administrateur | 8 Park Close Ilchester Place W14 8ND London | United Kingdom | British | 56240430001 | |||||
| GARDNER, Charles Amphlett | Administrateur | 4 Mitchmere Stoughton PO18 9JW Chichester West Sussex | United Kingdom | British | 77352260002 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur THE EASTERN AFRICA ASSOCIATION ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé |
|---|---|---|---|
| Mr John Charles Small | 06 avr. 2016 | Kao Hockham Building Edinburgh Way CM20 2NQ Harlow Harlow Enterprise Hub Essex | Oui |
Nationalité: British Pays de résidence: England | |||
Nature du contrôle
| |||
Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour THE EASTERN AFRICA ASSOCIATION ?
| Notifié le | Cessé le | Déclaration |
|---|---|---|
| 03 sept. 2020 | La société sait ou a des raisons de croire qu'aucune personne enregistrable ou entité juridique pertinente enregistrable n'est liée à la société. |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0