P GROUP LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | P GROUP LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 02666018 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Oui |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe P GROUP LIMITED ?
Adresse du siège social | 1 Bridgewater Place Water Lane LS11 5QR Leeds |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de P GROUP LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 oct. 2016 |
Quels sont les derniers dépôts pour P GROUP LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||||||
Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres | 13 pages | LIQ13 | ||||||||||||||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 09 août 2019 | 10 pages | LIQ03 | ||||||||||||||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 09 août 2018 | 10 pages | LIQ03 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Craig Parsons en tant que directeur le 01 sept. 2017 | 2 pages | TM01 | ||||||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Marrons Solicitors 1 Meridian South Meridian Business Park Leicester Leicestershire LE19 1WY à 1 Bridgewater Place Water Lane Leeds LS11 5QR le 11 sept. 2017 | 2 pages | AD01 | ||||||||||||||
L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de Park Mill Wakefield Road Clayton West Huddersfield HD8 9QQ England à Adair Sec Limited 1 Meridian South Meridian Business Park Leicester Leicestershire LE19 1WY | 2 pages | AD02 | ||||||||||||||
Nomination d'un liquidateur volontaire | 1 pages | 600 | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Déclaration de solvabilité | 5 pages | LIQ01 | ||||||||||||||
Satisfaction de la charge 026660180009 en totalité | 4 pages | MR04 | ||||||||||||||
Satisfaction de la charge 026660180008 en totalité | 4 pages | MR04 | ||||||||||||||
Satisfaction de la charge 026660180007 en totalité | 4 pages | MR04 | ||||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 oct. 2016 | 16 pages | AA | ||||||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||||||
État du capital au 21 juin 2017
| 3 pages | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 26 nov. 2016 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||||||
Démission de l'auditeur | 1 pages | AUD | ||||||||||||||
Démission de l'auditeur | 1 pages | AUD | ||||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 oct. 2015 | 12 pages | AA | ||||||||||||||
Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré Park Mill Wakefield Road Clayton West Huddersfield HD8 9QQ | 1 pages | AD03 | ||||||||||||||
L'adresse d'inspection du registre a été modifiée à Park Mill Wakefield Road Clayton West Huddersfield HD8 9QQ | 1 pages | AD02 | ||||||||||||||
Inscription de la charge 026660180009, créée le 27 avr. 2016 | 54 pages | MR01 | ||||||||||||||
Qui sont les dirigeants de P GROUP LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARRONS CONSULTANCIES LIMITED | Secrétaire | Meridian South Meridian Business Park LE19 1WY Leicester 1 Leicestershire United Kingdom |
| 65475060002 | ||||||||||
WHITESIDE, Robert | Administrateur | 23 Millbeck Green LS22 5AJ Collingham West Yorkshire | United Kingdom | British | Company Director | 81547240001 | ||||||||
KINN, Jeffrey Martin | Secrétaire | 9 Alderwood Way SS7 1QJ Hadleigh Essex | British | 31000380002 | ||||||||||
LYNCH, Peter Eugene | Secrétaire | 45 Holmwood, Brennastown Road IRISH Dublin 18 Republic Of Ireland | Irish | Accountant | 96288470001 | |||||||||
BOOKER, John Albert | Administrateur | Ivy House 43 Church Street Buckden PE18 9TP Huntingdon Cambridgeshire | British | Director | 5944410001 | |||||||||
CARSON, Edward | Administrateur | Wantz Road Wantz Road CM4 0EP Margaretting Essex Beech Lorne | United Kingdom | British | Company Director | 136498460001 | ||||||||
COLL, James Joseph | Administrateur | 7 Elkwood Rathfarmham 16 Dublin Ireland | Irish | Company Director | 51120160001 | |||||||||
CREAN, Patrick James | Administrateur | The Beeches Enniskerry Demense Enniskerry County Wicklow Eire | Ireland | Irish | Accountant | 54812330001 | ||||||||
EVERARD, Clinton Edwin | Administrateur | Ballymoss Thursley Road Elstead GU8 6EB Godalming Surrey | England | British | Finance Director | 99667360001 | ||||||||
HERBERT, Kevin Arthur | Administrateur | Southfield Close Rufforth YO23 3RE York 28 | England | British | Accountant | 167011610001 | ||||||||
KINN, Jeffrey Martin | Administrateur | Nine Oaks 5 Woodlands Park SS9 3TX Leigh On Sea Essex | British | Company Director | 31000380004 | |||||||||
LOANE, Beaufort Nelson | Administrateur | 1 Rathdown Crescent IRISH Terenure Dublin 6 Ireland | Irish | Accountant | 78428900001 | |||||||||
LYNCH, Peter Eugene | Administrateur | 45 Holmwood, Brennastown Road IRISH Dublin 18 Republic Of Ireland | Ireland | Irish | Accountant | 96288470001 | ||||||||
MOTTERSHEAD, Derek Stuart | Administrateur | The Cottage 1 Millgate Gilling West DL10 5JQ Richmond North Yorkshire | British | Company Director | 36334680001 | |||||||||
O TIGHEARNAIGH, Cormac | Administrateur | 56 Hillside IRISH Dalkey County Dublin Ireland | Irish | Accountant | 84690240001 | |||||||||
PARSONS, Craig | Administrateur | Wakefield Road Clayton West HD8 9QQ Huddersfield Park Mill England | England | British | Chief Financial Officer | 181017920001 | ||||||||
RAWORTH, Richard | Administrateur | 7 St Georges Road St Margarets TW1 1QS Twickenham Middlesex | United Kingdom | British | Company Director | 1506920001 | ||||||||
SMITH, David Richard Peart | Administrateur | Ashford Cottage Steep GU32 1AB Petersfield Hants | British | Company Director | 32883530002 | |||||||||
SPENCE, Michael Allan | Administrateur | Redlands Merrybent DL2 2LB Darlington County Durham | British | Company Director | 59228100001 | |||||||||
STREET, Geoffrey Graham | Administrateur | 9 Fulwith Mill Lane HG2 8HJ Harrogate North Yorkshire | England | British | Company Director | 70418720001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur P GROUP LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adare Group Limited | 26 nov. 2016 | 1 Meridian South Meridian Business Park LE19 1WY Leicester Shakespeare Martineau England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
|
P GROUP LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Créé le 27 avr. 2016 Livré le 27 avr. 2016 | Totalement satisfaite | ||
Brève description Not applicable. La charge flottante couvre tout: Oui Contient une promesse négative: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
A registered charge | Créé le 10 avr. 2015 Livré le 14 avr. 2015 | Totalement satisfaite | ||
Brève description Property detailed in schedule 3 of the instrument, including freehold land and buildings on the west side of falconer road, haverhill - title number SK141185. For more information please refer to schedule 3 of the instrument. La charge flottante couvre tout: Oui Contient une promesse négative: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
A registered charge | Créé le 03 oct. 2014 Livré le 07 oct. 2014 | Totalement satisfaite | ||
La charge flottante couvre tout: Oui Contient une promesse négative: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 30 mars 2012 Livré le 03 avr. 2012 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the obligors to the security beneficiaries (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 24 mars 2006 Livré le 12 avr. 2006 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due by the obligors to the security beneficiaries (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Deed of accession to a composite guarantee and debenture dated 14 july 2000 | Créé le 30 août 2000 Livré le 08 sept. 2000 | Totalement satisfaite | Montant garanti All present and future obligations and liabilities whatsoever due or to become due from each charging company (as defined) to the chargee and the security beneficiaries (as defined) under the banking documents, the mezzanine loan agreement and/or the senior note documents (all as defined) | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 23 juin 1997 Livré le 27 juin 1997 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Fixed and floating charge | Créé le 29 nov. 1995 Livré le 07 déc. 1995 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 27 août 1992 Livré le 17 sept. 1992 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions For full details see form 395 m/3/L. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
P GROUP LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Members voluntary liquidation |
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0