P GROUP LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéP GROUP LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02666018
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de P GROUP LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe P GROUP LIMITED ?

    Adresse du siège social
    1 Bridgewater Place
    Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de P GROUP LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    PRONTAPRINT GROUP LIMITED07 déc. 199207 déc. 1992
    PRONTAPRINT (1992) PLC23 mars 199223 mars 1992
    JAYBYTE PLC26 nov. 199126 nov. 1991

    Quels sont les derniers comptes de P GROUP LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 oct. 2016

    Quels sont les derniers dépôts pour P GROUP LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    13 pagesLIQ13

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 09 août 2019

    10 pagesLIQ03

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 09 août 2018

    10 pagesLIQ03

    Cessation de la nomination de Craig Parsons en tant que directeur le 01 sept. 2017

    2 pagesTM01

    Changement d'adresse du siège social de Marrons Solicitors 1 Meridian South Meridian Business Park Leicester Leicestershire LE19 1WY à 1 Bridgewater Place Water Lane Leeds LS11 5QR le 11 sept. 2017

    2 pagesAD01

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de Park Mill Wakefield Road Clayton West Huddersfield HD8 9QQ England à Adair Sec Limited 1 Meridian South Meridian Business Park Leicester Leicestershire LE19 1WY

    2 pagesAD02

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 10 août 2017

    LRESSP

    Déclaration de solvabilité

    5 pagesLIQ01

    Satisfaction de la charge 026660180009 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 026660180008 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 026660180007 en totalité

    4 pagesMR04

    Comptes annuels établis au 31 oct. 2016

    16 pagesAA

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 21 juin 2017

    • Capital: GBP 1
    3 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Reduction of share premium account 20/06/2017
    RES13
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Déclaration de confirmation établie le 26 nov. 2016 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Démission de l'auditeur

    1 pagesAUD

    Démission de l'auditeur

    1 pagesAUD

    Comptes annuels établis au 31 oct. 2015

    12 pagesAA

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré Park Mill Wakefield Road Clayton West Huddersfield HD8 9QQ

    1 pagesAD03

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée à Park Mill Wakefield Road Clayton West Huddersfield HD8 9QQ

    1 pagesAD02

    Inscription de la charge 026660180009, créée le 27 avr. 2016

    54 pagesMR01

    Qui sont les dirigeants de P GROUP LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MARRONS CONSULTANCIES LIMITED
    Meridian South
    Meridian Business Park
    LE19 1WY Leicester
    1
    Leicestershire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Meridian South
    Meridian Business Park
    LE19 1WY Leicester
    1
    Leicestershire
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement01708508
    65475060002
    WHITESIDE, Robert
    23 Millbeck Green
    LS22 5AJ Collingham
    West Yorkshire
    Administrateur
    23 Millbeck Green
    LS22 5AJ Collingham
    West Yorkshire
    United KingdomBritishCompany Director81547240001
    KINN, Jeffrey Martin
    9 Alderwood Way
    SS7 1QJ Hadleigh
    Essex
    Secrétaire
    9 Alderwood Way
    SS7 1QJ Hadleigh
    Essex
    British31000380002
    LYNCH, Peter Eugene
    45 Holmwood,
    Brennastown Road
    IRISH Dublin 18
    Republic Of Ireland
    Secrétaire
    45 Holmwood,
    Brennastown Road
    IRISH Dublin 18
    Republic Of Ireland
    IrishAccountant96288470001
    BOOKER, John Albert
    Ivy House 43 Church Street
    Buckden
    PE18 9TP Huntingdon
    Cambridgeshire
    Administrateur
    Ivy House 43 Church Street
    Buckden
    PE18 9TP Huntingdon
    Cambridgeshire
    BritishDirector5944410001
    CARSON, Edward
    Wantz Road
    Wantz Road
    CM4 0EP Margaretting Essex
    Beech Lorne
    Administrateur
    Wantz Road
    Wantz Road
    CM4 0EP Margaretting Essex
    Beech Lorne
    United KingdomBritishCompany Director136498460001
    COLL, James Joseph
    7 Elkwood
    Rathfarmham
    16 Dublin
    Ireland
    Administrateur
    7 Elkwood
    Rathfarmham
    16 Dublin
    Ireland
    IrishCompany Director51120160001
    CREAN, Patrick James
    The Beeches Enniskerry Demense
    Enniskerry
    County Wicklow Eire
    Administrateur
    The Beeches Enniskerry Demense
    Enniskerry
    County Wicklow Eire
    IrelandIrishAccountant54812330001
    EVERARD, Clinton Edwin
    Ballymoss
    Thursley Road Elstead
    GU8 6EB Godalming
    Surrey
    Administrateur
    Ballymoss
    Thursley Road Elstead
    GU8 6EB Godalming
    Surrey
    EnglandBritishFinance Director99667360001
    HERBERT, Kevin Arthur
    Southfield Close
    Rufforth
    YO23 3RE York
    28
    Administrateur
    Southfield Close
    Rufforth
    YO23 3RE York
    28
    EnglandBritishAccountant167011610001
    KINN, Jeffrey Martin
    Nine Oaks 5 Woodlands Park
    SS9 3TX Leigh On Sea
    Essex
    Administrateur
    Nine Oaks 5 Woodlands Park
    SS9 3TX Leigh On Sea
    Essex
    BritishCompany Director31000380004
    LOANE, Beaufort Nelson
    1 Rathdown Crescent
    IRISH Terenure
    Dublin 6
    Ireland
    Administrateur
    1 Rathdown Crescent
    IRISH Terenure
    Dublin 6
    Ireland
    IrishAccountant78428900001
    LYNCH, Peter Eugene
    45 Holmwood,
    Brennastown Road
    IRISH Dublin 18
    Republic Of Ireland
    Administrateur
    45 Holmwood,
    Brennastown Road
    IRISH Dublin 18
    Republic Of Ireland
    IrelandIrishAccountant96288470001
    MOTTERSHEAD, Derek Stuart
    The Cottage 1 Millgate
    Gilling West
    DL10 5JQ Richmond
    North Yorkshire
    Administrateur
    The Cottage 1 Millgate
    Gilling West
    DL10 5JQ Richmond
    North Yorkshire
    BritishCompany Director36334680001
    O TIGHEARNAIGH, Cormac
    56 Hillside
    IRISH Dalkey
    County Dublin
    Ireland
    Administrateur
    56 Hillside
    IRISH Dalkey
    County Dublin
    Ireland
    IrishAccountant84690240001
    PARSONS, Craig
    Wakefield Road
    Clayton West
    HD8 9QQ Huddersfield
    Park Mill
    England
    Administrateur
    Wakefield Road
    Clayton West
    HD8 9QQ Huddersfield
    Park Mill
    England
    EnglandBritishChief Financial Officer181017920001
    RAWORTH, Richard
    7 St Georges Road
    St Margarets
    TW1 1QS Twickenham
    Middlesex
    Administrateur
    7 St Georges Road
    St Margarets
    TW1 1QS Twickenham
    Middlesex
    United KingdomBritishCompany Director1506920001
    SMITH, David Richard Peart
    Ashford Cottage
    Steep
    GU32 1AB Petersfield
    Hants
    Administrateur
    Ashford Cottage
    Steep
    GU32 1AB Petersfield
    Hants
    BritishCompany Director32883530002
    SPENCE, Michael Allan
    Redlands
    Merrybent
    DL2 2LB Darlington
    County Durham
    Administrateur
    Redlands
    Merrybent
    DL2 2LB Darlington
    County Durham
    BritishCompany Director59228100001
    STREET, Geoffrey Graham
    9 Fulwith Mill Lane
    HG2 8HJ Harrogate
    North Yorkshire
    Administrateur
    9 Fulwith Mill Lane
    HG2 8HJ Harrogate
    North Yorkshire
    EnglandBritishCompany Director70418720001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur P GROUP LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    1 Meridian South
    Meridian Business Park
    LE19 1WY Leicester
    Shakespeare Martineau
    England
    26 nov. 2016
    1 Meridian South
    Meridian Business Park
    LE19 1WY Leicester
    Shakespeare Martineau
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementUk
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement02387953
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    P GROUP LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 27 avr. 2016
    Livré le 27 avr. 2016
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Not applicable.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC as Security Trustee for the Secured Parties
    Transactions
    • 27 avr. 2016Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 30 août 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 10 avr. 2015
    Livré le 14 avr. 2015
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Property detailed in schedule 3 of the instrument, including freehold land and buildings on the west side of falconer road, haverhill - title number SK141185. For more information please refer to schedule 3 of the instrument.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Endless LLP
    Transactions
    • 14 avr. 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 30 août 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 03 oct. 2014
    Livré le 07 oct. 2014
    Totalement satisfaite
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 07 oct. 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 30 août 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 30 mars 2012
    Livré le 03 avr. 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the obligors to the security beneficiaries (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 03 avr. 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 07 oct. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 24 mars 2006
    Livré le 12 avr. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due by the obligors to the security beneficiaries (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The "Security Trustee")
    Transactions
    • 12 avr. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 oct. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Deed of accession to a composite guarantee and debenture dated 14 july 2000
    Créé le 30 août 2000
    Livré le 08 sept. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All present and future obligations and liabilities whatsoever due or to become due from each charging company (as defined) to the chargee and the security beneficiaries (as defined) under the banking documents, the mezzanine loan agreement and/or the senior note documents (all as defined)
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland, as Security Trustee for the Securitybeneficiaries
    Transactions
    • 08 sept. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 juin 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 23 juin 1997
    Livré le 27 juin 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Allied Irish Banks Plcas Security Trustee for the Beneficiaries (As Defined)
    Transactions
    • 27 juin 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 mai 2003Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 16 juil. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed and floating charge
    Créé le 29 nov. 1995
    Livré le 07 déc. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 07 déc. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 sept. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 27 août 1992
    Livré le 17 sept. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    For full details see form 395 m/3/L. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Samuel Montagu & Co. Limitedas Agent and Trustee for Itself and for Each Other Finance Party (As Defined)
    Transactions
    • 17 sept. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 janv. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    P GROUP LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    10 août 2017Commencement of winding up
    24 janv. 2020Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Derek Hyslop
    1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    West Yorkshire
    practitioner
    1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    West Yorkshire
    Colin Peter Dempster
    1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    West Yorkshire
    practitioner
    1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    West Yorkshire

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0