TIMEULTRA LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéTIMEULTRA LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02666630
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de TIMEULTRA LIMITED ?

    • Autre transport terrestre de voyageurs (49390) / Transports et stockage

    Où se situe TIMEULTRA LIMITED ?

    Adresse du siège social
    C/O Trathens Travel Services Ltd
    Walkham Park
    PL5 3LS Plymouth
    Devon
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de TIMEULTRA LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2013

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour TIMEULTRA LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour TIMEULTRA LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    4 pagesDS01

    Déclaration annuelle jusqu'au 28 nov. 2013 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital11 déc. 2013

    État du capital au 11 déc. 2013

    • Capital: GBP 35,501
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2013

    10 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 28 nov. 2012 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 mars 2012

    6 pagesAA

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2011

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 28 nov. 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Déclaration annuelle jusqu'au 28 nov. 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2010

    13 pagesAA

    Nomination de Mr Ross William Park en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Alexander Stewart Bryce en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Déclaration annuelle jusqu'au 28 nov. 2009 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Ian Barron Mackay le 30 nov. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur William Cumming le 30 nov. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Gerard Donnachie le 30 nov. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Douglas Ireland Park le 30 nov. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Gerard Donnachie le 30 nov. 2009

    1 pagesCH03

    Comptes annuels établis au 31 mars 2009

    12 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    Comptes annuels établis au 31 mars 2008

    13 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    1 pages288b

    Comptes annuels établis au 31 mars 2007

    13 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de TIMEULTRA LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    DONNACHIE, Gerard
    C/O Trathens Travel Services Ltd
    Walkham Park
    PL5 3LS Plymouth
    Devon
    Secrétaire
    C/O Trathens Travel Services Ltd
    Walkham Park
    PL5 3LS Plymouth
    Devon
    British602380003
    BRYCE, Alexander Stewart
    C/O Trathens Travel Services Ltd
    Walkham Park
    PL5 3LS Plymouth
    Devon
    Administrateur
    C/O Trathens Travel Services Ltd
    Walkham Park
    PL5 3LS Plymouth
    Devon
    United KingdomBritish150803460001
    CUMMING, William
    C/O Trathens Travel Services Ltd
    Walkham Park
    PL5 3LS Plymouth
    Devon
    Administrateur
    C/O Trathens Travel Services Ltd
    Walkham Park
    PL5 3LS Plymouth
    Devon
    ScotlandBritish112830750002
    DONNACHIE, Gerard
    C/O Trathens Travel Services Ltd
    Walkham Park
    PL5 3LS Plymouth
    Devon
    Administrateur
    C/O Trathens Travel Services Ltd
    Walkham Park
    PL5 3LS Plymouth
    Devon
    United KingdomBritish602380003
    MACKAY, Ian Barron
    C/O Trathens Travel Services Ltd
    Walkham Park
    PL5 3LS Plymouth
    Devon
    Administrateur
    C/O Trathens Travel Services Ltd
    Walkham Park
    PL5 3LS Plymouth
    Devon
    ScotlandBritish406430001
    PARK, Douglas Ireland
    C/O Trathens Travel Services Ltd
    Walkham Park
    PL5 3LS Plymouth
    Devon
    Administrateur
    C/O Trathens Travel Services Ltd
    Walkham Park
    PL5 3LS Plymouth
    Devon
    GibraltarBritish333600005
    PARK, Ross William
    C/O Trathens Travel Services Ltd
    Walkham Park
    PL5 3LS Plymouth
    Devon
    Administrateur
    C/O Trathens Travel Services Ltd
    Walkham Park
    PL5 3LS Plymouth
    Devon
    ScotlandBritish93072080001
    TRATHEN, David John
    12 Romilly Gardens
    Plympton
    PL7 2FF Plymouth
    Devon
    Secrétaire
    12 Romilly Gardens
    Plympton
    PL7 2FF Plymouth
    Devon
    British1685120001
    TRATHEN, Michael George
    Coombe House Green Lane
    PL20 6BW Yelverton
    Devon
    Secrétaire
    Coombe House Green Lane
    PL20 6BW Yelverton
    Devon
    British48272710001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secrétaire désigné
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BROWN, Steve
    8 Snead View
    ML1 5GL Motherwell
    Lanarkshire
    Administrateur
    8 Snead View
    ML1 5GL Motherwell
    Lanarkshire
    British112830890001
    COLE, Ian Edward
    5 Meadowbank
    DG10 9LR Moffat
    Dumfries & Galloway
    Administrateur
    5 Meadowbank
    DG10 9LR Moffat
    Dumfries & Galloway
    British79462900002
    HEATH, David
    39 Polwarth Street
    Hyndland
    G12 9UE Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    39 Polwarth Street
    Hyndland
    G12 9UE Glasgow
    Lanarkshire
    British64815190001
    MILLER, John
    13 Rogerhill Gait
    Blackwood
    ML11 9XR Lanark
    Lanarkshire
    Administrateur
    13 Rogerhill Gait
    Blackwood
    ML11 9XR Lanark
    Lanarkshire
    British45748630001
    TRATHEN, David John
    12 Romilly Gardens
    Plympton
    PL7 2FF Plymouth
    Devon
    Administrateur
    12 Romilly Gardens
    Plympton
    PL7 2FF Plymouth
    Devon
    British1685120001
    TRATHEN, Michael George
    3 Woodlands Drive Woodlands Lane
    PL6 8AS Plymouth
    Administrateur
    3 Woodlands Drive Woodlands Lane
    PL6 8AS Plymouth
    British48272710003
    TRATHEN, Michael George
    Coombe House Green Lane
    PL20 6BW Yelverton
    Devon
    Administrateur
    Coombe House Green Lane
    PL20 6BW Yelverton
    Devon
    British48272710001
    WYPER, Robert Littlejohn
    70 London Road
    KA3 7DD Kilmarnock
    Ayrshire
    Administrateur
    70 London Road
    KA3 7DD Kilmarnock
    Ayrshire
    ScotlandScottish6579320001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Administrateur désigné
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    TIMEULTRA LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 28 mai 1996
    Livré le 01 juin 1996
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 01 juin 1996Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 31 mars 1992
    Livré le 10 avr. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £225,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge and all monies due or to brcome due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Unit 20 walkham business park burnington way plymouth in the county of devon t/n dn 272491 and dn 272530 and all buildings fixtures and fittings and goodwill.
    Personnes ayant droit
    • Citibank Trust Limited
    Transactions
    • 10 avr. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 sept. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 31 mars 1992
    Livré le 04 avr. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Citibank Trust Limited
    Transactions
    • 04 avr. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 sept. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0