W REALISATIONS 2023 LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéW REALISATIONS 2023 LIMITED
    Statut de la sociétéEn administration
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02667809
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de W REALISATIONS 2023 LIMITED ?

    • Vente au détail d'articles de sport, d'articles de pêche, d'articles de camping, de bateaux et de bicyclettes (47640) / Commerce de gros et de détail ; réparation de véhicules automobiles et de motocycles

    Où se situe W REALISATIONS 2023 LIMITED ?

    Adresse du siège social
    2nd Floor 110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de W REALISATIONS 2023 LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    WIGGLE LIMITED28 mai 199928 mai 1999
    EDGE TECHNOLOGIES (UK) LIMITED03 déc. 199103 déc. 1991

    Quels sont les derniers comptes de W REALISATIONS 2023 LIMITED ?

    En retardOui
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le30 sept. 2023
    Date d'échéance des prochains comptes30 juin 2024
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2022

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour W REALISATIONS 2023 LIMITED ?

    En retardOui
    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au03 déc. 2023
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation17 déc. 2023
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au03 déc. 2022
    En retardOui

    Quels sont les derniers dépôts pour W REALISATIONS 2023 LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    60 pagesAM10

    Avis de prolongation de la période de l'administration

    3 pagesAM19

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    57 pagesAM10

    Certificat de changement de nom

    Company name changed wiggle LIMITED\certificate issued on 04/04/24
    3 pagesCERTNM
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Avis de changement de nom"

    2 pagesCONNOT

    Résultat de la réunion des créanciers

    5 pagesAM07

    Déclaration des affaires avec le formulaire AM02SOA

    19 pagesAM02

    Déclaration de la proposition de l'administrateur

    51 pagesAM03

    Déclaration de la proposition de l'administrateur

    51 pagesAM03

    Changement d'adresse du siège social de , Suite 310 Third Floor N E Wing 1000 Lakeside, Portsmouth, PO6 3EN à 2nd Floor 110 Cannon Street London EC4N 6EU le 02 nov. 2023

    2 pagesAD01

    Nomination d'un administrateur

    3 pagesAM01

    Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 30 sept. 2022

    25 pagesAA

    legacy

    40 pagesPARENT_ACC

    legacy

    3 pagesGUARANTEE2

    legacy

    1 pagesAGREEMENT2

    Nomination de Mr William Dalton Randle en tant qu'administrateur le 16 mai 2023

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Adrian John Bruce en tant que directeur le 16 mai 2023

    1 pagesTM01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Huw David Crwys-Williams le 01 juin 2022

    2 pagesCH01

    Déclaration de confirmation établie le 03 déc. 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Statuts

    21 pagesMA

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01

    Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 26 sept. 2021

    27 pagesAA

    legacy

    41 pagesPARENT_ACC

    legacy

    1 pagesAGREEMENT2

    legacy

    3 pagesGUARANTEE2

    Qui sont les dirigeants de W REALISATIONS 2023 LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    CRWYS-WILLIAMS, Huw David
    110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    2nd Floor
    Administrateur
    110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    2nd Floor
    EnglandBritishDirector184099610002
    RANDLE, William Dalton
    110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    2nd Floor
    Administrateur
    110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    2nd Floor
    EnglandBritishCompany Director309332180001
    BUCKLE, Nicholas James
    3 Optima Northarbour Spur
    Portsmouth
    PO6 3TU Hampshire
    Secrétaire
    3 Optima Northarbour Spur
    Portsmouth
    PO6 3TU Hampshire
    177795960001
    DALL, Christine Marie
    Elmfield
    Delling Lane
    PO18 8NR Bosham
    West Sussex
    Secrétaire
    Elmfield
    Delling Lane
    PO18 8NR Bosham
    West Sussex
    BritishDirector7540230006
    DAVID, Giles Matthew Oliver
    1000 Lakeside
    PO6 3EN Portsmouth
    Suite 310 Third Floor N E Wing
    United Kingdom
    Secrétaire
    1000 Lakeside
    PO6 3EN Portsmouth
    Suite 310 Third Floor N E Wing
    United Kingdom
    187907570001
    GALLEY, Simon John
    47 High Street
    PO1 2LU Portsmouth
    Hampshire
    Secrétaire
    47 High Street
    PO1 2LU Portsmouth
    Hampshire
    BritishDirector16929090002
    JONES, Harvey Sean
    Whitehill
    Finchdean
    PO8 0AU Waterlooville
    Hampshire
    Secrétaire
    Whitehill
    Finchdean
    PO8 0AU Waterlooville
    Hampshire
    BritishDirector101415660001
    LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Secrétaire désigné
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001510001
    BARDEN, Stefan
    1000 Lakeside
    PO6 3EN Portsmouth
    Suite 310 Third Floor N E Wing
    United Kingdom
    Administrateur
    1000 Lakeside
    PO6 3EN Portsmouth
    Suite 310 Third Floor N E Wing
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector181476310001
    BOLWELL, Paul James
    65a St. Johns Road
    Hedge End
    SO30 4DG Southampton
    Hampshire
    Administrateur
    65a St. Johns Road
    Hedge End
    SO30 4DG Southampton
    Hampshire
    United KingdomBritishCommercial Director109551230002
    BOND, Andrew James
    Northarbour Spur
    PO6 3TU Portsmouth
    3 Optima
    Hampshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Northarbour Spur
    PO6 3TU Portsmouth
    3 Optima
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector164453850001
    BRUCE, Adrian John
    1000 Lakeside
    PO6 3EN Portsmouth
    Suite 310 Third Floor N E Wing
    Administrateur
    1000 Lakeside
    PO6 3EN Portsmouth
    Suite 310 Third Floor N E Wing
    EnglandBritishDirector259111420001
    BUCKLE, Nicholas James
    3 Optima Northarbour Spur
    Portsmouth
    PO6 3TU Hampshire
    Administrateur
    3 Optima Northarbour Spur
    Portsmouth
    PO6 3TU Hampshire
    United KingdomBritishDirector177795700001
    CLEMMOW, Alexander Ross
    1000 Lakeside
    PO6 3EN Portsmouth
    Suite 310 Third Floor N E Wing
    Administrateur
    1000 Lakeside
    PO6 3EN Portsmouth
    Suite 310 Third Floor N E Wing
    EnglandBritishDirector245205600001
    COBBOLD, Humphrey Michael
    Hilgrove Road
    NW6 4TH London
    19
    Administrateur
    Hilgrove Road
    NW6 4TH London
    19
    United KingdomBritishDirector100141010001
    DALL, Mitchell
    Chapman House
    Delling Lane
    PO18 8NR Bosham
    West Sussex
    Administrateur
    Chapman House
    Delling Lane
    PO18 8NR Bosham
    West Sussex
    United KingdomBritishDirector7540240009
    DAVID, Giles Matthew Oliver
    1000 Lakeside
    PO6 3EN Portsmouth
    Suite 310 Third Floor N E Wing
    United Kingdom
    Administrateur
    1000 Lakeside
    PO6 3EN Portsmouth
    Suite 310 Third Floor N E Wing
    United Kingdom
    EnglandBritishAccountant187907210001
    DAVY, Michael Robert
    1000 Lakeside
    PO6 3EN Portsmouth
    Suite 310 Third Floor N E Wing
    Administrateur
    1000 Lakeside
    PO6 3EN Portsmouth
    Suite 310 Third Floor N E Wing
    EnglandBritishDirector132050710002
    GALLEY, Simon John
    47 High Street
    PO1 2LU Portsmouth
    Hampshire
    Administrateur
    47 High Street
    PO1 2LU Portsmouth
    Hampshire
    EnglandBritishDirector16929090002
    GRESHAM, Nicholas John
    1000 Lakeside
    PO6 3EN Portsmouth
    Suite 310 Third Floor N E Wing
    Administrateur
    1000 Lakeside
    PO6 3EN Portsmouth
    Suite 310 Third Floor N E Wing
    United KingdomBritishDirector91773790002
    JONES, Harvey Sean
    Whitehill
    Finchdean
    PO8 0AU Waterlooville
    Hampshire
    Administrateur
    Whitehill
    Finchdean
    PO8 0AU Waterlooville
    Hampshire
    EnglandBritishDirector101415660001
    KERNAN, William James
    1000 Lakeside
    PO6 3EN Portsmouth
    Suite 310 Third Floor N E Wing
    Administrateur
    1000 Lakeside
    PO6 3EN Portsmouth
    Suite 310 Third Floor N E Wing
    EnglandBritishDirector217862600001
    MCBRIDE, Brian
    1000 Lakeside
    PO6 3EN Portsmouth
    Suite 310 Third Floor N E Wing
    United Kingdom
    Administrateur
    1000 Lakeside
    PO6 3EN Portsmouth
    Suite 310 Third Floor N E Wing
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector196964660001
    MICHELL, Simon Toby
    1000 Lakeside
    PO6 3EN Portsmouth
    Suite 310 Third Floor N E Wing
    Administrateur
    1000 Lakeside
    PO6 3EN Portsmouth
    Suite 310 Third Floor N E Wing
    United KingdomBritishDirector228110920001
    PANTELI, Andreas
    3 Optima Northarbour Spur
    Portsmouth
    PO6 3TU Hampshire
    Administrateur
    3 Optima Northarbour Spur
    Portsmouth
    PO6 3TU Hampshire
    United KingdomBritishDirector109275700001
    TALBOT, Martin Richard
    Northarbour Spur
    PO6 3TU Portsmouth
    3 Optima
    Hampshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Northarbour Spur
    PO6 3TU Portsmouth
    3 Optima
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector165349260001
    LONDON LAW SERVICES LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Administrateur désigné
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001500001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur W REALISATIONS 2023 LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Ensco 503 Limited
    Suite 310 Third Floor N E Wing
    PO6 3EN Portsmouth
    1000 Lakeside
    England
    06 avr. 2016
    Suite 310 Third Floor N E Wing
    PO6 3EN Portsmouth
    1000 Lakeside
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementUnited Kingdom
    Autorité légaleEngland & Wales
    Lieu d'enregistrementUk Companies House
    Numéro d'enregistrement05772214
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    W REALISATIONS 2023 LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 07 janv. 2020
    Livré le 07 janv. 2020
    Totalement satisfaite
    Brève description
    The premises known as citadel logistics centre, citadel junction way, bilston (WV14 7BR) and held under a lease for a term of 15 years starting on 1 october 2014 and ending 30 september 2029 and made between (1) goodman citadel (jersey) limited (as landlord) and (2) the company (as tenant).
    Contient une promesse négative: Oui
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited
    Transactions
    • 07 janv. 2020Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 08 mars 2022Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 25 août 2017
    Livré le 30 août 2017
    Totalement satisfaite
    Brève description
    A trademark registered in the UK with registered number 2523535. for more details of intellectual property charged please refer to the instrument.
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited
    Transactions
    • 30 août 2017Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 08 mars 2022Satisfaction d'une charge (MR04)
    General pledge
    Créé le 20 déc. 2011
    Livré le 22 déc. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The customer pursuant to the terms of the deed pledges with full title guarantee to the security agent by way of a continuing security the documents and the goods for the discharge and payment of the customer's liabilities and the secured obligations assigns with full title guarantee to the security agent all rights and claims see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited as Security Agent
    Transactions
    • 22 déc. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 08 mars 2022Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 12 déc. 2011
    Livré le 19 déc. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any chargor and any other obligor to the chargee or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited
    Transactions
    • 19 déc. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 08 mars 2022Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 14 juil. 2006
    Livré le 26 juil. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 26 juil. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 déc. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 14 juil. 2006
    Livré le 18 juil. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the beneficiaries on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Isis Ep LLP
    Transactions
    • 18 juil. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 déc. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Mortgage debenture
    Créé le 15 juin 2000
    Livré le 06 juil. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 06 juil. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 juil. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    W REALISATIONS 2023 LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    24 oct. 2023Administration started
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Anthony John Wright
    Frp Advisory Llp 2nd Floor 110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    practitioner
    Frp Advisory Llp 2nd Floor 110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    Alastair Massey
    2nd Floor 110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    practitioner
    2nd Floor 110 Cannon Street
    EC4N 6EU London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0