SECOND HUNTER PROPERTIES LIMITED

SECOND HUNTER PROPERTIES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSECOND HUNTER PROPERTIES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02670543
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de SECOND HUNTER PROPERTIES LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe SECOND HUNTER PROPERTIES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    28 Old Church Street
    London
    SW3 5BY
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de SECOND HUNTER PROPERTIES LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    SORTMONEY PUBLIC LIMITED COMPANY12 déc. 199112 déc. 1991

    Quels sont les derniers comptes de SECOND HUNTER PROPERTIES LIMITED ?

    En retardOui
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 mars 2017
    Date d'échéance des prochains comptes31 déc. 2017
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2016

    Quels sont les derniers dépôts pour SECOND HUNTER PROPERTIES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration de confirmation établie le 12 déc. 2016 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2016

    9 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 12 déc. 2015 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital18 déc. 2015

    État du capital au 18 déc. 2015

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Richard Gwynne Smith le 01 déc. 2015

    2 pagesCH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2015

    8 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 12 déc. 2014 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital16 déc. 2014

    État du capital au 16 déc. 2014

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2014

    8 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 12 déc. 2013 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital13 déc. 2013

    État du capital au 13 déc. 2013

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2013

    7 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 12 déc. 2012 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Richard Gwynne Smith le 12 déc. 2012

    2 pagesCH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2012

    8 pagesAA

    Comptes annuels établis au 31 mars 2011

    12 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 12 déc. 2011 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    Déclaration annuelle jusqu'au 12 déc. 2010 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01

    Modification des coordonnées du secrétaire Mr Geoffrey John Griggs le 01 déc. 2010

    1 pagesCH03

    Comptes annuels établis au 31 mars 2010

    12 pagesAA

    Cessation de la nomination de Duncan Sweetland en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Qui sont les dirigeants de SECOND HUNTER PROPERTIES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    GRIGGS, Geoffrey John
    28 Old Church Street
    London
    SW3 5BY
    Secrétaire
    28 Old Church Street
    London
    SW3 5BY
    British16580510001
    SMITH, Richard Gwynne
    28 Old Church Street
    London
    SW3 5BY
    Administrateur
    28 Old Church Street
    London
    SW3 5BY
    United KingdomBritish168772030001
    DEARLING, Lynne Joyce
    55 Huntingdon Road
    N2 9DX London
    Secrétaire
    55 Huntingdon Road
    N2 9DX London
    Welsh60000900001
    HOPKINS, Antony John
    Broomleaf Cottage Church Lane
    Ewshot
    GU10 5BD Farnham
    Surrey
    Secrétaire
    Broomleaf Cottage Church Lane
    Ewshot
    GU10 5BD Farnham
    Surrey
    British33046620004
    SMYTH, Michael Anthony
    8 Regent Square
    WC1H 8HZ London
    Secrétaire
    8 Regent Square
    WC1H 8HZ London
    British4337440001
    SWEETLAND, Duncan Barrington John
    Periwinkle Cottage
    Perry Hill, Worplesdon
    GU3 3RG Guildford
    Surrey
    Secrétaire
    Periwinkle Cottage
    Perry Hill, Worplesdon
    GU3 3RG Guildford
    Surrey
    British46467820005
    WILKES, Rupert Thomas James
    4 The Crescent
    PE13 1EH Wisbech
    Cambridgeshire
    Secrétaire
    4 The Crescent
    PE13 1EH Wisbech
    Cambridgeshire
    British71363620004
    WILSON, Nigel John Cadbury
    The Manor
    SN6 7RX Hannington Wick
    Wiltshire
    Secrétaire
    The Manor
    SN6 7RX Hannington Wick
    Wiltshire
    British11107640001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secrétaire désigné
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    EVANS, Keith
    3 Dunstable Mews
    W1 London
    Administrateur
    3 Dunstable Mews
    W1 London
    British77410310002
    HAWKINS, Christopher James
    20 Northweald Lane
    KT2 5GW Kingston Upon Thames
    Surrey
    Administrateur
    20 Northweald Lane
    KT2 5GW Kingston Upon Thames
    Surrey
    British50135940001
    HOPKINS, Antony John
    Broomleaf Cottage Church Lane
    Ewshot
    GU10 5BD Farnham
    Surrey
    Administrateur
    Broomleaf Cottage Church Lane
    Ewshot
    GU10 5BD Farnham
    Surrey
    British33046620004
    ONYETT, Robert Paul
    66 Mantilla Road
    SW17 8DT London
    Administrateur
    66 Mantilla Road
    SW17 8DT London
    British38506620001
    SMYTH, Michael Anthony
    8 Regent Square
    WC1H 8HZ London
    Administrateur
    8 Regent Square
    WC1H 8HZ London
    EnglandBritish4337440001
    WEBB, Maurice Clifford
    32b Argyle Street
    WC1H 8EN London
    Administrateur
    32b Argyle Street
    WC1H 8EN London
    British2664040002
    WHITAKER, James Herbert Ingham, Sir
    Garden House
    Babworth
    DN22 8EW Retford
    Nottinghamshire
    Administrateur
    Garden House
    Babworth
    DN22 8EW Retford
    Nottinghamshire
    British15213710002
    WILKES, Rupert Thomas James
    4 The Crescent
    PE13 1EH Wisbech
    Cambridgeshire
    Administrateur
    4 The Crescent
    PE13 1EH Wisbech
    Cambridgeshire
    United KingdomBritish71363620004
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Administrateur désigné
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur SECOND HUNTER PROPERTIES LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Old Church Street
    SW3 5BY London
    28
    England
    01 déc. 2016
    Old Church Street
    SW3 5BY London
    28
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCompanies Act
    Lieu d'enregistrementUnited Kingdom
    Numéro d'enregistrement02570517
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    SECOND HUNTER PROPERTIES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Assignment of rental income
    Créé le 26 oct. 1998
    Livré le 06 nov. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All rights,title,benefit and interest in to all rent or other sums of money received from any tenant of the properties listed in schedule. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The British Linen Bank Limited
    Transactions
    • 06 nov. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 oct. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Account charge
    Créé le 26 oct. 1998
    Livré le 06 nov. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the banking documents and in whatever name or style or on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The charge account and the secured amounts and all ebtitlements rights to repaymnet and other right and benefits relating thereto the accounts being hobs account no 1 account no 01559895,rectory road account no 00698809,albany row account no 00698702,benhill road account no 00698752,coverdale road account no 00387717,hermitage court account no 00920273 and elizabeth court account no 00911406 all with the royal bank of scotland.
    Personnes ayant droit
    • The British Linen Bank Limited
    Transactions
    • 06 nov. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 oct. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 26 oct. 1998
    Livré le 06 nov. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    85 rectory road little thurrock grays t/n EX214089 essex,4 and 5 albany row t/n NGL698322 and 12 the causeway NGL698323 and other properties please refer to form 395 for full details. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The British Linen Bank Limited
    Transactions
    • 06 nov. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 oct. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 26 oct. 1998
    Livré le 06 nov. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The British Linen Bank Limited
    Transactions
    • 06 nov. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 oct. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 19 sept. 1995
    Livré le 21 sept. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 21 sept. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 nov. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0