PEPSI-COLA EAST AFRICA LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | PEPSI-COLA EAST AFRICA LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 02672644 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe PEPSI-COLA EAST AFRICA LIMITED ?
| Adresse du siège social | Building 4 Chiswick Park 566 Chiswick High Road W4 5YE London |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de PEPSI-COLA EAST AFRICA LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2012 |
Quel est le statut du dernier bilan annuel pour PEPSI-COLA EAST AFRICA LIMITED ?
| Bilan annuel |
|
|---|
Quels sont les derniers dépôts pour PEPSI-COLA EAST AFRICA LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Nomination de Claire Ellen Stone en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de John Sigalos en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 4 pages | DS01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 02 janv. 2014 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2012 | 5 pages | AA | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de * 63 Kew Rd Richmond Surrey TW9 2QL* le 06 févr. 2013 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 02 janv. 2013 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2011 | 5 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Mr John L Sigalos en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Joanne Kerry Averiss le 26 avr. 2012 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Andrew John Macleod le 27 avr. 2012 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Mr Andrew John Macleod le 27 avr. 2012 | 1 pages | CH03 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 02 janv. 2012 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2010 | 5 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 02 janv. 2011 avec liste complète des actionnaires | 14 pages | AR01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2009 | 5 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 02 janv. 2010 avec liste complète des actionnaires | 15 pages | AR01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2008 | 4 pages | AA | ||||||||||
legacy | 8 pages | 363a | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2007 | 4 pages | AA | ||||||||||
legacy | 1 pages | 288b | ||||||||||
legacy | 4 pages | 288a | ||||||||||
legacy | 5 pages | 363a | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de PEPSI-COLA EAST AFRICA LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACLEOD, Andrew John | Secrétaire | Chiswick Park 566 Chiswick High Road W4 5YE London Building 4 United Kingdom | British | 62169550002 | ||||||
| AVERISS, Joanne Kerry | Administrateur | Chiswick Park 566 Chiswick High Road W4 5YE London Building 4 United Kingdom | England | British | 57057370001 | |||||
| MACLEOD, Andrew John | Administrateur | Chiswick Park 566 Chiswick High Road W4 5YE London Building 4 United Kingdom | United Kingdom | British | 62169550002 | |||||
| STONE, Claire Ellen | Administrateur | Chiswick Park 566 Chiswick High Road W4 5YE London Building 4 | England | British | 111950160001 | |||||
| EMMONS, Steven Luther | Secrétaire | 3 Ashley Drive KT12 1JL Walton On Thames Surrey | Us Citizen | 34533860001 | ||||||
| MCFADDEN, Douglas James | Secrétaire | 2 Spring Road Greenwich Connecticut 06830 Usa | Canadian | 30329230002 | ||||||
| SISEC LIMITED | Secrétaire désigné | 21 Holborn Viaduct EC1A 2DY London | 900001770001 | |||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Secrétaire désigné | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
| ABRAMS, Daniel | Administrateur | 4 Montrose Court Finchley Road NW11 6AG London | British | 900840002 | ||||||
| AHMED, Anwar Yaseen | Administrateur | 2 St Johns Road Tackley OX5 3AP Kidlington Oxfordshire | United Kingdom | British | 96045380002 | |||||
| ASHBY, Timothy John | Administrateur | 63 St Marks Road RG9 1LP Henley On Thames Oxfordshire | British | 38701440004 | ||||||
| BOWTELL, Robert | Administrateur | 26 Faraday Road SW19 8PD London | British | 52105020001 | ||||||
| BRADLEY, Adrian Paul | Administrateur | 19 Laitwood Road Balham SW12 9QN London | British | 25544580001 | ||||||
| EMMONS, Steven Luther | Administrateur | 3 Ashley Drive KT12 1JL Walton On Thames Surrey | Us Citizen | 34533860001 | ||||||
| EVANS, Richard David | Administrateur | Tate Close Kitisuru C/O P.O.Box 30275 Nairobi Kenya | British | 42110750001 | ||||||
| GREENLEES, Lesley Alexander | Administrateur | Cliff House Kingsland Way SG7 5QA Ashwell Hertfordshire | British | 92290170002 | ||||||
| HOWARD, Robert | Administrateur | 7 Lenham Close RG41 1HR Wokingham Berkshire | British | 108344890001 | ||||||
| KANKIWALA, Nishpank Rameshbabu | Administrateur | 20 Redwood Drive SL5 0LW Ascot Berkshire | British | 70872940001 | ||||||
| LINWOOD, Neil Anthony | Administrateur | Lonrho House 7th Floor Standard Road Nairobi Kenya | British | 34533850001 | ||||||
| MCFADDEN, Douglas James | Administrateur | 2 Spring Road Greenwich Connecticut 06830 Usa | Canadian | 30329230002 | ||||||
| NEWELL, Kenneth James Alexander | Administrateur | 19 Lower Road Fetcham KT22 9EL Leatherhead Surrey | British | 25544570001 | ||||||
| O'SHEA, William James | Administrateur | 1 Haddon Close Rosslyn Park KT13 9ND Weybridge Surrey | British | 66415540001 | ||||||
| PRESCOTT BRANN, Landen Robert | Administrateur | 54 Norcutt Road TW2 6SR Twickenham Middlesex | United Kingdom | British | 69817020002 | |||||
| PRIOR, Anthony Gordon | Administrateur | P O Box 30275 Lonrho House 7th Floor Nairobi Kenya | British | 63853800001 | ||||||
| SIGALOS, John L | Administrateur | Chiswick Park 566 Chiswick High Road W4 5YE London Building 4 United Kingdom | United Kingdom | American | 170690380001 | |||||
| WALKER, Robert Malcolm | Administrateur | 16 Ladbroke Square W11 3NA London | England | British | 58674570001 | |||||
| WALTON, Simon Robert Macfarlane | Administrateur | 1 Hurstwood SL5 9SP South Ascott | British | 76631070003 | ||||||
| INSTANT COMPANIES LIMITED | Administrateur désigné | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 | |||||||
| LOVITING LIMITED | Administrateur désigné | 21 Holborn Viaduct EC1A 2DY London | 900001760001 | |||||||
| SERJEANTS' INN NOMINEES LIMITED | Administrateur désigné | 21 Holborn Viaduct EC1A 2DY London | 900001750001 |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0